SECURITY DESIGN ASSOCIATES (1979) LIMITED
Panoramica
Nome della società | SECURITY DESIGN ASSOCIATES (1979) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | SC069292 |
Giurisdizione | Scozia |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SECURITY DESIGN ASSOCIATES (1979) LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova SECURITY DESIGN ASSOCIATES (1979) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 272 Bath Street G2 4JR Glasgow Scotland |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di SECURITY DESIGN ASSOCIATES (1979) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 nov 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per SECURITY DESIGN ASSOCIATES (1979) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2019 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Stato del capitale al 08 lug 2020
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 feb 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Michael Bedford come amministratore in data 06 gen 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Amanda Louise Larnder come amministratore in data 06 gen 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Amanda Louise Larnder il 01 gen 2020 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mrs Claire Susan Stewart il 01 gen 2020 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2018 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Eversheds Llp 3-5 Melville Street Edinburgh EH3 7PE a 272 Bath Street Glasgow G2 4JR in data 02 mag 2019 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Amanda Louise Larnder come amministratore in data 18 apr 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon Beswick come amministratore in data 18 apr 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Gerald Goodwin come amministratore in data 18 apr 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Claire Susan Stewart come segretario in data 04 mar 2019 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon Beswick come segretario in data 04 mar 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 feb 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Simon Beswick come amministratore in data 30 nov 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Simon Beswick come segretario in data 30 nov 2018 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael James Stilwell come amministratore in data 30 nov 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SECURITY DESIGN ASSOCIATES (1979) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEWART, Claire Susan | Segretario | 3-4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield Synectics House England | 255934220001 | |||||||
BEDFORD, David Michael | Amministratore | 3-4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield Synectics House England | England | British | Finance Director | 302295360001 | ||||
BESWICK, Simon | Segretario | 3-4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield Synectics House England | 253074600001 | |||||||
BRIERLEY, Richard Paul | Segretario | c/o Eversheds Llp Melville Street EH3 7PE Edinburgh 3-5 | 209316370001 | |||||||
GERAGHTY, Paul Kevin Ian | Segretario | Monkwood Cottage Whitakers Way IG10 1SQ Loughton Essex | British | Finance Director | 86029660001 | |||||
HISCOCK, Bruce Edward Heath | Segretario | 2 Webbs Cottages The Green RG29 1HF North Warnborough Hampshire | British | Finance Director | 74922870001 | |||||
POULTNEY, Nigel Charles | Segretario | 4 Holt Road B80 7NX Studley Warwickshire | British | Accountant | 8488600002 | |||||
STILWELL, Michael James | Segretario | c/o Eversheds Llp Melville Street EH3 7PE Edinburgh 3-5 | 245078530001 | |||||||
WESTCOTT, Angela | Segretario | 5 Woodfield Drive SL6 4NX Maidenhead Berkshire | British | 394110001 | ||||||
BESWICK, Simon | Amministratore | 3-4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield Synectics House England | United Kingdom | British | Finance Director | 133770010001 | ||||
BRIERLEY, Richard Paul | Amministratore | c/o Eversheds Llp Melville Street EH3 7PE Edinburgh 3-5 | United Kingdom | British | Company Secretary | 209175910001 | ||||
CHITTENDEN, Keith Alan | Amministratore | Red Lion House Church End Stebbing CM6 3SW Dunmow Essex | British | Company Director | 9117860001 | |||||
GERAGHTY, Paul Kevin Ian | Amministratore | Monkwood Cottage Whitakers Way IG10 1SQ Loughton Essex | United Kingdom | British | Finance Director | 86029660001 | ||||
GOODWIN, Mark Gerald | Amministratore | c/o Eversheds Llp Melville Street EH3 7PE Edinburgh 3-5 | England | British | Accountant | 233845210001 | ||||
HISCOCK, Bruce Edward Heath | Amministratore | 2 Webbs Cottages The Green RG29 1HF North Warnborough Hampshire | United Kingdom | British | Finance Director | 74922870001 | ||||
KIRTLAND, John Philip | Amministratore | 4 Kingfisher House Dedmere Road SL7 1PG Marlow Buckinghamshire | England | British | Managing Director | 86087080001 | ||||
LARNDER, Amanda Louise | Amministratore | 3-4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield Synectics House England | England | British | Head Of Finance | 257818550001 | ||||
MOIR, William John Wallace | Amministratore | Shrublands Lockhampton Hill GL53 9QJ Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | Engineer | 394130001 | ||||
POULTNEY, Nigel Charles | Amministratore | 4 Holt Road B80 7NX Studley Warwickshire | England | British | Accountant | 8488600002 | ||||
ROGERS, Victor Joseph | Amministratore | 3 The Green Letchmore Heath WD2 8ER Watford Hertfordshire | British | Technical Director | 394140001 | |||||
SHEPHERD, John, Mr. | Amministratore | 3-5 Melville Street EH3 7PE Edinburgh C/O Evershields Llp | United Kingdom | British | Director | 151588320001 | ||||
SINGLETON, Russell Craig | Amministratore | 417 Whirlowdale Road S11 9NG Sheffield South Yorkshire | England | British | Director | 3492940001 | ||||
SMITH, John Ernest | Amministratore | 10 Bearswood End HP9 2NR Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | Ca | 1246220002 | ||||
STILWELL, Michael James | Amministratore | c/o Eversheds Llp Melville Street EH3 7PE Edinburgh 3-5 Scotland | England | British | Accountant | 194783340001 | ||||
WESTCOTT, Angela | Amministratore | 5 Woodfield Drive SL6 4NX Maidenhead Berkshire | British | Teacher | 394110001 | |||||
WESTCOTT, Robert William | Amministratore | 5 Woodfield Drive SL6 4NX Maidenhead Berkshire | British | Engineer | 394120001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SECURITY DESIGN ASSOCIATES (1979) LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protec Plc | 06 apr 2016 | 88 Birmingham Road B80 7AS Studley Studley Point England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
SECURITY DESIGN ASSOCIATES (1979) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Floating charge | Creato il 17 feb 2003 Consegnato il 25 feb 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge over cash deposit | Creato il 26 mar 2002 Consegnato il 03 apr 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due in terms of facility letter | |
Brevi particolari The account (denominated in whatever currency) of the company with the bank of scotland treasury services PLC at 155 bishopsgate, london designated managers obligations o/a security design associates (1979) limited as the same may be replaced, redesignated, renumbered or rearranged from time to time. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Floating charge | Creato il 12 mar 2001 Consegnato il 15 mar 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Floating charge | Creato il 12 mar 2001 Consegnato il 15 mar 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 10 dic 1996 Consegnato il 27 dic 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £7,875 | |
Brevi particolari The rent deposit account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Floating charge | Creato il 12 set 1990 Consegnato il 01 ott 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Letter of charge | Creato il 06 gen 1986 Consegnato il 13 gen 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari All moneys standing at credit with the bank in name of the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0