KILRON SEAFOODS LIMITED

KILRON SEAFOODS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKILRON SEAFOODS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC069667
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KILRON SEAFOODS LIMITED?

    • Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi (10200) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova KILRON SEAFOODS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di KILRON SEAFOODS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per KILRON SEAFOODS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Verbale della riunione finale di liquidazione volontaria

    3 pagine4.26(Scot)

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2012 al 30 set 2012

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Stephen Paul Leadbeater come amministratore in data 31 mar 2013

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 3 Harbour Road Fraserburgh Aberdeenshire AB43 9TB in data 22 gen 2013

    2 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 11 gen 2013

    LRESSP

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    4 pagineMG03s

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    11 pagineAA

    Nomina di Mr Hamish Drummond Forbes come amministratore in data 18 dic 2012

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Christopher Paul Britton come amministratore in data 18 dic 2012

    1 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    8 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Approval of various tabled restructuring documents, directors are authorised to execute & deliver said docs, directors to avoid conflict of interest 20/09/2012
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 15 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 set 2012

    Stato del capitale al 19 set 2012

    • Capitale: GBP 150,000
    SH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Approval of various docs, auth of directors & sec to execute & deliver documents, directors conflict of interest 11/06/2012
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 15 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Wilkin Chapman Company Secretarial Services Limited il 15 set 2010

    2 pagineCH04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    5 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine225

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 27 set 2008

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di KILRON SEAFOODS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Town Hall Square
    PO BOX 16
    DN31 1HE Grimsby
    New Oxford House
    North East Lincolnshire
    Segretario
    Town Hall Square
    PO BOX 16
    DN31 1HE Grimsby
    New Oxford House
    North East Lincolnshire
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione02249348
    75197930001
    FORBES, Hamish Drummond
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    Amministratore
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    EnglandBritishChartered Accountant66295550001
    PARKER, Michael
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    Segretario
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    British2785890001
    RUFFELL WARD, Brian
    Tudor Garth 18a Stallingborough Road
    Healing
    DN41 7QN Grimsby
    North East Lincolnshire
    Segretario
    Tudor Garth 18a Stallingborough Road
    Healing
    DN41 7QN Grimsby
    North East Lincolnshire
    British72694900001
    WILSON, Andrew George Richard
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    Segretario
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    British47433990002
    WRIGHT, James Leonard
    32 Devonshire Avenue
    DN32 0BW Grimsby
    N.E. Lincolnshire
    Segretario
    32 Devonshire Avenue
    DN32 0BW Grimsby
    N.E. Lincolnshire
    British714180001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Segretario
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    38565160001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Segretario
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    38565160001
    BRITTON, Christopher Paul
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    Amministratore
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector127835580001
    CANE, James Robert
    Chapel House
    Brigg Road
    LN7 6PQ South Kelsey
    Lincolnshire
    Amministratore
    Chapel House
    Brigg Road
    LN7 6PQ South Kelsey
    Lincolnshire
    United KingdomBritishCompany Director104635350001
    FLEAR, Frank Alan
    93 High Street
    Waltham
    DN37 0PN Grimsby
    North East Lincolnshire
    Amministratore
    93 High Street
    Waltham
    DN37 0PN Grimsby
    North East Lincolnshire
    BritishCompany Director2785880001
    GRIFFITHS, Wynne Philip Morgan
    Hawerby Hall
    DN36 5PX Hawerby Cum Beesby
    Lincolnshire
    Amministratore
    Hawerby Hall
    DN36 5PX Hawerby Cum Beesby
    Lincolnshire
    United KingdomBritishCompany Director58713750002
    HARKJAER, Per
    Oakridge House
    6 Montrose Gardens Oxshott
    KT22 0UU Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Oakridge House
    6 Montrose Gardens Oxshott
    KT22 0UU Leatherhead
    Surrey
    EnglandDanishDirector127032620001
    LEADBEATER, Stephen Paul
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    Amministratore
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    EnglandBritishDirector84487230001
    PARKER, Michael
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    Amministratore
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    United KingdomBritishCompany Director2785890001
    RUFFELL WARD, Brian
    Tudor Garth 18a Stallingborough Road
    Healing
    DN41 7QN Grimsby
    North East Lincolnshire
    Amministratore
    Tudor Garth 18a Stallingborough Road
    Healing
    DN41 7QN Grimsby
    North East Lincolnshire
    BritishCompany Director72694900001
    SIM, James Ralph
    17 Strichen Road
    AB43 9SA Fraserburgh
    Aberdeenshire
    Amministratore
    17 Strichen Road
    AB43 9SA Fraserburgh
    Aberdeenshire
    BritishCompany Director178260001
    SIM, John Buchan
    23 Strichen Court
    AB43 9SZ Fraserburgh
    Aberdeenshire
    Amministratore
    23 Strichen Court
    AB43 9SZ Fraserburgh
    Aberdeenshire
    BritishCompany Director178270002
    THOMAS, Andrew George
    14 Mount View
    Woodgates Lane
    HU14 3JG North Ferriby
    East Yorkshire
    Amministratore
    14 Mount View
    Woodgates Lane
    HU14 3JG North Ferriby
    East Yorkshire
    BritishCompany Director40002910008
    WILSON, Andrew George Richard
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    Amministratore
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    BritishFinance Director47433990002

    KILRON SEAFOODS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security
    Creato il 06 nov 2008
    Consegnato il 19 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Tenants interest in 2 leases of the subjects 9 & 23, reclaimed ground, harbour road, fraserburgh ABN27588.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale
    Transazioni
    • 19 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 06 nov 2008
    Consegnato il 19 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Tenants interest in the lease of the subjects on the east side of harbour road, fraserburgh ABN31395.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale
    Transazioni
    • 19 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Debenture
    Creato il 23 ott 2008
    Consegnato il 05 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale
    Transazioni
    • 05 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    Standard security
    Creato il 30 mar 2007
    Consegnato il 04 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Tenants interest under the lease of ground east side of harbour road, fraserburgh ABN31395.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale
    Transazioni
    • 04 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 30 mar 2007
    Consegnato il 04 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Tenants interest under the leases of 9 & 23 reclaimed ground, harbour road, fraserburgh ABN27588.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale
    Transazioni
    • 04 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Debenture
    Creato il 21 mar 2007
    Consegnato il 31 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed charges by way of legal mortgage all material premises, all the subsidary shares and investments and distribution rights, all other interests in any material premises, all plant machinery vehicles computers office and other equipment, all book debts - see form 410 appendix 2 for further details including floating charge over all assets.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale as Security Agent
    Transazioni
    • 31 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • 28 ott 2008
    Standard security
    Creato il 28 mar 2006
    Consegnato il 31 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under the finance documents
    Brevi particolari
    The subjects comrising the tenant's interest under the lease of ground on the east side of harbour road, fraserburgh (title number ABN31395) together with the whole buildings and erections thereon.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale
    Transazioni
    • 31 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 28 mar 2006
    Consegnato il 31 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under the finance documents
    Brevi particolari
    The subjects comprising the tenant's interest under the lease of 9 and 23 reclaimed ground, harbour road, fraserburgh (title number ABN27588) together with the whole buildings and erections thereon.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale
    Transazioni
    • 31 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Debenture
    Creato il 16 mar 2006
    Consegnato il 29 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under the finance documents
    Brevi particolari
    First legal mortgage over all material premises; first fixed and floating charges over assets.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale
    Transazioni
    • 29 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • 28 ott 2008
    Floating charge
    Creato il 12 dic 2005
    Consegnato il 20 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale
    Transazioni
    • 20 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 15 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 07 dic 2005
    Consegnato il 28 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Tenants interest under the lease of ground on east side of harbour road, fraserburgh ABN31395.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale
    Transazioni
    • 28 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 26 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 07 dic 2005
    Consegnato il 28 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Tenants interest under leases of 9 & 23 reclaimed ground, harbour road, fraserburgh ABN27588.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale
    Transazioni
    • 28 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 26 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 05 ago 2002
    Consegnato il 08 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charges over assets.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale
    Transazioni
    • 08 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 23 lug 2002
    Consegnato il 06 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Area of ground on the east side of harbour road, fraserburgh--title number ABN31395.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale
    Transazioni
    • 06 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 20 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 18 apr 2002
    Consegnato il 26 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    9 & 23 reclaimed ground, fraserburgh.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale
    Transazioni
    • 26 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 20 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 08 dic 1998
    Consegnato il 16 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Tenants interest in the minute of lease over harbour road,fraserburgh.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC as Agent and Trustee for Itself and the Secured Parties
    Transazioni
    • 16 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 20 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 08 dic 1998
    Consegnato il 16 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Tenants interest in the lease over 23 reclaimed ground & yard at 9 reclaimed ground,fraserburgh.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC as Agent and Trustee for Itself and the Secured Parties
    Transazioni
    • 16 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 20 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 25 ott 1998
    Consegnato il 09 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 09 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 07 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 29 giu 1983
    Consegnato il 07 lug 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Part of a two storey industrial development in harbour rd fraserburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 lug 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 16 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 16 lug 1982
    Consegnato il 03 ago 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 ago 1982Registrazione di un'ipoteca
    Standard security
    Creato il 11 feb 1981
    Consegnato il 20 feb 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Parish of fraserburgh harbour road, fraserburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 feb 1981Registrazione di un'ipoteca
    Bond & floating charge
    Creato il 08 lug 1980
    Consegnato il 21 lug 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The whole assets of the company.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 lug 1980Registrazione di un'ipoteca

    KILRON SEAFOODS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 dic 2013Data di scioglimento
    11 gen 2013Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Blair Carnegie Nimmo
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Praticante
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Mark Granville Firmin
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Praticante
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Notescottish-insolvency-info

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0