IAN SKELLY (WISHAW) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | IAN SKELLY (WISHAW) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC070875 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di IAN SKELLY (WISHAW) LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova IAN SKELLY (WISHAW) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | c/o WRIGHT, JOHNSTON & MACKENZIE LLP 302 St. Vincent Street G2 5RZ Glasgow Scotland |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di IAN SKELLY (WISHAW) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per IAN SKELLY (WISHAW) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 27 lug 2020
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
legacy | 49 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE1 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Matthew Bishop come amministratore in data 01 gen 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr David John Muir come amministratore in data 01 gen 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
legacy | 44 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE1 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
legacy | 49 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE1 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
legacy | 51 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 pagine | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE1 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di IAN SKELLY (WISHAW) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINCH, Mark | Segretario | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | 175736800001 | |||||||
| FINCH, Mark Charles | Amministratore | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 175612870001 | |||||
| MUIR, David John | Amministratore | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | England | British | 254017640001 | |||||
| MACNAMARA, Richard James | Segretario | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | 149304900001 | |||||||
| MAHAFFEY, Matthew Ian | Segretario | 23 St Oswalds Road Fulford YO1 4PF York North Yorkshire | British | 507940001 | ||||||
| WARD, Andrew Ian | Segretario | 6 Coniston Way LS22 6TT Wetherby West Yorkshire | British | 360770001 | ||||||
| WATSON, Deirdre Mary Alison | Segretario | 51 Park Avenue Hutton CM13 2QP Brentwood Essex | Uk | 74385360001 | ||||||
| MATHESON & CO LIMITED | Segretario | 3 Lombard Street EC3V 9AQ London | 1947590001 | |||||||
| ATKIN, John Richard | Amministratore | Baillie Gate Queens Drive LS29 9QW Ilkley West Yorkshire | British | 20102900001 | ||||||
| ATKIN, John Richard | Amministratore | Baillie Gate Queens Drive LS29 9QW Ilkley West Yorkshire | British | 20102900001 | ||||||
| BEATTIE, Craig Alan | Amministratore | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 177627900001 | |||||
| BEYNON, Peter | Amministratore | Stonehurst Elm Lane Copdock IP8 3ET Ipswich Suffolk | England | British | 38504390006 | |||||
| BISHOP, Matthew | Amministratore | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 206755450002 | |||||
| CHAMBERS, Paul Jonathan | Amministratore | 24 Constable Road Ben Rhydding LS29 8RW Ilkley West Yorkshire | British | 1188140001 | ||||||
| HEALEY, Derek John | Amministratore | 5 Tudor Court Prince Of Wales Mansions HG1 1JB Harrogate North Yorkshire | British | 46399230001 | ||||||
| HERBERT, Mark Philip | Amministratore | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | England | British | 123285980005 | |||||
| HOPE, John Alexander | Amministratore | Riverside,5 School Brae EH4 6JN Edinburgh Midlothian | British | 71318590002 | ||||||
| HOUSTON, Samuel George | Amministratore | Flat 59 Medland House 11 Branch Road E14 7JT London | British | 75730290003 | ||||||
| JONES, Alun Morton | Amministratore | Fen Walk IP12 4BG Woodbridge Fen House Suffolk United Kingdom | United Kingdom | British | 12785600004 | |||||
| MACNAMARA, Richard James | Amministratore | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 149294820002 | |||||
| O'DONNELL, Joseph Peter | Amministratore | 5 Brodie Park Avenue PA2 6JH Paisley Renfrewshire | British | 18421870001 | ||||||
| POTTS, Derek | Amministratore | 55 East Street Coggeshall CO6 1SJ Colchester Essex | United Kingdom | British | 52485510001 | |||||
| RITCHIE, John Muir | Amministratore | High House Snipe Farm Road IP13 6SL Clopton Suffolk | British | 22325820001 | ||||||
| STUART, John Morris | Amministratore | Cromdale 26 Foxglove Avenue LS8 2QR Leeds West Yorkshire | British | 507950001 | ||||||
| WATSON, Deirdre Mary Alison | Amministratore | 51 Park Avenue Hutton CM13 2QP Brentwood Essex | England | Uk | 74385360001 | |||||
| WILLIAMS, Steven Wyn | Amministratore | 199 Finchampstead Road RG40 3HE Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | 54580940001 | |||||
| WILLIAMSON, Michael Granville | Amministratore | Church Green Old Church Lane Pateley Bridge HG3 5LZ Harrogate North Yorkshire | British | 57360160001 | ||||||
| WITT, John Raymond | Amministratore | 28 Westerfield Road IP4 2YJ Ipswich Suffolk | Canadian | 51303670001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di IAN SKELLY (WISHAW) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Skelly Group Limited | 06 apr 2016 | 302 St Vincent Street G2 5RZ Glasgow C/O Wright, Johnston & Mackenzie Llp Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
IAN SKELLY (WISHAW) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Assignation in security | Creato il 17 gen 1991 Consegnato il 21 gen 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari All refunds of monies by the company by way of deposit on acquisition of motor vehicles supplied by V.A.G. and man on a consignment basis. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Letter of offset | Creato il 05 giu 1987 Consegnato il 16 giu 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due by the company and/or others | |
Brevi particolari The balances at credit of any accounts held by the bank in name of the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignation in security | Creato il 20 nov 1985 Consegnato il 25 nov 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari All monies due to the company by V.A.G. (united kingdom) LTD dated 1/6/83. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 04 nov 1985 Consegnato il 15 nov 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari All used vehicles. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 04 nov 1985 Consegnato il 15 nov 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Letter of offset | Creato il 07 ago 1985 Consegnato il 13 ago 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due by the company and others | |
Brevi particolari All sums due to the company by the governor and company of the bank of scotland on the several accounts held by the bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 01 ago 1985 Consegnato il 15 ago 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 0.58 acres at the A73 lanarkshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignation in security | Creato il 30 mar 1984 Consegnato il 05 apr 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari All monies which may from time to time be owing to the company by V.A.G. (UK) limited. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 08 dic 1982 Consegnato il 13 dic 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Garage known as beacon garage, bogside and dwellinghouse known as vondercroft, lanark. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Bond & floating charge | Creato il 27 lug 1981 Consegnato il 11 ago 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due but not exceeding £70,000 of principal | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
| Floating charge | Creato il 27 lug 1981 Consegnato il 11 ago 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari All used motor vehicles forming or which may at any time or from time to time form part of the company's stock of used motor vehicles and proceeds of any insurance policies. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
| Floating charge | Creato il 27 lug 1981 Consegnato il 11 ago 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari All monies which may from time to time be owing to the company by vag (united kingdom) limited. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Creato il 17 apr 1981 Consegnato il 24 apr 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0