SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Convertita/Chiusa |
| Forma giuridica | Convertita o chiusa |
| Numero di società | SC071516 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?
- Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi
Dove si trova SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Peregrine House Peregrine Road Westhill Business Park, Westhill AB32 6JL Aberdeenshire Scotland |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SPS-AFOS INTERNATIONAL LIMITED | 05 giu 2000 | 05 giu 2000 |
| AFOS INTERNATIONAL LIMITED | 15 ott 1992 | 15 ott 1992 |
| ABERDEEN FILTRATION AND OILFIELD SERVICES LIMITED | 21 mag 1980 | 21 mag 1980 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2018 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2019 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varie Confirmation of transfer of assets and liabilities | 1 pagine | MISC | ||||||||||
Varie Notification from overseas registry of completion of merger | 3 pagine | MISC | ||||||||||
Varie Court order re completion of cross border merger | 3 pagine | MISC | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 105 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 nov 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Varie CB01 – cross border merger notice | 142 pagine | MISC | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Ian Jack come amministratore in data 10 ago 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 nov 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 nov 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Marsh come amministratore in data 03 nov 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Simon Smoker come amministratore in data 03 nov 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ryan Alexander Kidd come amministratore in data 03 nov 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Ryan Alexander Kidd il 01 mag 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mr Simon Smoker come segretario in data 01 gen 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Pauline Droy Moore come segretario in data 31 dic 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 nov 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Pauline Droy Moore il 23 ott 2015 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian Jack il 23 ott 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 1 Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill Aberdeen, Aberdeenshire Scotland AB32 6TQ a Peregrine House Peregrine Road Westhill Business Park, Westhill Aberdeenshire Scotland AB32 6JL in data 01 mag 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Mr Ryan Alexander Kidd come amministratore in data 01 gen 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jim Andrews come amministratore in data 01 gen 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMOKER, Simon | Segretario | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 0NZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | 203967800001 | |||||||
| MARSH, David | Amministratore | Buckingham Gate RH6 0NZ Gatwick Airport Schlumberger House West Sussex United Kingdom | United Kingdom | British | 171331520001 | |||||
| SMOKER, Simon | Amministratore | Buckingham Gate RH6 0NZ Gatwick Airport Schlumberger House West Sussex United Kingdom | England | British | 134158640002 | |||||
| COWAN, Raymond Andrew William | Segretario | Hillcrest Kincairn, Blairs AB12 5YQ Aberdeen Aberdeenshire | British | 65217400001 | ||||||
| DROY MOORE, Pauline | Segretario | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 ONZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | 158497360002 | |||||||
| GORMLEY, Donald | Segretario | Manor Royal RH10 9LU Crawley Victory House West Sussex United Kingdom | British | 105532790001 | ||||||
| GRIFFIN, Thomas Eugene | Segretario | Menie House Balmedie AB23 8YE Aberdeen | Lawyer | 14300020004 | ||||||
| LEDINGHAM CHALMERS | Segretario | 1 Golden Square AB10 1HA Aberdeen | 73896680007 | |||||||
| ANDREWS, Jim | Amministratore | Manor Royal RH10 9LU Crawley Victory House West Sussex United Kingdom | United Kingdom | British | 163190540001 | |||||
| ARNOLD-GRIFFIN, Sandra Gay | Amministratore | Menie House Balmedie Aberdeen | American | 14300010002 | ||||||
| COWAN, Raymond Andrew William | Amministratore | Hillcrest Kincairn, Blairs AB12 5YQ Aberdeen Aberdeenshire | Scotland | British | 65217400001 | |||||
| ELLIS, Richard John Muir | Amministratore | Burnside Kingsford Mews AB33 8HN Alford Aberdeenshire Scotland | British | 82194530001 | ||||||
| EMSLIE, Peter Forbes | Amministratore | Tantallon Corsee Road AB31 3RS Banchory Kincardineshire | British | 24490001 | ||||||
| GIBB, William Ian Alexander | Amministratore | St Eunans Road AB34 5HH Aboyne Kinnaird Aberdeenshire | United Kingdom | British | 103544230002 | |||||
| GORMLEY, Donald | Amministratore | Manor Royal RH10 9LU Crawley Victory House West Sussex United Kingdom | Scotland | British | 105532790001 | |||||
| GRIFFIN, Thomas Eugene | Amministratore | Menie House Balmedie AB23 8YE Aberdeen | Lawyer | 14300020004 | ||||||
| HENDERSON, Jeremy Neil | Amministratore | Tillyfour House Tough AB33 8DX Alford Aberdeenshire | British | 73430001 | ||||||
| HOWLETT, Paul David | Amministratore | 234 North Deeside Road Cults AB15 9PB Aberdeen | British | 55761030001 | ||||||
| JACK, Ian | Amministratore | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 0NZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | Scotland | British | 103412640012 | |||||
| KIDD, Ryan Alexander | Amministratore | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 ONZ Gatwick Schlumberger House West Sussex United Kingdom | Scotland | British | 192568420001 | |||||
| MACKENZIE, Peter | Amministratore | Manor Royal RH10 9LU Crawley Victory House West Sussex United Kingdom | British | 114652960002 | ||||||
| WILLIAMS, Glynn Richard | Amministratore | The Old Post Office Easton SO21 1EF Winchester Hampshire | United Kingdom | British | 36481970003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialised Petroleum Services Group Limited | 06 apr 2016 | Peregrine Road Westhill Business Park, Westhill AB32 6JL Aberdeenshire Peregrine House Scotland Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Creato il 24 mag 2000 Consegnato il 01 giu 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 24 mag 2000 Consegnato il 01 giu 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 07 lug 1999 Consegnato il 14 lug 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 28 lug 1997 Consegnato il 07 ago 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari The farm and lands of leyton, belhelvie, aberdeen....... See ch microfiche for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 14 feb 1994 Consegnato il 28 feb 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari (1ST) 2 areas of ground in belhelvie, aberdeenshire being enclosure numbers 0045, 0038, 0035, 3819, 6033, 8124, 8700, 8500, 8100, 7212 & 5719 (2ND) strip of ground 12FT wide along east most boundary of (1ST) (3RD) strip of woodland dividing areas formerly numbered 1233 and 1234. but always excluding from (1ST) the accesss road running along southwest boundary. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 14 feb 1994 Consegnato il 28 feb 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 29 acres at menie house, balmedie, aberdeenshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 05 ott 1993 Consegnato il 19 ott 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 58.31 acres comprising enclosures number 1234,1235, 1237, 1238, 1239 & 1241 part of the lands and farm of hill of menie in the parish of belhelvie aberdeenshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 16 dic 1991 Consegnato il 06 gen 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito 81 | |
Brevi particolari 1.27 acres comprising the mansion house of mernie balmedie aberdeen. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Letter of agreement | Creato il 11 mar 1985 Consegnato il 19 mar 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari All sums standing or that may stand to the credit of any of the company's accounts with the bank and all sums deposited or to be deposited by the company with the bank whether denominated in sterling or otherwise and irrespective of the term of such deposits. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Bond & floating charge | Creato il 11 mar 1981 Consegnato il 11 mar 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Bond & floating charge | Creato il 10 feb 1981 Consegnato il 27 feb 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0