SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED

SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED
    Stato della societàConvertita/Chiusa
    Forma giuridicaConvertita o chiusa
    Numero di società SC071516
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?

    • Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi

    Dove si trova SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Peregrine House Peregrine Road
    Westhill Business Park, Westhill
    AB32 6JL Aberdeenshire
    Scotland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SPS-AFOS INTERNATIONAL LIMITED05 giu 200005 giu 2000
    AFOS INTERNATIONAL LIMITED15 ott 199215 ott 1992
    ABERDEEN FILTRATION AND OILFIELD SERVICES LIMITED21 mag 198021 mag 1980

    Quali sono gli ultimi bilanci di SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2018
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2019
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Varie

    Confirmation of transfer of assets and liabilities
    1 pagineMISC

    Varie

    Notification from overseas registry of completion of merger
    3 pagineMISC

    Varie

    Court order re completion of cross border merger
    3 pagineMISC

    Risoluzioni

    Resolutions
    105 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Approved draft terms of cross border merger 10/12/2018
    RES13

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 nov 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Varie

    CB01 – cross border merger notice
    142 pagineMISC

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    9 pagineAA

    Cessazione della carica di Ian Jack come amministratore in data 10 ago 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 nov 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 nov 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Mr David Marsh come amministratore in data 03 nov 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Simon Smoker come amministratore in data 03 nov 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ryan Alexander Kidd come amministratore in data 03 nov 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    16 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ryan Alexander Kidd il 01 mag 2015

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Simon Smoker come segretario in data 01 gen 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Pauline Droy Moore come segretario in data 31 dic 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 30 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 dic 2015

    Stato del capitale al 11 dic 2015

    • Capitale: GBP 250,000
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Pauline Droy Moore il 23 ott 2015

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian Jack il 23 ott 2015

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    13 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill Aberdeen, Aberdeenshire Scotland AB32 6TQ a Peregrine House Peregrine Road Westhill Business Park, Westhill Aberdeenshire Scotland AB32 6JL in data 01 mag 2015

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Ryan Alexander Kidd come amministratore in data 01 gen 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jim Andrews come amministratore in data 01 gen 2015

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SMOKER, Simon
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 0NZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    Segretario
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 0NZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    203967800001
    MARSH, David
    Buckingham Gate
    RH6 0NZ Gatwick Airport
    Schlumberger House
    West Sussex
    United Kingdom
    Amministratore
    Buckingham Gate
    RH6 0NZ Gatwick Airport
    Schlumberger House
    West Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritish171331520001
    SMOKER, Simon
    Buckingham Gate
    RH6 0NZ Gatwick Airport
    Schlumberger House
    West Sussex
    United Kingdom
    Amministratore
    Buckingham Gate
    RH6 0NZ Gatwick Airport
    Schlumberger House
    West Sussex
    United Kingdom
    EnglandBritish134158640002
    COWAN, Raymond Andrew William
    Hillcrest
    Kincairn, Blairs
    AB12 5YQ Aberdeen
    Aberdeenshire
    Segretario
    Hillcrest
    Kincairn, Blairs
    AB12 5YQ Aberdeen
    Aberdeenshire
    British65217400001
    DROY MOORE, Pauline
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 ONZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    Segretario
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 ONZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    158497360002
    GORMLEY, Donald
    Manor Royal
    RH10 9LU Crawley
    Victory House
    West Sussex
    United Kingdom
    Segretario
    Manor Royal
    RH10 9LU Crawley
    Victory House
    West Sussex
    United Kingdom
    British105532790001
    GRIFFIN, Thomas Eugene
    Menie House
    Balmedie
    AB23 8YE Aberdeen
    Segretario
    Menie House
    Balmedie
    AB23 8YE Aberdeen
    Lawyer14300020004
    LEDINGHAM CHALMERS
    1 Golden Square
    AB10 1HA Aberdeen
    Segretario
    1 Golden Square
    AB10 1HA Aberdeen
    73896680007
    ANDREWS, Jim
    Manor Royal
    RH10 9LU Crawley
    Victory House
    West Sussex
    United Kingdom
    Amministratore
    Manor Royal
    RH10 9LU Crawley
    Victory House
    West Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritish163190540001
    ARNOLD-GRIFFIN, Sandra Gay
    Menie House
    Balmedie
    Aberdeen
    Amministratore
    Menie House
    Balmedie
    Aberdeen
    American14300010002
    COWAN, Raymond Andrew William
    Hillcrest
    Kincairn, Blairs
    AB12 5YQ Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Hillcrest
    Kincairn, Blairs
    AB12 5YQ Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish65217400001
    ELLIS, Richard John Muir
    Burnside
    Kingsford Mews
    AB33 8HN Alford
    Aberdeenshire
    Scotland
    Amministratore
    Burnside
    Kingsford Mews
    AB33 8HN Alford
    Aberdeenshire
    Scotland
    British82194530001
    EMSLIE, Peter Forbes
    Tantallon Corsee Road
    AB31 3RS Banchory
    Kincardineshire
    Amministratore
    Tantallon Corsee Road
    AB31 3RS Banchory
    Kincardineshire
    British24490001
    GIBB, William Ian Alexander
    St Eunans Road
    AB34 5HH Aboyne
    Kinnaird
    Aberdeenshire
    Amministratore
    St Eunans Road
    AB34 5HH Aboyne
    Kinnaird
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish103544230002
    GORMLEY, Donald
    Manor Royal
    RH10 9LU Crawley
    Victory House
    West Sussex
    United Kingdom
    Amministratore
    Manor Royal
    RH10 9LU Crawley
    Victory House
    West Sussex
    United Kingdom
    ScotlandBritish105532790001
    GRIFFIN, Thomas Eugene
    Menie House
    Balmedie
    AB23 8YE Aberdeen
    Amministratore
    Menie House
    Balmedie
    AB23 8YE Aberdeen
    Lawyer14300020004
    HENDERSON, Jeremy Neil
    Tillyfour House
    Tough
    AB33 8DX Alford
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Tillyfour House
    Tough
    AB33 8DX Alford
    Aberdeenshire
    British73430001
    HOWLETT, Paul David
    234 North Deeside Road
    Cults
    AB15 9PB Aberdeen
    Amministratore
    234 North Deeside Road
    Cults
    AB15 9PB Aberdeen
    British55761030001
    JACK, Ian
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 0NZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    Amministratore
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 0NZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    ScotlandBritish103412640012
    KIDD, Ryan Alexander
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 ONZ Gatwick
    Schlumberger House
    West Sussex
    United Kingdom
    Amministratore
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 ONZ Gatwick
    Schlumberger House
    West Sussex
    United Kingdom
    ScotlandBritish192568420001
    MACKENZIE, Peter
    Manor Royal
    RH10 9LU Crawley
    Victory House
    West Sussex
    United Kingdom
    Amministratore
    Manor Royal
    RH10 9LU Crawley
    Victory House
    West Sussex
    United Kingdom
    British114652960002
    WILLIAMS, Glynn Richard
    The Old Post Office
    Easton
    SO21 1EF Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    The Old Post Office
    Easton
    SO21 1EF Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish36481970003

    Chi sono le persone con controllo significativo di SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Peregrine Road
    Westhill Business Park, Westhill
    AB32 6JL Aberdeenshire
    Peregrine House
    Scotland
    Scotland
    06 apr 2016
    Peregrine Road
    Westhill Business Park, Westhill
    AB32 6JL Aberdeenshire
    Peregrine House
    Scotland
    Scotland
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleUnited Kingdom (Scotland)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazioneSc204919
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 24 mag 2000
    Consegnato il 01 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee
    Transazioni
    • 01 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 07 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 24 mag 2000
    Consegnato il 01 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Qhe Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee
    Transazioni
    • 01 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 07 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 07 lug 1999
    Consegnato il 14 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 07 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 28 lug 1997
    Consegnato il 07 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The farm and lands of leyton, belhelvie, aberdeen....... See ch microfiche for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 08 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 14 feb 1994
    Consegnato il 28 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    (1ST) 2 areas of ground in belhelvie, aberdeenshire being enclosure numbers 0045, 0038, 0035, 3819, 6033, 8124, 8700, 8500, 8100, 7212 & 5719 (2ND) strip of ground 12FT wide along east most boundary of (1ST) (3RD) strip of woodland dividing areas formerly numbered 1233 and 1234. but always excluding from (1ST) the accesss road running along southwest boundary.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 28 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 08 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 14 feb 1994
    Consegnato il 28 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    29 acres at menie house, balmedie, aberdeenshire.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 28 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 08 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 05 ott 1993
    Consegnato il 19 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    58.31 acres comprising enclosures number 1234,1235, 1237, 1238, 1239 & 1241 part of the lands and farm of hill of menie in the parish of belhelvie aberdeenshire.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 19 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 feb 1994Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (419b)
    • 08 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 16 dic 1991
    Consegnato il 06 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    81
    Brevi particolari
    1.27 acres comprising the mansion house of mernie balmedie aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 06 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 08 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Letter of agreement
    Creato il 11 mar 1985
    Consegnato il 19 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All sums standing or that may stand to the credit of any of the company's accounts with the bank and all sums deposited or to be deposited by the company with the bank whether denominated in sterling or otherwise and irrespective of the term of such deposits.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 19 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 15 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 11 mar 1981
    Consegnato il 11 mar 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 mar 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 09 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 10 feb 1981
    Consegnato il 27 feb 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 feb 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0