O.I.L. ENGINEERING LIMITED
Panoramica
| Nome della società | O.I.L. ENGINEERING LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC072717 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di O.I.L. ENGINEERING LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova O.I.L. ENGINEERING LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 13 Henderson Road IV1 1SN Inverness Scotland |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di O.I.L. ENGINEERING LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| O I L (ENGINEERING) LIMITED | 16 nov 1983 | 16 nov 1983 |
| OCEAN INCHCAPE (ENGINEERING) LIMITED | 03 ott 1980 | 03 ott 1980 |
Quali sono gli ultimi bilanci di O.I.L. ENGINEERING LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per O.I.L. ENGINEERING LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Terence David Willox come amministratore in data 26 mar 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Roderick James Macgregor come amministratore in data 26 mar 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Masson come amministratore in data 26 mar 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di William Hamilton come amministratore in data 26 mar 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Geg Capital come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 mag 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 mag 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 mag 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr James Donald Macdonald il 01 set 2017 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr James Donald Macdonald il 01 set 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da In-Spec House Wellheads Drive Dyce Aberdeen AB21 7GQ a 13 Henderson Road Inverness IV1 1SN in data 21 gen 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 giu 2015 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 giu 2014 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di O.I.L. ENGINEERING LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACDONALD, James Donald | Segretario | Henderson Road IV1 1SN Inverness 13 Scotland | 173184740001 | |||||||
| MACDONALD, James Donald | Amministratore | Henderson Road IV1 1SN Inverness 13 Scotland | Scotland | British | 155685440002 | |||||
| GOLDBLATT, Michael Lee | Segretario | 4709 Folse Drive Metairie Louisiana 70006 Usa | American | 53094660001 | ||||||
| HART, Richard | Segretario | 1 Crombie Circle AB14 0XU Peterculter Aberdeenshire | American | 56160400001 | ||||||
| LABORDE, Cliffe Floyd | Segretario | 429 Walnut Street New Orleans Louisiana 70118 Usa | American | 53094340001 | ||||||
| MAIR, Alexander Bruce | Segretario | Woodburn Avenue AB15 8JQ Aberdeen 19 | British | 92844720001 | ||||||
| RICKETTS, John Anthony | Segretario | Wellyard Nyewood GU31 5JA Petersfield Hampshire | British | 826820001 | ||||||
| WALLS, Kenneth Charles | Segretario | Silverstone 12 Jubilee Road L37 2HW Formby Merseyside | British | 24310840001 | ||||||
| WILLOX, Terence David | Segretario | 56 Dawson Drive Skene AB32 6NS Westhill Aberdeenshire | British | 123197880001 | ||||||
| PAULL & WILLIAMSONS | Segretario | Union Plaza (6th Floor) 1 Union Wynd AB10 1DQ Aberdeen | 24280001 | |||||||
| RAEBURN CHRISTIE CLARK & WALLACE | Segretario | 12-16 Albyn Place AB10 1PS Aberdeen | 35622500003 | |||||||
| BARTON, Derek John | Amministratore | Woodend The Cedars RH16 1RP Haywards Heath West Sussex | British | 767710001 | ||||||
| BUCHAN, William Jamie | Amministratore | The Yews Knoll Road GU7 2EL Godalming Surrey | British | 44486250001 | ||||||
| BURGESS, John Graham | Amministratore | 4 Willow Tree Way AB31 5JQ Banchory Aberdeenshire | Banchory | British | 37612260003 | |||||
| COWIE, Julie Elizabeth | Amministratore | 5 Hartington Road AB10 6XT Aberdeen Aberdeenshire | United Kingdom | British | 111585570001 | |||||
| CURRENCE, Richard Morrison | Amministratore | 541 Audubon New Orleans Louisiana 70118 Usa | American | 10304500001 | ||||||
| DICK, Stephen Wallace | Amministratore | 5500 Durham Drive 70131 New Orleans Louisiana Usa | American | 44896530001 | ||||||
| EDWARDS, David Kendrick | Amministratore | Kirkton House Banchory Devenick AB1 5YL Aberdeen | British | 61845880002 | ||||||
| FELTER, Peter Gjedboe, Dr | Amministratore | Nouaihed Building BP5233/11 Beirut Sami El Sohl St Lebanon | British | 100602880002 | ||||||
| GIBBARD, Michael John | Amministratore | Dormer Cottage 24 Weald Way CR3 6EG Caterham Surrey | British | 7528830001 | ||||||
| GILL, Bruce William | Amministratore | 22 Norman Gray Park AB21 0ZR Blackburn Aberdeenshire | United Kingdom | British | 118503010001 | |||||
| GRAHAM, Patrick David | Amministratore | The Old Vicarage Upper Chute SP11 9EN Andover Hampshire | British | 826830001 | ||||||
| HALL, Stuart | Amministratore | Newlyn Huntly Road AB34 5HE Aboyne Aberdeenshire | British | 37727490001 | ||||||
| HAMILTON, William | Amministratore | Woodburn Avenue AB15 8JQ Aberdeen Murlingden, 8 | Scotland | British | 42252580002 | |||||
| LENTHALL, Rodney Desmonde Morgan | Amministratore | Mulberry Lodge Lodge Hill Road GU10 3RD Farnham Surrey | British | 64332640001 | ||||||
| MACGREGOR, Roderick James | Amministratore | Delny Muirs IV18 0NP Invergordon The Cherry Trees | Scotland | British | 61748240004 | |||||
| MAIR, Alexander Bruce | Amministratore | Woodburn Avenue AB15 8JQ Aberdeen 19 Aberdeenshire | Scotland | British | 92844720001 | |||||
| MASSON, David | Amministratore | 18 Charleston Circle AB12 3EY Aberdeen | United Kingdom | British | 58565940001 | |||||
| MCGEEHAN, Christopher | Amministratore | 131 Grandholm Drive Bridge Of Don AB22 8AE Aberdeen Aberdeenshire | United Kingdom | British | 118503110001 | |||||
| MCINNES, Sandy | Amministratore | Dunstaffnage Woodside Avenue PH26 3JR Grantown On Spey Morayshire | United Kingdom | British | 52989660002 | |||||
| O'MALLEY, William Charles | Amministratore | 4 Lakeway Court New Orleans Louisiana 70131 Usa | American | 41492720001 | ||||||
| PHILIP, Graham Martin | Amministratore | 13 Oaklands Avenue KT10 8HX Esher Surrey | British | 2585740001 | ||||||
| ROURKE, James Lindsay | Amministratore | Castle Airy High Street AB31 5TJ Banchory Aberdeenshire | British | 56160290002 | ||||||
| ROURKE, James Lindsay | Amministratore | 21 St Dutchac Crescent AB31 3TG Banchory Kincardineshire | British | 56160290001 | ||||||
| SORAHAN, Peter John | Amministratore | Bryn Hafod Wepre Lane Northop Hall CH7 6LD Mold Flintshire | British | 28674620001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di O.I.L. ENGINEERING LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geg Capital (Howe Moss) Limited | 06 apr 2016 | Henderson Road IV1 1SN Inverness 13 Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
O.I.L. ENGINEERING LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Floating charge | Creato il 08 mar 2010 Consegnato il 10 mar 2010 | In corso | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 24 gen 2007 Consegnato il 07 feb 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari One acre and five decimal or one tenth parts of an acre or thereby at hareness road, alterns industrial estate, aberdeen. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 19 gen 2007 Consegnato il 01 feb 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Bond & floating charge | Creato il 18 gen 2007 Consegnato il 24 gen 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 24 feb 2006 Consegnato il 03 mar 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Ground at hareness road, altens industrial estate, aberdeen. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 17 feb 2006 Consegnato il 22 feb 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 15 ago 2000 Consegnato il 16 ago 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Subjects at hareness road, altens industrial estate, aberdeen. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 18 feb 1998 Consegnato il 25 feb 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari The whole assets of the company. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0