IAN SKELLY (LIVERPOOL) LIMITED

IAN SKELLY (LIVERPOOL) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàIAN SKELLY (LIVERPOOL) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC073929
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di IAN SKELLY (LIVERPOOL) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova IAN SKELLY (LIVERPOOL) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o WRIGHT, JOHNSTON & MACKENZIE LLP
    302 St. Vincent Street
    G2 5RZ Glasgow
    Scotland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di IAN SKELLY (LIVERPOOL) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per IAN SKELLY (LIVERPOOL) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 27 lug 2020

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    legacy

    49 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT1

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Matthew Bishop come amministratore in data 01 gen 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David John Muir come amministratore in data 01 gen 2019

    2 pagineAP01

    legacy

    44 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT1

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    legacy

    49 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT1

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    legacy

    51 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineAGREEMENT1

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    Chi sono gli amministratori di IAN SKELLY (LIVERPOOL) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FINCH, Mark
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Segretario
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    175736810001
    FINCH, Mark Charles
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish175612870001
    MUIR, David John
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish254017640001
    MACNAMARA, Richard James
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Segretario
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    149304530001
    MAHAFFEY, Matthew Ian
    23 St Oswalds Road
    Fulford
    YO1 4PF York
    North Yorkshire
    Segretario
    23 St Oswalds Road
    Fulford
    YO1 4PF York
    North Yorkshire
    British507940001
    WARD, Andrew Ian
    6 Coniston Way
    LS22 6TT Wetherby
    West Yorkshire
    Segretario
    6 Coniston Way
    LS22 6TT Wetherby
    West Yorkshire
    British360770001
    WATSON, Deirdre Mary Alison
    51 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    Segretario
    51 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    Uk74385360001
    MATHESON & CO LIMITED
    3 Lombard Street
    EC3V 9AQ London
    Segretario
    3 Lombard Street
    EC3V 9AQ London
    1947590001
    ATKIN, John Richard
    Baillie Gate
    Queens Drive
    LS29 9QW Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Baillie Gate
    Queens Drive
    LS29 9QW Ilkley
    West Yorkshire
    British20102900001
    ATKIN, John Richard
    Baillie Gate
    Queens Drive
    LS29 9QW Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Baillie Gate
    Queens Drive
    LS29 9QW Ilkley
    West Yorkshire
    British20102900001
    BEATTIE, Craig Alan
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish177627900001
    BEYNON, Peter
    Stonehurst Elm Lane
    Copdock
    IP8 3ET Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    Stonehurst Elm Lane
    Copdock
    IP8 3ET Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritish38504390006
    BISHOP, Matthew
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish206755450002
    CHAMBERS, Paul Jonathan
    24 Constable Road
    Ben Rhydding
    LS29 8RW Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    24 Constable Road
    Ben Rhydding
    LS29 8RW Ilkley
    West Yorkshire
    British1188140001
    HEALEY, Derek John
    5 Tudor Court
    Prince Of Wales Mansions
    HG1 1JB Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    5 Tudor Court
    Prince Of Wales Mansions
    HG1 1JB Harrogate
    North Yorkshire
    British46399230001
    HERBERT, Mark Philip
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish123285980005
    HOPE, John Alexander
    Riverside,5 School Brae
    EH4 6JN Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    Riverside,5 School Brae
    EH4 6JN Edinburgh
    Midlothian
    British71318590002
    HOUSTON, Samuel George
    Flat 59 Medland House
    11 Branch Road
    E14 7JT London
    Amministratore
    Flat 59 Medland House
    11 Branch Road
    E14 7JT London
    British75730290003
    JONES, Alun Morton
    Fen Walk
    IP12 4BG Woodbridge
    Fen House
    Suffolk
    United Kingdom
    Amministratore
    Fen Walk
    IP12 4BG Woodbridge
    Fen House
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritish12785600004
    MACNAMARA, Richard James
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish149294820002
    O'DONNELL, Joseph Peter
    5 Brodie Park Avenue
    PA2 6JH Paisley
    Renfrewshire
    Amministratore
    5 Brodie Park Avenue
    PA2 6JH Paisley
    Renfrewshire
    British18421870001
    POTTS, Derek
    55 East Street
    Coggeshall
    CO6 1SJ Colchester
    Essex
    Amministratore
    55 East Street
    Coggeshall
    CO6 1SJ Colchester
    Essex
    United KingdomBritish52485510001
    RITCHIE, John Muir
    High House
    Snipe Farm Road
    IP13 6SL Clopton
    Suffolk
    Amministratore
    High House
    Snipe Farm Road
    IP13 6SL Clopton
    Suffolk
    British22325820001
    STUART, John Morris
    Cromdale 26 Foxglove Avenue
    LS8 2QR Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Cromdale 26 Foxglove Avenue
    LS8 2QR Leeds
    West Yorkshire
    British507950001
    WATSON, Deirdre Mary Alison
    51 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    Amministratore
    51 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    EnglandUk74385360001
    WILLIAMS, Steven Wyn
    199 Finchampstead Road
    RG40 3HE Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    199 Finchampstead Road
    RG40 3HE Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish54580940001
    WILLIAMSON, Michael Granville
    Church Green
    Old Church Lane Pateley Bridge
    HG3 5LZ Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Church Green
    Old Church Lane Pateley Bridge
    HG3 5LZ Harrogate
    North Yorkshire
    British57360160001
    WITT, John Raymond
    28 Westerfield Road
    IP4 2YJ Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    28 Westerfield Road
    IP4 2YJ Ipswich
    Suffolk
    Canadian51303670001

    Chi sono le persone con controllo significativo di IAN SKELLY (LIVERPOOL) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    302 St Vincent Street
    G2 5RZ Glasgow
    C/O Wright, Johnston & Mackenzie Llp
    Scotland
    06 apr 2016
    302 St Vincent Street
    G2 5RZ Glasgow
    C/O Wright, Johnston & Mackenzie Llp
    Scotland
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleUnited Kingdom (Scotland)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione62560
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    IAN SKELLY (LIVERPOOL) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Assignation in security
    Creato il 17 gen 1991
    Consegnato il 21 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All refunds of monies paid by the company by way of deposit of the acquisition of motor vehicles.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 21 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 26 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 18 set 1987
    Consegnato il 28 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Freehold land and buildings southwest of the junction of edge lane drive and mill lane liverpool.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker LTD
    Transazioni
    • 28 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    Letter of offset
    Creato il 05 giu 1987
    Consegnato il 16 giu 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due by the company and/or others
    Brevi particolari
    The balances at credit of any accounts held by the bank in name of the company.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 giu 1987Registrazione di un'ipoteca
    Assignation
    Creato il 20 nov 1985
    Consegnato il 25 nov 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All monies due reference supply of motor vehicles.
    Persone aventi diritto
    • Mercantile Credit Company LTD
    Transazioni
    • 25 nov 1985Registrazione di un'ipoteca
    Floating charge
    Creato il 04 nov 1985
    Consegnato il 15 nov 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Mercantile Credit Company LTD
    Transazioni
    • 15 nov 1985Registrazione di un'ipoteca
    Floating charge
    Creato il 04 nov 1985
    Consegnato il 15 nov 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All the stock of used vehicles.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Mercantile Credit Company LTD
    Transazioni
    • 15 nov 1985Registrazione di un'ipoteca
    • Ha modifiche all'ordine:
    Letter of offset
    Creato il 07 ago 1985
    Consegnato il 13 ago 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due, or to become due by the company and others to the chargee
    Brevi particolari
    All sums due to the company by the bank on the several accounts.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 ago 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 18 apr 1984
    Consegnato il 23 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Land and premises situate and known as the borat works, edge lane drive, liverpool, merseyside.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 05 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 10 nov 1981
    Consegnato il 25 nov 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The whole assets of the company.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 nov 1981Registrazione di un'ipoteca
    • Ha modifiche all'ordine:
    Assignment in security
    Creato il 10 nov 1981
    Consegnato il 17 nov 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds and Scottish Trust LTD
    Transazioni
    • 17 nov 1981Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 10 nov 1981
    Consegnato il 17 nov 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds and Scottish Trust LTD & Another
    Transazioni
    • 17 nov 1981Registrazione di un'ipoteca
    • Ha modifiche all'ordine:
    Legal charge
    Creato il 10 nov 1981
    Consegnato il 17 nov 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £440,000 & all sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds and Scottish Trust LTD
    Transazioni
    • 17 nov 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0