SEGRO (WESSEX FIELDS) LIMITED

SEGRO (WESSEX FIELDS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSEGRO (WESSEX FIELDS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC074005
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SEGRO (WESSEX FIELDS) LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova SEGRO (WESSEX FIELDS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4 Atlantic Quay
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SEGRO (WESSEX FIELDS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SLOUGH (WESSEX FIELDS) LIMITED09 nov 199909 nov 1999
    BREDERO ABERDEEN CENTRE LIMITED 07 feb 198607 feb 1986
    BREDERO (ABERDEEN CENTRE) LIMITED13 gen 198613 gen 1986
    ABERDEEN (AREA B. GEORGE STREET) DEVELOPMENT LIMITED02 mar 198102 mar 1981

    Quali sono gli ultimi bilanci di SEGRO (WESSEX FIELDS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per SEGRO (WESSEX FIELDS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Verbale della riunione finale di liquidazione volontaria

    9 pagine4.26(Scot)

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL a 4 Atlantic Quay 70 York Street Glasgow G2 8JX in data 13 dic 2016

    2 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 08 dic 2016

    LRESSP

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2015

    14 pagineAA

    Stato del capitale al 14 set 2016

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    legacy

    1 pagineSH20

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 20 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 lug 2016

    Stato del capitale al 25 lug 2016

    • Capitale: GBP 18,000,000
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Elizabeth Ann Blease il 12 lug 2010

    1 pagineCH03

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    19 pagineAA

    Nomina di Mr Simon Christian Pursey come amministratore in data 30 giu 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Ann Octavia Peters come amministratore in data 30 giu 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Richard Proctor come amministratore in data 30 giu 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Laurence Yolande Giard come amministratore in data 30 giu 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 20 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 lug 2015

    Stato del capitale al 14 lug 2015

    • Capitale: GBP 18,000,000
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Edinburgh Quay 133 Fountainbridge Edinburgh Midlothian EH3 9AG a 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL in data 09 gen 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    19 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 lug 2014

    Stato del capitale al 11 lug 2014

    • Capitale: GBP 18,000,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew John Pilsworth il 28 feb 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Gareth John Osborn il 20 gen 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Richard Proctor il 20 gen 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Gareth John Osborn il 15 nov 2013

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    22 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SEGRO (WESSEX FIELDS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BLEASE, Elizabeth Ann
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    Segretario
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    Other132060350001
    HOLLAND, Alan Michael
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    Amministratore
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    United KingdomBritishDirector167815240001
    OSBORN, Gareth John
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    258
    Amministratore
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    258
    EnglandBritishChartered Surveyor91257750004
    PETERS, Ann Octavia
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    Amministratore
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    EnglandBritishDirector199465250001
    PILSWORTH, Andrew John
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    Amministratore
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    United KingdomBritishDirector155293090003
    PURSEY, Simon Christian
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    258
    Amministratore
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    258
    United KingdomBritishDirector190915460001
    BADCOCK, Peter Colin
    53 Sandown Park
    TN2 4RH Tunbridge Wells
    Kent
    Segretario
    53 Sandown Park
    TN2 4RH Tunbridge Wells
    Kent
    British545530001
    BANERJEE, Pradip
    4 Seaton Stables
    AB2 1XS Aberdeen
    Aberdeenshire
    Segretario
    4 Seaton Stables
    AB2 1XS Aberdeen
    Aberdeenshire
    British756560001
    BLEASE, Elizaabeth Ann
    Central Buildings Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    3
    United Kingdom
    Segretario
    Central Buildings Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    3
    United Kingdom
    Other134283690001
    KERSLAKE, Susan
    8 The Common
    KT21 2ED Ashtead
    Surrey
    Segretario
    8 The Common
    KT21 2ED Ashtead
    Surrey
    British1320390001
    LYNCH, Valerie Ann
    6 Charvil House Road
    Charvil
    RG10 9RD Reading
    Berkshire
    Segretario
    6 Charvil House Road
    Charvil
    RG10 9RD Reading
    Berkshire
    British68872030002
    MAIR, Kenneth
    3 Smithy Lane
    Lower Kingswood
    KT20 6TP Tadworth
    Surrey
    Segretario
    3 Smithy Lane
    Lower Kingswood
    KT20 6TP Tadworth
    Surrey
    British545490001
    PROBERT, John Robert
    2 Compton Way Taylors Farm
    Sherfield On Loddon
    RG27 0SQ Hook
    Segretario
    2 Compton Way Taylors Farm
    Sherfield On Loddon
    RG27 0SQ Hook
    British34786610008
    RANKEN & REID SSC
    7 Albyn Place
    EH2 4NG Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    7 Albyn Place
    EH2 4NG Edinburgh
    Midlothian
    36900001
    TODS MURRAY LLP
    66 Queen Street
    EH2 4NE Edinburgh
    Segretario
    66 Queen Street
    EH2 4NE Edinburgh
    1117600001
    BADCOCK, Peter Colin
    53 Sandown Park
    TN2 4RH Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    53 Sandown Park
    TN2 4RH Tunbridge Wells
    Kent
    BritishCompany Director545530001
    BRIDGES, David Crawford
    Bath Road
    234 Bath Road
    SL1 4EE Slough
    234
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Bath Road
    234 Bath Road
    SL1 4EE Slough
    234
    Berkshire
    England
    EnglandBritishDirector94982860001
    BURMAN, Barry William
    Little Orchard 3 Winchelsey Rise
    CR2 7BP South Croydon
    Surrey
    Amministratore
    Little Orchard 3 Winchelsey Rise
    CR2 7BP South Croydon
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director50817240001
    CAREY, Roger William
    Instow
    Burtons Way
    HP8 4BP Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Instow
    Burtons Way
    HP8 4BP Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director6069370001
    CHISHOLM, Allan Donald
    49 Colcokes Road
    SM7 2EJ Banstead
    Surrey
    Amministratore
    49 Colcokes Road
    SM7 2EJ Banstead
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director545510001
    COOK, Alexander Kinnison
    10 Station Road East
    Peterculter
    AB1 0PT Aberdeen
    Amministratore
    10 Station Road East
    Peterculter
    AB1 0PT Aberdeen
    BritishCompany Director545520001
    DRUMMOND, Graham
    17 St Ronans Circle
    AB14 0NE Peterculter
    Aberdeenshire
    Amministratore
    17 St Ronans Circle
    AB14 0NE Peterculter
    Aberdeenshire
    BritishEngineer59086970001
    GIARD, Laurence Yolande
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    Amministratore
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    FranceFrenchDirector166569010001
    GULLIFORD, Andrew Stephen
    White Gables
    Perks Lane Prestwood
    HP16 0JQ Great Missenden
    Buckinghamshire
    Amministratore
    White Gables
    Perks Lane Prestwood
    HP16 0JQ Great Missenden
    Buckinghamshire
    EnglandBritishChartered Surveyor101612810001
    HEAWOOD, John Anthony Nicholas
    South View Road
    HA5 3YB Pinner
    Gateway
    Middlesex
    Amministratore
    South View Road
    HA5 3YB Pinner
    Gateway
    Middlesex
    United KingdomBritishChartered Surveyor133123780001
    HORLER, Elizabeth Anne
    9 Lionel Avenue
    HP22 6LL Wendover
    Buckinghamshire
    Amministratore
    9 Lionel Avenue
    HP22 6LL Wendover
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant118644450001
    KINGSTON, Richard David
    60 Clifton Road
    HP6 5PN Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    60 Clifton Road
    HP6 5PN Amersham
    Buckinghamshire
    BritishAccountant10789160002
    NEWBIGGING, Bruce Robert
    Quiet Waters
    Upland
    IP7 6ES Kersey
    Suffolk
    Amministratore
    Quiet Waters
    Upland
    IP7 6ES Kersey
    Suffolk
    EnglandBritishBanker151932690001
    NEWELL, Margaret Ida
    White House
    WD3 4NG Rickmansworth
    Herts
    Amministratore
    White House
    WD3 4NG Rickmansworth
    Herts
    BritishCompany Director612900001
    O'CONNOR, Kevin John
    Salisbury Place
    KT14 6SW West Byfleet
    5
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Salisbury Place
    KT14 6SW West Byfleet
    5
    Surrey
    United Kingdom
    BritishDirector134211680002
    POSTLETHWAITE, Maureen Anne
    65 London Road South
    Merstham
    RH1 3AX Redhill
    Surrey
    Amministratore
    65 London Road South
    Merstham
    RH1 3AX Redhill
    Surrey
    BritishBanker612910001
    PROCTOR, David Richard
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    258
    Amministratore
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    258
    EnglandBritishDirector172618490001
    REDDING, Philip Anthony
    Bath Road
    234 Bath Road
    SL1 4EE Slough
    234
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Bath Road
    234 Bath Road
    SL1 4EE Slough
    234
    Berkshire
    England
    EnglandBritishDirector152749640002
    SHANKAR, Siva
    Roberts Way
    Englefield Green
    TW20 9SH Egham
    Queenswood
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Roberts Way
    Englefield Green
    TW20 9SH Egham
    Queenswood
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director Uk Property132176500001
    SIMMS, Vanessa Kate
    Turbary Road
    GU51 1GH Fleet
    18
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Turbary Road
    GU51 1GH Fleet
    18
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector134181890002

    SEGRO (WESSEX FIELDS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Floating charge
    Creato il 01 set 1993
    Consegnato il 21 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 set 1993Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 25 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 21 giu 1989
    Consegnato il 03 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The lease relating to shops no's 30 and 34 schoolhill aberdeen 8 1/4 square metres part of the solum of loch street, aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • Citibank N.A.
    Transazioni
    • 03 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 29 giu 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 28 mag 1987
    Consegnato il 08 giu 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Bon accord centre aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • Citibank N.A.
    Transazioni
    • 08 giu 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 29 giu 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 30 apr 1987
    Consegnato il 07 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Citibank N.A.
    Transazioni
    • 07 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 08 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 21 mag 1986
    Consegnato il 05 giu 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The whole interest of the company in and to (a) the development agreement entered into between the city of aberdeen district council ("the council") and bredero vast goed N.V. a company incorporated under the laws of the netherlands whose chief office is situated at kromme nieuwe gracht 66, utrecht (B.V.G.) dated 2ND may 1979, (b) the first supplemental agreement entered into between the council and B.V.G. dated 24TH september and 20TH november 1979, (c) the second supplemental agreement entered into between the council and B.V.G. dated 1ST august 1984 and 7TH august 1985, (d) the linking agreement entered into between the council, B.V.G. and the wordie property company limited incorporated under the companies acts and having its registered office at 202 west george street, glasgow (wordie) dates 1ST august 1984 and 8TH january and 7TH august 1985 and (e) the agreement entered into between B.V.G. and wordie dated 1ST august 1984 and 8TH january 1985, the said whole interest of B.V.G. in said development agreement, first and second supplemental agreements, linking agreement and agreement having been assigned by B.V.G. to the company by virtue of two assignations granted by B.V.G. in favour of the company dated 9TH may 1986.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 05 giu 1986Registrazione di un'ipoteca

    SEGRO (WESSEX FIELDS) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    14 ott 2017Data di scioglimento
    08 dic 2016Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Notescottish-insolvency-info

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0