M. & S. TOILETRIES LIMITED
Panoramica
Nome della società | M. & S. TOILETRIES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | SC074577 |
Giurisdizione | Scozia |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di M. & S. TOILETRIES LIMITED?
- Commercio all'ingrosso non specializzato (46900) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Dove si trova M. & S. TOILETRIES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | First Floor, Quay 2, 139 Fountainbridge EH3 9QG Edinburgh |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di M. & S. TOILETRIES LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 gen 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per M. & S. TOILETRIES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Verbale della riunione finale di liquidazione volontaria | 3 pagine | 4.26(Scot) | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 17 Rothesay Place Edinburgh EH3 7SQ a First Floor, Quay 2, 139 Fountainbridge Edinburgh EH3 9QG in data 24 mar 2016 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 gen 2015 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Sabir Rashid Tayub il 05 giu 2015 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 feb 2015 | 14 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Kiran Tailor come amministratore in data 24 set 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2014 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 feb 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Sabir Rashid Tayub il 04 mar 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2013 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 feb 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2012 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 feb 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Mr Kiran Tailor come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Hemant Patel come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Hemant Patel come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2011 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 feb 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2010 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 feb 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Sabir Rashid Tayub il 19 feb 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2009 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di M. & S. TOILETRIES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAYUB, Sabir Rashid | Amministratore | Glaisdale Drive East NG8 4GU Bilborough Nottingham United Kingdom | England | British | Director | 53132720005 | ||||
BRODIE, John Ross | Segretario | Villa Marina, 4 Shore Road EH30 9SG South Queensferry Midlothian | British | Accountant | 91369050001 | |||||
CLARK, Archibald Ian | Segretario | 75 Caroline Terrace EH12 8QX Edinburgh Midlothian | British | 470120001 | ||||||
DALLEY, John Chapman | Segretario | Crichton Cottage Strathearn Road EH39 5BZ North Berwick East Lothian | British | 68631180003 | ||||||
DAVIES, John Richard Bridge | Segretario | Amberley 5 Primrose Hill Waste Lane CW6 0PE Kelsall Cheshire | British | 51554100001 | ||||||
MACNAB, Peter Douglas | Segretario | Rushmore 1 Medwyn Drive EH46 7HW West Linton Peeblesshire | British | 57201900001 | ||||||
MACNAB, Peter Douglas | Segretario | Rushmore 1 Medwyn Drive EH46 7HW West Linton Peeblesshire | British | 57201900001 | ||||||
MURPHY, Francis Joseph | Segretario | Oakmere Murieston Road WA15 9SU Hale Cheshire | British | 32866430003 | ||||||
PATEL, Hemant | Segretario | The Manor House 1028 Melton Road Syston LE7 2NN Leicester Leicestershire | British | Director | 104124100001 | |||||
BARCLAY, William D | Amministratore | The Den Winchburgh EH52 6PY West Lothian | British | Company Director | 35724590004 | |||||
BIRD, Colin Smith | Amministratore | Westgates 28 Queens Crescent FK1 5JL Falkirk | British | Accountant | 77595560001 | |||||
BRODIE, John Ross | Amministratore | Villa Marina, 4 Shore Road EH30 9SG South Queensferry Midlothian | Scotland | British | Accountant | 91369050001 | ||||
CRONAN, John Philip | Amministratore | 16 Rosebery Crescent EH23 4JR Gorebridge Midlothian | British | Retired | 43166440001 | |||||
DUFFY, James | Amministratore | 55 Corstorphine Hill Gardens EH12 6LB Edinburgh | British | Manufacturer'S Agent | 83567540001 | |||||
FIDLER, Brian Harvey | Amministratore | The Eighth House Vernon Avenue OX2 9AU Oxford | England | British | Company Director | 57282470001 | ||||
GREENHALGH, Gary | Amministratore | Washdyke Farm Lincoln Road NG32 3HY Fulbeck Lincolnshire | United Kingdom | British | Company Director | 1192810001 | ||||
MACNAB, Peter Douglas | Amministratore | Rushmore 1 Medwyn Drive EH46 7HW West Linton Peeblesshire | Scotland | British | Accountant | 57201900001 | ||||
MCBEATH, Donald | Amministratore | 98 Ravelston Dykes EH12 6HB Edinburgh Midlothian | British | Director | 470130001 | |||||
MCBEATH, Innes Archibald Wilson | Amministratore | 12 Polwarth Terrace EH11 1ND Edinburgh Lothian | United Kingdom | British | Company Director | 51134700001 | ||||
MCBEATH, Irene | Amministratore | 98 Ravelston Dykes EH12 6HB Edinburgh Midlothian | British | Director | 1062860001 | |||||
MCDOUGALL, Mary | Amministratore | 12 Briarcroft Place G33 1RG Glasgow | British | Accountant | 36430850002 | |||||
MCPAKE, Lawrence Joseph Doyle | Amministratore | 16 Lomond Crescent Stenhousemuir FK5 4LT Larbert Stirlingshire | British | Sales Manager | 62398480001 | |||||
MEISTER, Stefan Mario | Amministratore | Rosengartenstrasse 19 70184 Stuttgart Germany | Swiss | Company Director | 43550520003 | |||||
MOON, David | Amministratore | Morar Street ML2 0JP Wishaw 22 Lanarkshire | British | Project Manager | 106003340001 | |||||
PATEL, Hemant | Amministratore | The Manor House 1028 Melton Road Syston LE7 2NN Leicester Leicestershire | England | British | Director | 104124100001 | ||||
REVELL, Anthony William | Amministratore | 26 Ryland Road Welton LN2 3LU Lincoln | British | Company Director | 980590001 | |||||
SMALLMAN, Hollis | Amministratore | 39 Allan Park EH29 9HA Kirkliston West Lothian | Scotland | British | Retired | 106006380001 | ||||
TAILOR, Kiran | Amministratore | Rothesay Place EH3 7SQ Edinburgh 17 | England | British | Accountant | 166592020001 | ||||
TAYLOR, David Leslie | Amministratore | Woodbank Wilmslow Park SK9 2BA Wilmslow Cheshire | Gb-Eng | British | Pharmacist | 10776940001 | ||||
TEMPANY, William John | Amministratore | 19 Gleneagles Court EH47 8PG Whitburn West Lothian | Scotland | British | Sales & Marketing | 57201670001 | ||||
VIZARD, Ronald Charles, Harold | Amministratore | Fieldfare Pigeon Green, Snitterfield CV37 OLP Stratford-Upon-Avon Warwickshire | British | Chartered Accountant | 122881190001 | |||||
WALLIS, Andrew Leonard | Amministratore | The Old Rectory Church Street South Collingham NG23 7LH Newark Nottinghamshire | British | Chartered Accountant | 681750001 |
M. & S. TOILETRIES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Bond & floating charge | Creato il 28 lug 2003 Consegnato il 06 ago 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 24 feb 1998 Consegnato il 02 mar 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 3.385 acres at bankhead drive,edinburgh. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed charge | Creato il 20 feb 1998 Consegnato il 05 mar 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari All english book debts. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Floating charge | Creato il 20 feb 1998 Consegnato il 27 feb 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari The whole assets of the company. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 08 mar 1985 Consegnato il 19 mar 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Ground at bankhead drive edinburgh. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignation of life policy | Creato il 03 mar 1982 Consegnato il 16 mar 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Policy number 816552 dated 19/6/81 for £470,000 effected by the company on the life of donald mcbeath, 98 ravelston dykes, edinburgh. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 08 gen 1982 Consegnato il 15 gen 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 71 marionville road edinburgh. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Bond & floating charge | Creato il 26 giu 1981 Consegnato il 16 lug 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
M. & S. TOILETRIES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0