M. & S. TOILETRIES LIMITED

M. & S. TOILETRIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàM. & S. TOILETRIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC074577
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di M. & S. TOILETRIES LIMITED?

    • Commercio all'ingrosso non specializzato (46900) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova M. & S. TOILETRIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    First Floor, Quay 2,
    139 Fountainbridge
    EH3 9QG Edinburgh
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di M. & S. TOILETRIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per M. & S. TOILETRIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Verbale della riunione finale di liquidazione volontaria

    3 pagine4.26(Scot)

    Indirizzo della sede legale modificato da 17 Rothesay Place Edinburgh EH3 7SQ a First Floor, Quay 2, 139 Fountainbridge Edinburgh EH3 9QG in data 24 mar 2016

    2 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 03 mar 2016

    LRESSP

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 03 mar 2016

    LRESSP

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 gen 2015

    5 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Sabir Rashid Tayub il 05 giu 2015

    3 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2015

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 mag 2015

    Stato del capitale al 07 mag 2015

    • Capitale: GBP 225,000
    SH01

    Cessazione della carica di Kiran Tailor come amministratore in data 24 set 2014

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2014

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 feb 2014

    Stato del capitale al 03 feb 2014

    • Capitale: GBP 225,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Sabir Rashid Tayub il 04 mar 2013

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Nomina di Mr Kiran Tailor come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Hemant Patel come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Hemant Patel come segretario

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2010

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Sabir Rashid Tayub il 19 feb 2010

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2009

    5 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di M. & S. TOILETRIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TAYUB, Sabir Rashid
    Glaisdale Drive East
    NG8 4GU Bilborough
    Nottingham
    United Kingdom
    Amministratore
    Glaisdale Drive East
    NG8 4GU Bilborough
    Nottingham
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector53132720005
    BRODIE, John Ross
    Villa Marina, 4 Shore Road
    EH30 9SG South Queensferry
    Midlothian
    Segretario
    Villa Marina, 4 Shore Road
    EH30 9SG South Queensferry
    Midlothian
    BritishAccountant91369050001
    CLARK, Archibald Ian
    75 Caroline Terrace
    EH12 8QX Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    75 Caroline Terrace
    EH12 8QX Edinburgh
    Midlothian
    British470120001
    DALLEY, John Chapman
    Crichton Cottage
    Strathearn Road
    EH39 5BZ North Berwick
    East Lothian
    Segretario
    Crichton Cottage
    Strathearn Road
    EH39 5BZ North Berwick
    East Lothian
    British68631180003
    DAVIES, John Richard Bridge
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    Segretario
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    British51554100001
    MACNAB, Peter Douglas
    Rushmore 1 Medwyn Drive
    EH46 7HW West Linton
    Peeblesshire
    Segretario
    Rushmore 1 Medwyn Drive
    EH46 7HW West Linton
    Peeblesshire
    British57201900001
    MACNAB, Peter Douglas
    Rushmore 1 Medwyn Drive
    EH46 7HW West Linton
    Peeblesshire
    Segretario
    Rushmore 1 Medwyn Drive
    EH46 7HW West Linton
    Peeblesshire
    British57201900001
    MURPHY, Francis Joseph
    Oakmere Murieston Road
    WA15 9SU Hale
    Cheshire
    Segretario
    Oakmere Murieston Road
    WA15 9SU Hale
    Cheshire
    British32866430003
    PATEL, Hemant
    The Manor House
    1028 Melton Road Syston
    LE7 2NN Leicester
    Leicestershire
    Segretario
    The Manor House
    1028 Melton Road Syston
    LE7 2NN Leicester
    Leicestershire
    BritishDirector104124100001
    BARCLAY, William D
    The Den
    Winchburgh
    EH52 6PY West Lothian
    Amministratore
    The Den
    Winchburgh
    EH52 6PY West Lothian
    BritishCompany Director35724590004
    BIRD, Colin Smith
    Westgates
    28 Queens Crescent
    FK1 5JL Falkirk
    Amministratore
    Westgates
    28 Queens Crescent
    FK1 5JL Falkirk
    BritishAccountant77595560001
    BRODIE, John Ross
    Villa Marina, 4 Shore Road
    EH30 9SG South Queensferry
    Midlothian
    Amministratore
    Villa Marina, 4 Shore Road
    EH30 9SG South Queensferry
    Midlothian
    ScotlandBritishAccountant91369050001
    CRONAN, John Philip
    16 Rosebery Crescent
    EH23 4JR Gorebridge
    Midlothian
    Amministratore
    16 Rosebery Crescent
    EH23 4JR Gorebridge
    Midlothian
    BritishRetired43166440001
    DUFFY, James
    55 Corstorphine Hill Gardens
    EH12 6LB Edinburgh
    Amministratore
    55 Corstorphine Hill Gardens
    EH12 6LB Edinburgh
    BritishManufacturer'S Agent83567540001
    FIDLER, Brian Harvey
    The Eighth House Vernon Avenue
    OX2 9AU Oxford
    Amministratore
    The Eighth House Vernon Avenue
    OX2 9AU Oxford
    EnglandBritishCompany Director57282470001
    GREENHALGH, Gary
    Washdyke Farm
    Lincoln Road
    NG32 3HY Fulbeck
    Lincolnshire
    Amministratore
    Washdyke Farm
    Lincoln Road
    NG32 3HY Fulbeck
    Lincolnshire
    United KingdomBritishCompany Director1192810001
    MACNAB, Peter Douglas
    Rushmore 1 Medwyn Drive
    EH46 7HW West Linton
    Peeblesshire
    Amministratore
    Rushmore 1 Medwyn Drive
    EH46 7HW West Linton
    Peeblesshire
    ScotlandBritishAccountant57201900001
    MCBEATH, Donald
    98 Ravelston Dykes
    EH12 6HB Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    98 Ravelston Dykes
    EH12 6HB Edinburgh
    Midlothian
    BritishDirector470130001
    MCBEATH, Innes Archibald Wilson
    12 Polwarth Terrace
    EH11 1ND Edinburgh
    Lothian
    Amministratore
    12 Polwarth Terrace
    EH11 1ND Edinburgh
    Lothian
    United KingdomBritishCompany Director51134700001
    MCBEATH, Irene
    98 Ravelston Dykes
    EH12 6HB Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    98 Ravelston Dykes
    EH12 6HB Edinburgh
    Midlothian
    BritishDirector1062860001
    MCDOUGALL, Mary
    12 Briarcroft Place
    G33 1RG Glasgow
    Amministratore
    12 Briarcroft Place
    G33 1RG Glasgow
    BritishAccountant36430850002
    MCPAKE, Lawrence Joseph Doyle
    16 Lomond Crescent
    Stenhousemuir
    FK5 4LT Larbert
    Stirlingshire
    Amministratore
    16 Lomond Crescent
    Stenhousemuir
    FK5 4LT Larbert
    Stirlingshire
    BritishSales Manager62398480001
    MEISTER, Stefan Mario
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Amministratore
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    SwissCompany Director43550520003
    MOON, David
    Morar Street
    ML2 0JP Wishaw
    22
    Lanarkshire
    Amministratore
    Morar Street
    ML2 0JP Wishaw
    22
    Lanarkshire
    BritishProject Manager106003340001
    PATEL, Hemant
    The Manor House
    1028 Melton Road Syston
    LE7 2NN Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    The Manor House
    1028 Melton Road Syston
    LE7 2NN Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritishDirector104124100001
    REVELL, Anthony William
    26 Ryland Road
    Welton
    LN2 3LU Lincoln
    Amministratore
    26 Ryland Road
    Welton
    LN2 3LU Lincoln
    BritishCompany Director980590001
    SMALLMAN, Hollis
    39 Allan Park
    EH29 9HA Kirkliston
    West Lothian
    Amministratore
    39 Allan Park
    EH29 9HA Kirkliston
    West Lothian
    ScotlandBritishRetired106006380001
    TAILOR, Kiran
    Rothesay Place
    EH3 7SQ Edinburgh
    17
    Amministratore
    Rothesay Place
    EH3 7SQ Edinburgh
    17
    EnglandBritishAccountant166592020001
    TAYLOR, David Leslie
    Woodbank Wilmslow Park
    SK9 2BA Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    Woodbank Wilmslow Park
    SK9 2BA Wilmslow
    Cheshire
    Gb-EngBritishPharmacist10776940001
    TEMPANY, William John
    19 Gleneagles Court
    EH47 8PG Whitburn
    West Lothian
    Amministratore
    19 Gleneagles Court
    EH47 8PG Whitburn
    West Lothian
    ScotlandBritishSales & Marketing57201670001
    VIZARD, Ronald Charles, Harold
    Fieldfare
    Pigeon Green, Snitterfield
    CV37 OLP Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Fieldfare
    Pigeon Green, Snitterfield
    CV37 OLP Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    BritishChartered Accountant122881190001
    WALLIS, Andrew Leonard
    The Old Rectory
    Church Street South Collingham
    NG23 7LH Newark
    Nottinghamshire
    Amministratore
    The Old Rectory
    Church Street South Collingham
    NG23 7LH Newark
    Nottinghamshire
    BritishChartered Accountant681750001

    M. & S. TOILETRIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Bond & floating charge
    Creato il 28 lug 2003
    Consegnato il 06 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 06 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 13 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 24 feb 1998
    Consegnato il 02 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    3.385 acres at bankhead drive,edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 10 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Fixed charge
    Creato il 20 feb 1998
    Consegnato il 05 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All english book debts.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 31 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 20 feb 1998
    Consegnato il 27 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The whole assets of the company.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 31 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 08 mar 1985
    Consegnato il 19 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Ground at bankhead drive edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 19 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 26 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Assignation of life policy
    Creato il 03 mar 1982
    Consegnato il 16 mar 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Policy number 816552 dated 19/6/81 for £470,000 effected by the company on the life of donald mcbeath, 98 ravelston dykes, edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 mar 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 26 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 08 gen 1982
    Consegnato il 15 gen 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    71 marionville road edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 gen 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 26 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 26 giu 1981
    Consegnato il 16 lug 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 lug 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 26 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    M. & S. TOILETRIES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    03 mar 2016Inizio della liquidazione
    30 giu 2017Data prevista di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Notescottish-insolvency-info

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0