GILFIN PROPERTY HOLDINGS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | GILFIN PROPERTY HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC077200 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GILFIN PROPERTY HOLDINGS LIMITED?
- Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari
- Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari
Dove si trova GILFIN PROPERTY HOLDINGS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 4 Atlantic Quay 70 York Street G2 8JX Glasgow |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di GILFIN PROPERTY HOLDINGS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| GILFIN PROPERTY HOLDINGS PLC | 18 gen 1982 | 18 gen 1982 |
Quali sono gli ultimi bilanci di GILFIN PROPERTY HOLDINGS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per GILFIN PROPERTY HOLDINGS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Conto finale prima della dissoluzione in MVL (conto finale allegato) | 18 pagine | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Cessazione della carica di William Alexander Heaney come segretario in data 24 nov 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Rupert Peter Wallman come amministratore in data 04 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nicholas John Vetch come amministratore in data 04 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stephen John East come amministratore in data 04 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jonathan Ottley Short come amministratore in data 04 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione di Rupert Peter Wallman come persona con controllo significativo il 04 ott 2019 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Cessazione di Stephen John East come persona con controllo significativo il 04 ott 2019 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Cessazione di Nicholas John Vetch come persona con controllo significativo il 04 ott 2019 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da No 2 Lochrin Square 96 Fountainbridge Edinburgh EH3 9QA a 4 Atlantic Quay 70 York Street Glasgow G2 8JX in data 04 mar 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Modifica dei dettagli di Mr Nicholas John Vetch come persona con controllo significativo il 25 feb 2019 | 2 pagine | PSC04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 ago 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2017 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 ago 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2016 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 ago 2016 con aggiornamenti | 7 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2015 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Jonathan Ottley Short come amministratore in data 11 apr 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Steven Robert Faber come amministratore in data 11 apr 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Rupert Peter Wallman come amministratore in data 16 dic 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 ago 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2014 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 ago 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di GILFIN PROPERTY HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILCHRIST, Sheena Mary | Segretario | Drum Lodge Drummochy Road, Lower Largo KY8 6BZ Leven Fife | British | 290930001 | ||||||
| HEANEY, William Alexander | Segretario | Clematis Cottage 14 Deanway HP8 4JH Chalfont St Giles Buckinghamshire | British | 2538150001 | ||||||
| EAST, Stephen John | Amministratore | 70 York Street G2 8JX Glasgow 4 Atlantic Quay | England | British | 108586450003 | |||||
| FABER, Steven Robert | Amministratore | No 2 Lochrin Square 96 Fountainbridge EH3 9QA Edinburgh | England | British | 102825930002 | |||||
| GILCHRIST, Iain Johnston | Amministratore | Drum Lodge Drummochy Road KY8 6BZ Lower Largo Fife | Scotland | British | 62780001 | |||||
| GILCHRIST, Julie Ann | Amministratore | Ground Floor 143 Danes Drive, Scotstoun G6 Glasgow | British | 61174950004 | ||||||
| GILCHRIST, Sheena Mary | Amministratore | Drum Lodge Drummochy Road, Lower Largo KY8 6BZ Leven Fife | British | 290930001 | ||||||
| GREGORY, Nicholas John | Amministratore | Rands Rands Road, High Roding CM6 1NH Dunmow Essex | England | British | 84754890001 | |||||
| POCOCK, Clare Helen | Amministratore | The Old Mill Milton Of Buchanan, Drymen G63 0JE Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 65214460001 | |||||
| RILEY, Michael Edward | Amministratore | 34 Thornton Avenue Warsash SO31 9FJ Southampton The Ferry House United Kingdom | United Kingdom | British | 94724020003 | |||||
| SHORT, Jonathan Ottley | Amministratore | 70 York Street G2 8JX Glasgow 4 Atlantic Quay | England | British | 68161740001 | |||||
| VETCH, Nicholas John | Amministratore | 70 York Street G2 8JX Glasgow 4 Atlantic Quay | England | British | 6270470003 | |||||
| WALLMAN, Rupert Peter | Amministratore | 70 York Street G2 8JX Glasgow 4 Atlantic Quay | England | British | 204171070001 | |||||
| WHITEHOUSE, Victoria Ann | Amministratore | The Old Granary 5 Shurnock Court Saltway B96 6JT Feckenham Worcestershire | England | British | 212489080001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di GILFIN PROPERTY HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
|---|---|---|---|
| Mr Nicholas John Vetch | 06 apr 2016 | 70 York Street G2 8JX Glasgow 4 Atlantic Quay | Sì |
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||
Natura del controllo
| |||
| Mr Stephen John East | 06 apr 2016 | 70 York Street G2 8JX Glasgow 4 Atlantic Quay | Sì |
Nazionalità: British Paese di residenza: United Kingdom | |||
Natura del controllo
| |||
| Mr Rupert Peter Wallman | 06 apr 2016 | 70 York Street G2 8JX Glasgow 4 Atlantic Quay | Sì |
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||
Natura del controllo
| |||
GILFIN PROPERTY HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Creato il 28 nov 2000 Consegnato il 06 dic 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 49-55D rose street, aberdeen. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 09 nov 2000 Consegnato il 24 nov 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 142/144 king street and 8/10 fowlds street, both kilmarnock. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 21 mar 2000 Consegnato il 27 mar 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 273-283 gallowgate, glasgow. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 21 mar 2000 Consegnato il 27 mar 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 273-281 gallowgate, glasgow. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 20 mar 2000 Consegnato il 27 mar 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 381-387 sauchiehall street, glasgow. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 01 mag 1996 Consegnato il 21 mag 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 573 garratt lane,wandsworth,london SW18. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 15 apr 1996 Consegnato il 19 apr 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Lorne arcade, ayr. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 15 apr 1996 Consegnato il 19 apr 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 237 kilmarnock road, glasgow, registered under title number gla 44007. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 27 mar 1996 Consegnato il 16 apr 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 27 gen 1994 Consegnato il 11 feb 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 218 st. Vincent street, glasgow. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 29 apr 1991 Consegnato il 03 mag 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 273-283 gallowgate glasgow gla 52408. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 29 apr 1991 Consegnato il 03 mag 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Interest in ground lease dated 30/5 registered 28/8/86 gla 14922 over 273/283 gallowgate glasgow. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 23 gen 1989 Consegnato il 27 gen 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Shops at rose street, aberdeen. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 16 feb 1988 Consegnato il 22 feb 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Shop 12 bonnygate, cupar, fife. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 18 lug 1986 Consegnato il 28 lug 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 3 three greyfriars garden st andrews. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 11 apr 1985 Consegnato il 23 apr 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Property situated at millie street, kirkcaldy, fife. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 11 apr 1985 Consegnato il 23 apr 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Property situated on the west side of dunnikier road, kirkcaldy, fife. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 03 mar 1982 Consegnato il 16 mar 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 160 howard street, glasgow 417/419 sauchiehall street, glasgow 385/387 sauchiehall street, glasgow 96 waverley street, glasgow. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
GILFIN PROPERTY HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0