RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE)
Panoramica
| Nome della società | RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE) |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC077737 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE)?
- Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi
Dove si trova RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE)?
| Indirizzo della sede legale | 1 Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire Scotland Scotland |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE)?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE)?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordinanza giudiziaria Scheme of arrangement | 8 pagine | OC | ||||||||||
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio Dissolution by c/order effective 21/12/23 manual gazette issued | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ordinanza giudiziaria Diss by c/order | 8 pagine | OC | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 giu 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Christopher Allan Walker come amministratore in data 18 ago 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Giselle Evette Varn come amministratore in data 04 ago 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Colin David Beddall come amministratore in data 31 lug 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Gary Park come amministratore in data 31 lug 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Schlumberger Uk Limited come persona con controllo significativo il 15 lug 2022 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 giu 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mikki Victoria Corcoran come amministratore in data 04 feb 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Roman Higgins come amministratore in data 30 lug 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Roman Higgins come segretario in data 30 lug 2021 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 giu 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Mikki Victoria Corcoran il 15 mar 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Giselle Evette Varn il 15 mar 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Peregrine House Peregrine Road Westhill Business Park, Westhill Aberdeenshire Scotland AB32 6JL a 1 Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill Aberdeen, Aberdeenshire Scotland AB32 6TQ in data 15 mar 2021 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mrs Giselle Evette Varn come amministratore in data 18 gen 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 giu 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon Smoker come segretario in data 29 mag 2020 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mark Roman Higgins come segretario in data 29 mag 2020 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Gary Park come amministratore in data 29 mag 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE)?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEDDALL, Colin David, Mr. | Amministratore | Lauderdale Mansions Lauderdale Road W9 1LX London 29 United Kingdom | United Kingdom | British | 287316070001 | |||||
| WALKER, Christopher Allan | Amministratore | Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire 1 Scotland Scotland | Scotland | American | 299227560001 | |||||
| BRUCE, Gordon Alexander | Segretario | 18 Reidford Gardens Drumoak AB31 5AW Banchory Kincardineshire | British | 120448390001 | ||||||
| DROY MOORE, Pauline | Segretario | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 ONZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | 168150570002 | |||||||
| HENDRY, Eric George | Segretario | School Road Newmachar AB21 0WB Aberdeen 19 Aberdeenshire United Kingdom | British | 139588340001 | ||||||
| HIGGINS, Mark Roman | Segretario | Buckingham Gate SW1E 6AJ London 62 England And Wales United Kingdom | 270743080001 | |||||||
| LEYS, Michael Cheyne | Segretario | 125 Hamilton Place AB2 4BD Aberdeen | British | 3742210004 | ||||||
| SMOKER, Simon | Segretario | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 0NZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | 203976100001 | |||||||
| BARR, Lawrence Robert | Amministratore | Findon AB12 4RL Aberdeen Blackhill Steading East Aberdeenshire Great Britain | United Kingdom | British | 96384280001 | |||||
| BERG, Jorgen | Amministratore | Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire 1 Scotland Scotland | United Kingdom | Danish | 177176120001 | |||||
| BOYAULT, Gwenola Jacqueline Stephanie | Amministratore | Buckingham Gate RH6 0NZ Gatwick Airport Schlumberger House West Sussex United Kingdom | United Kingdom | French | 216352570001 | |||||
| BRUCE, Gordon Alexander | Amministratore | 18 Reidford Gardens Drumoak AB31 5AW Banchory Kincardineshire | British | 120448390001 | ||||||
| BRUCE, Ronald James | Amministratore | Badentoy Industrial Park Portlethen Industrial Estate AB12 4YB Portlethen, Aberdeen Badentoy Avenue Scotland Scotland | United Kingdom | British | 67939110001 | |||||
| CHANDLER, Richard | Amministratore | 7310 Foster Island Drive Richmond Texas 77469 Usa | Usa | American | 113233060001 | |||||
| CORCORAN, Mikki Victoria | Amministratore | Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire 1 Scotland Scotland | Scotland | British | 261075650001 | |||||
| DUDMAN, Bryan Leigh | Amministratore | Cr 444 Waelder 78959 Texas 5974 Us | Usa | American | 137079030001 | |||||
| HENDRY, Eric George | Amministratore | School Road Newmachar AB21 0WB Aberdeen 19 Aberdeenshire United Kingdom | United Kingdom | British | 139588340001 | |||||
| HIGGINS, Mark Roman | Amministratore | Buckingham Gate SW1E 6AJ London 62 England And Wales United Kingdom | England | British | 256940520001 | |||||
| HOEING-COSENTINO, Karin Annette | Amministratore | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 ONZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | Scotland | German | 183326450001 | |||||
| JOHNSTON, Gregory | Amministratore | Badentoy Industrial Park Portlethen Industrial Estate AB12 4YB Portlethen, Aberdeen Badentoy Avenue Scotland Scotland | United Kingdom | Irish | 172272950001 | |||||
| KIDD, Ryan Alexander | Amministratore | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 ONZ Gatwick Schlumberger House West Sussex United Kingdom | Scotland | British | 192568420001 | |||||
| LAU, Werner | Amministratore | Grange Lodge South Avenue Cults AB1 9LP Aberdeen Aberdeenshire | West German | 3742290001 | ||||||
| LEYS, Michael Cheyne | Amministratore | 15 West Cults Road Cults AB15 9HQ Aberdeen | Scotland | British | 3742210006 | |||||
| MARSH, David | Amministratore | Buckingham Gate RH6 0NZ Gatwick Airport Schlumberger House West Sussex United Kingdom | United Kingdom | British | 171331520001 | |||||
| MCGACHIE, John | Amministratore | Badentoy Industrial Park Portlethen Industrial Estate AB12 4YB Portlethen, Aberdeen Badentoy Avenue Scotland Scotland | United Kingdom | British | 187731560001 | |||||
| MCROBERTS, James Greer | Amministratore | Alford House One Alford Place AB1 1YB Aberdeen | British | 53510790001 | ||||||
| NICHOLSON, Peter Duncan | Amministratore | The Lilies 20 Bath Street AB39 2DH Stonehaven | Scotland | British | 48078570002 | |||||
| PAISLEY, Martin William | Amministratore | Cairndow PH33 6SD Onich West Highlands | British | 113228990001 | ||||||
| PARK, Gary | Amministratore | Buckingham Gate SW1E 6AJ London 62 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 270424580001 | |||||
| SMOKER, Simon | Amministratore | Buckingham Gate RH6 0NZ Gatwick Airport Schlumberger House West Sussex United Kingdom | England | British | 134158640002 | |||||
| STEINKAMP, Manfred Theodor | Amministratore | Westwinds Cammachmore Stonehaven Aberdeen | West German | 3742280001 | ||||||
| SUTTON, Neal | Amministratore | County Road 242 Shiro 77876 Texas P O Box 10 Usa | American | 50209290001 | ||||||
| VARN, Giselle Evette | Amministratore | Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire 1 Scotland Scotland | Scotland | American | 273564740002 | |||||
| WERNER, Richard | Amministratore | 3507 Newcastle Drive 77027 Houston Texas Usa | American | 50209320002 | ||||||
| WILDE, Geraldine | Amministratore | 2819 Hazy Hillside Ct 77345 Kingwood Tx Usa | Usa | American | 56051310001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE)?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlumberger Uk Limited | 06 apr 2016 | Manor Royal RH10 9BU Crawley Minerva United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE) ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Creato il 23 nov 1988 Consegnato il 01 dic 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Lease of ground on the southside of blackness avenue, altens industrial estate, aberdeen. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 14 nov 1988 Consegnato il 21 nov 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 19 gen 1984 Consegnato il 31 gen 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari 0.9 acres situated on or towards the south side of blackness avenue, altens industrial estate, aberdeen. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 09 set 1983 Consegnato il 20 set 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0