SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC086166 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Tlt Llp 140 West George Street G2 2HG Glasgow |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| S&N PUBS AND RESTAURANTS LIMITED | 26 ott 2001 | 26 ott 2001 |
| SCOTTISH & NEWCASTLE RETAIL LIMITED | 18 giu 1991 | 18 giu 1991 |
| LAXERT LIMITED | 10 gen 1984 | 10 gen 1984 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 22 ago 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Verbale della riunione finale di liquidazione volontaria | 11 pagine | 4.26(Scot) | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 ago 2016 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 lug 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Lindsay Anne Keswick come segretario in data 25 apr 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Claire Susan Stewart come segretario in data 25 apr 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 22 ago 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Jonathan Robert Langford come amministratore in data 26 gen 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Daryl Antony Kelly come amministratore in data 26 gen 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lucy Jane Bell come amministratore in data 26 gen 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Kirk Dyson Davis come amministratore in data 21 dic 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Henry Jones come segretario in data 04 dic 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 24 ago 2016 al 30 apr 2016 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 lug 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Patrick James Gallagher come amministratore in data 23 giu 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 23 ago 2014 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 21 York Place Edinburgh EH1 3EN a Tlt Llp 140 West George Street Glasgow G2 2HG in data 01 set 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 lug 2014 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 17 ago 2013 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Claire Susan Stewart come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Susan Rudd come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Henry Jones come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 lug 2013 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 18 ago 2012 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESWICK, Lindsay Anne | Segretario | 140 West George Street G2 2HG Glasgow Tlt Llp | 207523740001 | |||||||
| DAVIS, Kirk Dyson | Amministratore | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 158484730001 | |||||
| BOLTON, George Francis | Segretario | 61 Comiston View EH10 6LZ Edinburgh Midlothian | British | 6950001 | ||||||
| CUTHBERTSON, Colin | Segretario | 5 Hill Gardens LE16 9EB Market Harborough Leicestershire | British | 26369940001 | ||||||
| HOMER, Neville Rex | Segretario | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| HOMER, Neville Rex | Segretario | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| JONES, Henry | Segretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 180592230001 | |||||||
| KENDALL, Timothy James | Segretario | 31 Canterbury Close Erdington B23 7QL Birmingham West Midlands | British | 117397470002 | ||||||
| RUDD, Susan Clare | Segretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 172446760001 | |||||||
| RUDD, Susan Clare | Segretario | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
| STEVENS, Mark | Segretario | 5 Lyon Drive Murieston EH54 9HF Livingston West Lothian | British | 80951870001 | ||||||
| STEWART, Claire Susan | Segretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 181021800001 | |||||||
| STEWART, Claire Susan | Segretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | Other | 130369890001 | ||||||
| WALMSLEY, Derek Kerr | Segretario | High Street Pavenham MK43 7NJ Bedford Walnut Barn Bedfordshire | British | 135181230001 | ||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Amministratore | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| BELL, Lucy Jane | Amministratore | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 164754670001 | |||||
| BUBB, Stewart Edmund Conyers | Amministratore | Clare Cottage 42 Lammas Lane KT10 8PD Esher Surrey | British | 36779040001 | ||||||
| CRICHTON, Roger Wells | Amministratore | Pitsford House West Manor Road, Pitsford NN6 9AR Northampton Northamptonshire | British | 67937290001 | ||||||
| CUMMING, Johanna Louise | Amministratore | 18 Prospect Quay 98 Point Pleasant SW18 1PR London | United Kingdom | British | 111108910001 | |||||
| DANDO, Stephen Peter | Amministratore | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152083750001 | |||||
| DAVIDSON, Angus Neil | Amministratore | High Camilty Harburn EH55 8RH West Calder | British | 26376890001 | ||||||
| DUTTON, Philip | Amministratore | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141395280001 | |||||
| EDWARDS, David James | Amministratore | Greencroft 38 Dunbar Road EH41 3PJ Haddington East Lothian | British | 9489100001 | ||||||
| FLEMING, John William Robert | Amministratore | The Garth Lands Lane HG5 9DE Knaresborough North Yorkshire | British | 39827670001 | ||||||
| FRASER, Stanley Durward | Amministratore | 7 Murrayfield Drive EH12 6EB Edinburgh Midlothian | British | 189330001 | ||||||
| GALLAGHER, Patrick James | Amministratore | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | 205366190001 | |||||
| GEIB, Paul | Amministratore | Redbourne Castle Hill SK10 4AS Prestbury Cheshire | British | 34477180001 | ||||||
| GODWIN-BRATT, Robert James | Amministratore | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 170184800001 | |||||
| GRACE, David Allen | Amministratore | Conservatory Apartments 1 Park Avenue HG2 9BQ Harrogate | British | 67926560002 | ||||||
| HANNAH, Ian George | Amministratore | White Dell Farm Belsize WD3 4NX Sarratt Hertfordshire | British | 37054780003 | ||||||
| HAUPT, Stephen Edward | Amministratore | The Owls Nest Market Square, Lower Heyford OX6 3NY Bicester Oxfordshire | British | 68466580001 | ||||||
| HIELD, Timothy Peter | Amministratore | 20 Cluny Drive EH10 6DP Edinburgh | British | 26376950002 | ||||||
| HOLTHAM, Robert William | Amministratore | The Coppice 3 Dorridge Croft B93 8QL Solihull West Midlands | British | 40415840002 | ||||||
| HOMER, Neville Rex | Amministratore | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| IVELL, Robert Lewis | Amministratore | Boltons Hill Barham Road PE28 0YT Spaldwick Cambridgeshire | United Kingdom | English | 96389110001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spirit Retail Bidco Limited | 06 apr 2016 | Westgate Street IP33 1QT Bury St. Edmunds Westgate Brewery Suffolk England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0