FISHERS SERVICES (ABERFELDY) LIMITED

FISHERS SERVICES (ABERFELDY) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFISHERS SERVICES (ABERFELDY) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC089407
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FISHERS SERVICES (ABERFELDY) LIMITED?

    • Lavaggio e stiratura di prodotti tessili e pellicce (96010) / Altre attività di servizi

    Dove si trova FISHERS SERVICES (ABERFELDY) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Riggs Place
    Cupar
    KY15 5JA Fife
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di FISHERS SERVICES (ABERFELDY) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per FISHERS SERVICES (ABERFELDY) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Stato del capitale al 23 dic 2019

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    legacy

    2 pagineSH20

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 ott 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 ott 2018 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    8 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca SC0894070022, creata il 26 mar 2018

    25 pagineMR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    31 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company enter into documents in connection with banking arrangements aproved 23/02/2018
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Soddisfazione dell'onere SC0894070017 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC0894070019 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC0894070018 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC0894070020 in pieno

    1 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca SC0894070021, creata il 27 nov 2017

    46 pagineMR01

    Nomina di Matthew Hills come amministratore in data 27 nov 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Lucy Jane Renaut come segretario in data 27 nov 2017

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Lucy Jane Renaut come amministratore in data 27 nov 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Lucy Jane Renaut come segretario in data 27 nov 2017

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Lucy Jane Renaut come amministratore in data 27 nov 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Linda Mccurdy come amministratore in data 27 nov 2017

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 ott 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di FISHERS SERVICES (ABERFELDY) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HILLS, Matthew
    Hobart Road
    02459 Newton Centre
    25
    Massachusetts
    Usa
    Amministratore
    Hobart Road
    02459 Newton Centre
    25
    Massachusetts
    Usa
    United StatesAmerican239891650001
    JONES, Michael William
    Riggs Place
    Cupar
    KY15 5JA Fife
    Amministratore
    Riggs Place
    Cupar
    KY15 5JA Fife
    United KingdomBritish126352170001
    MCCURDY, Linda
    Hasting Street W
    Vancouver
    1002-1205
    British Columbia, V6e 4t7
    Canada
    Amministratore
    Hasting Street W
    Vancouver
    1002-1205
    British Columbia, V6e 4t7
    Canada
    CanadaCanadian239891640001
    FISHER, Jennifer Elizabeth
    Rathillet Farm
    KY15 4QG Cupar
    Fife
    Segretario
    Rathillet Farm
    KY15 4QG Cupar
    Fife
    British78428780001
    FISHER, Judith Margaret
    Arden
    Cupar
    Fife
    Segretario
    Arden
    Cupar
    Fife
    British34855450001
    INGLIS, Scott Ian
    Riggs Place
    KY15 5JA Cupar
    Fishers Services (Aberfeldy) Ltd
    Fife
    Scotland
    Segretario
    Riggs Place
    KY15 5JA Cupar
    Fishers Services (Aberfeldy) Ltd
    Fife
    Scotland
    British172854670001
    MACKAY, Roderick Gunn
    2 Innerleithen Way
    PH1 1RN Perth
    Perthshire
    Segretario
    2 Innerleithen Way
    PH1 1RN Perth
    Perthshire
    British96851920001
    RENAUT, Lucy Jane
    Riggs Place
    Cupar
    KY15 5JA Fife
    Segretario
    Riggs Place
    Cupar
    KY15 5JA Fife
    193555160001
    SANDIE, James Scott
    2 Meadowfield Court
    KY15 7AT Falkland
    Fife
    Segretario
    2 Meadowfield Court
    KY15 7AT Falkland
    Fife
    British34380240001
    FISHER, Donald Mcdonald
    Arden
    Cupar
    Fife
    Amministratore
    Arden
    Cupar
    Fife
    British918010001
    FISHER, James
    Torr Hill
    Aberfeldy
    Amministratore
    Torr Hill
    Aberfeldy
    British932430001
    INGLIS, Scott Ian
    Riggs Place
    KY15 5JA Cupar
    Fishers Services (Aberfeldy) Ltd
    Fife
    Scotland
    Amministratore
    Riggs Place
    KY15 5JA Cupar
    Fishers Services (Aberfeldy) Ltd
    Fife
    Scotland
    ScotlandBritish172854550001
    MACKAY, Roderick Gunn
    2 Innerleithen Way
    PH1 1RN Perth
    Perthshire
    Amministratore
    2 Innerleithen Way
    PH1 1RN Perth
    Perthshire
    ScotlandBritish96851920001
    MCHARDY, Bruce Alexander
    The Park
    Brighton Road
    KY15 5DH Cupar
    Fife
    Amministratore
    The Park
    Brighton Road
    KY15 5DH Cupar
    Fife
    ScotlandBritish40384630002
    RENAUT, Lucy Jane
    Riggs Place
    Cupar
    KY15 5JA Fife
    Amministratore
    Riggs Place
    Cupar
    KY15 5JA Fife
    ScotlandBritish193551970001
    WARD, David Victor
    38 Druids Park
    Murthly
    PH1 4EJ Perthshire
    Amministratore
    38 Druids Park
    Murthly
    PH1 4EJ Perthshire
    Irish19729330003

    Chi sono le persone con controllo significativo di FISHERS SERVICES (ABERFELDY) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Fishers Services Ltd
    Riggs Place
    KY15 5JA Cupar
    3
    Scotland
    06 apr 2016
    Riggs Place
    KY15 5JA Cupar
    3
    Scotland
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleUk
    Luogo di registrazioneCompanies House Scotland
    Numero di registrazioneSc067627
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    FISHERS SERVICES (ABERFELDY) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 26 mar 2018
    Consegnato il 05 apr 2018
    In corso
    Breve descrizione
    All and whole that area of ground in the county of perth forming part of the inveralmond industrial estate, perth and extending to 1.063 ha or thereby being the subjects shown coloured pink on the plan annexed and signed as relative to the charge (hereinafter referred to as the “plan”) and comprising all and whole the subjects extending to one hectare and three hundred and sixty six decimal or one thousandth parts of a hectare or thereby being the subjects more particularly described in, disponed by and delineated in red on the plan annexed and subscribed as relative to feu disposition by the perth and kinross district council in favour of the said fishers services (aberfeldy) limited dated 21 march and recorded in the division of the general register of sasines applicable to the county of perth on 27 march both dates in 1996 under exception of (first) that area of ground situated to the north east of ruthvenfield avenue, perth extending to twenty five square metres or thereby as delineated in black and coloured pink on the plan annexed and subscribed as relative to disposition by us the said fishers services (aberfeldy) limited in favour of scottish hydro-electric PLC dated 17 february and recorded in the said division of the general register of sasines on 10 april both dates in 1997 together with (by way of exception and not inclusion) the heritable and irredeemable servitude rights specified and contained in said disposition and (second) the subjects lying on the east side of ruthvenfield avenue, inveralmond industrial estate, perth being the subjects registered in the land register of scotland under title number PTH48297, which subjects (first) and (second) hereinbefore described are both shown for the avoidance of doubt coloured yellow on the said plan.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • The Toronto-Dominion Bank
    Transazioni
    • 05 apr 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 27 nov 2017
    Consegnato il 12 dic 2017
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Toronto-Dominion Bank
    Transazioni
    • 12 dic 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 05 lug 2013
    Consegnato il 15 lug 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All and whole the area of ground extending to 5/1,000TH parts of an acre lying to the north east of home street aberfeldy. See form 466. notification of addition to or amendment of charge.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 15 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 14 dic 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 05 lug 2013
    Consegnato il 15 lug 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Plot or area of ground being part of the inveralmond industrial estate perth see form.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 15 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 14 dic 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 27 giu 2013
    Consegnato il 04 lug 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Cavendish Square Partners Limited
    Transazioni
    • 04 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 16 lug 2013Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 14 dic 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    • Ha modifiche all'ordine:
    A registered charge
    Creato il 27 giu 2013
    Consegnato il 03 lug 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 03 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 lug 2013Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 14 dic 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Standard security
    Creato il 06 dic 2007
    Consegnato il 18 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects at home street, aberfeldy PTH21621.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 18 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 02 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 06 dic 2007
    Consegnato il 18 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    1.366 hectares of ground at inveralmond industrial estate, perth.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 18 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 02 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge
    Creato il 30 nov 2007
    Consegnato il 05 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 02 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 26 apr 2004
    Consegnato il 07 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Ground east side of home street, aberfeldy PTH9204.
    Persone aventi diritto
    • Close Investment Partners Limited
    Transazioni
    • 07 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 05 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 26 apr 2004
    Consegnato il 07 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Ground part of inveralmond industrial estate, perth.
    Persone aventi diritto
    • Close Investment Partners Limited
    Transazioni
    • 07 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 05 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 26 apr 2004
    Consegnato il 07 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Ground at east home street, aberfeldy.
    Persone aventi diritto
    • Close Investment Partners Limited
    Transazioni
    • 07 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 05 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 26 apr 2004
    Consegnato il 07 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    55 kelly street, greenock REN104183.
    Persone aventi diritto
    • Close Investment Partners Limited
    Transazioni
    • 07 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • 16 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 26 apr 2004
    Consegnato il 04 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Property known as home street, aberfeldy.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 05 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 26 apr 2004
    Consegnato il 04 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    239 square yards in the burgh of aberfeldy, county of perth under exception of ground on east side of home street, aberfeldy PTH9204.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 05 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 26 apr 2004
    Consegnato il 04 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Part of inveralmond industrial estate, perth.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 05 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 26 apr 2004
    Consegnato il 04 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    55 kelly street, greenock REN104183.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 26 mar 2004
    Consegnato il 08 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Close Investment Partners Limited
    Transazioni
    • 08 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 apr 2004Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 05 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Floating charge
    Creato il 26 mar 2004
    Consegnato il 30 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 30 mar 2004Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 05 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Standard security
    Creato il 27 mar 1996
    Consegnato il 03 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    0.484 hectares at ruthvenfield avenue,inveralmond industrial estate,perth.
    Persone aventi diritto
    • Perth and Kinross District Council
    Transazioni
    • 03 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 02 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 14 ago 1991
    Consegnato il 28 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Rose cottage, 20 dunkeld street aberfeldy perth.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 16 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Letter of offset
    Creato il 31 ott 1985
    Consegnato il 07 nov 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due, or to become due by fishers holdings LTD and/or others
    Brevi particolari
    The balances at credit of any accounts held by the bank in name of the company.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 nov 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 16 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0