CIRRUS LOGIC INTERNATIONAL (UK) LTD

CIRRUS LOGIC INTERNATIONAL (UK) LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCIRRUS LOGIC INTERNATIONAL (UK) LTD
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC089839
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di CIRRUS LOGIC INTERNATIONAL (UK) LTD?

    • fabbricazione di componenti elettronici (26110) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova CIRRUS LOGIC INTERNATIONAL (UK) LTD?

    Indirizzo della sede legale
    7 B Nightingale Way
    Quartermile
    EH3 9EG Edinburgh
    Scotland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CIRRUS LOGIC INTERNATIONAL (UK) LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WOLFSON MICROELECTRONICS LIMITED21 ago 201421 ago 2014
    WOLFSON MICROELECTRONICS PLC28 ott 200228 ott 2002
    WOLFSON MICROELECTRONICS LIMITED05 nov 198405 nov 1984
    WMI ELECTRONICS LIMITED26 set 198426 set 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di CIRRUS LOGIC INTERNATIONAL (UK) LTD?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mar 2025
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 dic 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 mar 2024

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per CIRRUS LOGIC INTERNATIONAL (UK) LTD?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al26 giu 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma10 lug 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al26 giu 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per CIRRUS LOGIC INTERNATIONAL (UK) LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 giu 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 mar 2024

    64 pagineAA

    Cessazione della carica di Venkatesh Rengarajan Nathamuni come amministratore in data 24 mag 2024

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 giu 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 25 mar 2023

    63 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Venkatesh Rengarajan Nathamuni il 07 lug 2022

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 26 mar 2022

    61 pagineAA

    Nomina di Venkatesh Rengarajan Nathamuni come amministratore in data 05 mag 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Thurman Klay Case come amministratore in data 18 apr 2022

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 27 mar 2021

    58 pagineAA

    Cessazione della carica di Gregory Scott Thomas come segretario in data 12 feb 2021

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Pedro Andrade come amministratore in data 22 gen 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Andrew Findlay Keir come segretario in data 12 feb 2021

    2 pagineAP03

    Nomina di Mrs Sarah Ann Wallis come amministratore in data 12 feb 2021

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 giu 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 28 mar 2020

    54 pagineAA

    Stato del capitale al 04 ott 2019

    • Capitale: GBP 0.001
    5 pagineSH19

    legacy

    2 pagineSH20

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    The share premium account of the company be cancelled and the amount of the share premium accounts so cancelled ($18,589.990.00) be credited to a distributable reserve of the company/that the capital redemption reserve of the company be cancelled and the amount of the capital redemption reserve so cancelled ($63,215,465.47) be credited to a distributable reserve of the company. 25/09/2019
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 mar 2019

    55 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 giu 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di CIRRUS LOGIC INTERNATIONAL (UK) LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KEIR, Andrew Findlay
    Nightingale Way
    Quartermile
    EH3 9EG Edinburgh
    7 B
    Scotland
    Segretario
    Nightingale Way
    Quartermile
    EH3 9EG Edinburgh
    7 B
    Scotland
    279700340001
    HUGHES, Allan William
    Nightingale Way
    Quartermile
    EH3 9EG Edinburgh
    7 B
    Scotland
    Amministratore
    Nightingale Way
    Quartermile
    EH3 9EG Edinburgh
    7 B
    Scotland
    United KingdomBritishDirector75476260001
    WALLIS, Sarah Ann
    835 W 6th Street
    78703 Austin
    Shoal Creek
    United States
    Amministratore
    835 W 6th Street
    78703 Austin
    Shoal Creek
    United States
    United StatesAmericanAccountant279693460001
    CUBITT, Mark
    Duncraggan House
    34 Airthrey Road
    FK9 5JS Stirling
    Segretario
    Duncraggan House
    34 Airthrey Road
    FK9 5JS Stirling
    British64309900002
    ELLIOTT, George Reginald
    Whinfield Paterson Street
    TD1 3DD Galashiels
    Selkirkshire
    Segretario
    Whinfield Paterson Street
    TD1 3DD Galashiels
    Selkirkshire
    British1231960002
    GOLDSMITH, Jill Louise
    Hopetoun Street
    EH7 4NG Edinburgh
    55/3
    Midlothian
    Segretario
    Hopetoun Street
    EH7 4NG Edinburgh
    55/3
    Midlothian
    British130571800001
    HATTERSLEY, Neil Graham
    6 Bramdean Place
    EH10 6JS Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    6 Bramdean Place
    EH10 6JS Edinburgh
    Midlothian
    British17832980001
    MURDOCH, Fiona Kathryn
    5/2 Bruntsfield Gardens
    EH10 4DX Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    5/2 Bruntsfield Gardens
    EH10 4DX Edinburgh
    Midlothian
    British102360100001
    THOMAS, Gregory Scott
    Nightingale Way
    Quartermile
    EH3 9EG Edinburgh
    7 B
    Scotland
    Segretario
    Nightingale Way
    Quartermile
    EH3 9EG Edinburgh
    7 B
    Scotland
    216428310001
    ALLCOTT, John Alfred
    Bedruthan Cowal Crescent
    PA19 1EY Gourock
    Renfrewshire
    Scotland
    Amministratore
    Bedruthan Cowal Crescent
    PA19 1EY Gourock
    Renfrewshire
    Scotland
    BritishBusiness Advisor11752840001
    ANDRADE, Pedro
    Austin
    800 W.6th Street
    Tx 78701
    United States
    Amministratore
    Austin
    800 W.6th Street
    Tx 78701
    United States
    United StatesAmericanDirector194330920002
    CAREY, John
    15320 Peach Hill Road
    95070 Saratago
    California
    Usa
    Amministratore
    15320 Peach Hill Road
    95070 Saratago
    California
    Usa
    BritishCompany Director65559540001
    CARMICHAEL, Peter
    86 Craiglea Drive
    EH10 5PH Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    86 Craiglea Drive
    EH10 5PH Edinburgh
    Midlothian
    BritishSelf Employed98740001
    CASE, Thurman Klay
    Nightingale Way
    Quartermile
    EH3 9EG Edinburgh
    7 B
    Scotland
    Amministratore
    Nightingale Way
    Quartermile
    EH3 9EG Edinburgh
    7 B
    Scotland
    United StatesAmericanVice President147568610002
    CAUBLE, Ky Lane
    Westfield House
    26 Westfield Road
    EH11 2QB Edinburgh
    Amministratore
    Westfield House
    26 Westfield Road
    EH11 2QB Edinburgh
    United States Of AmericaAmericanDirector119118450001
    COLLINSON, Glenn
    56 High Street
    Chippenham
    CB7 5PP Ely
    Cambridgeshire
    Amministratore
    56 High Street
    Chippenham
    CB7 5PP Ely
    Cambridgeshire
    EnglandBritishConsultant61120210002
    CUBITT, Mark
    Duncraggan House
    34 Airthrey Road
    FK9 5JS Stirling
    Amministratore
    Duncraggan House
    34 Airthrey Road
    FK9 5JS Stirling
    ScotlandBritishAccountant64309900002
    ECKELMANN, Robert Laurence
    1751 Sw Prospect Drive
    97201 Portland
    Oregon
    Usa
    Amministratore
    1751 Sw Prospect Drive
    97201 Portland
    Oregon
    Usa
    FranceUsaDirector101303830002
    ELLIOTT, George Reginald
    Whinfield Paterson Street
    TD1 3DD Galashiels
    Selkirkshire
    Amministratore
    Whinfield Paterson Street
    TD1 3DD Galashiels
    Selkirkshire
    BritishChartered Accountant1231960002
    GAMMELL, James Gilbert Sydney
    Foxhall
    EH29 9ER Kirkliston
    West Lothian
    Amministratore
    Foxhall
    EH29 9ER Kirkliston
    West Lothian
    BritishChartered Accountant130980001
    GERMIES, Jurgen
    Stenbenstr.12
    47447 Moers
    Germany
    Amministratore
    Stenbenstr.12
    47447 Moers
    Germany
    GermanDirector90736800001
    GINMAN, Maria Charlotta
    Westfield House
    26 Westfield Road
    EH11 2QB Edinburgh
    Amministratore
    Westfield House
    26 Westfield Road
    EH11 2QB Edinburgh
    EnglandFinnishChartered Accountant179801010002
    GRAHAM, Ross King
    Sale Place
    W2 1PJ London
    5
    London
    Amministratore
    Sale Place
    W2 1PJ London
    5
    London
    United KingdomBritishDirector61733920005
    GRANT, John Albert Martin
    Westfield House
    26 Westfield Road
    EH11 2QB Edinburgh
    Amministratore
    Westfield House
    26 Westfield Road
    EH11 2QB Edinburgh
    EnglandBritishCompany Director55161940001
    HATTERSLEY, Neil Graham
    6 Bramdean Place
    EH10 6JS Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    6 Bramdean Place
    EH10 6JS Edinburgh
    Midlothian
    BritishAccountant17832980001
    HICKEY, Joseph Michael
    Clease Way
    Compton
    SO21 2AL Winchester
    Larchwood,
    Hampshire
    Amministratore
    Clease Way
    Compton
    SO21 2AL Winchester
    Larchwood,
    Hampshire
    EnglandBritishGeneral Manager133409490001
    LOCKWOOD, Gregory Kilbourn
    89 Overstrand Mansions
    Prince Of Wales Drive
    SW11 4EU London
    Amministratore
    89 Overstrand Mansions
    Prince Of Wales Drive
    SW11 4EU London
    CanadianBanker80094870001
    MCPATE, John
    7 Clufflat Brae
    EH30 9YQ South Queensferry
    West Lothian
    Amministratore
    7 Clufflat Brae
    EH30 9YQ South Queensferry
    West Lothian
    BritishSales Director1119070002
    MCSWAN, Malcolm
    Latch House
    Abernyte
    PH14 9SU Perth
    Perthshire
    Amministratore
    Latch House
    Abernyte
    PH14 9SU Perth
    Perthshire
    ScotlandBritishChartered Accountant108155240001
    MILNE, Alastair David, Dr
    18 Napier Road
    EH10 5AY Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    18 Napier Road
    EH10 5AY Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritishDirector17832990002
    NATHAMUNI, Venkatesh Rengarajan
    835 W 6th Street
    78703 Austin
    Shoal Creek
    United States
    Amministratore
    835 W 6th Street
    78703 Austin
    Shoal Creek
    United States
    United StatesAmericanChief Financial Officer295544180001
    PYE, Michael Richard
    Redwood House
    Milnthorpe Lane
    SO22 4NP Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    Redwood House
    Milnthorpe Lane
    SO22 4NP Winchester
    Hampshire
    BritishDirector79970980001
    REID, James Robert Craig
    38 Fountainhall Road
    EH9 2LW Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    38 Fountainhall Road
    EH9 2LW Edinburgh
    Midlothian
    BritishEngineering Director668820001
    ROSE, Barry Michael
    8 Spylaw Bank Road
    Colinton
    EH13 0JP Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    8 Spylaw Bank Road
    Colinton
    EH13 0JP Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritishDirector1044490001
    RUETTGERS, Michael C
    453 Bedford Road
    Carlisle
    Massachusetts 01741
    Usa
    Amministratore
    453 Bedford Road
    Carlisle
    Massachusetts 01741
    Usa
    AmericanDirector68808240001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CIRRUS LOGIC INTERNATIONAL (UK) LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    The Sector Newbury Business Park
    London Road
    RG14 2PZ Newbury
    3
    United Kingdom
    26 mar 2018
    The Sector Newbury Business Park
    London Road
    RG14 2PZ Newbury
    3
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione11273051
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Cirrus Logic International Semiconductor Ltd.
    26 Westfield Road
    EH11 2QB Edinburgh
    Westfield House,
    Scotland
    09 giu 2016
    26 Westfield Road
    EH11 2QB Edinburgh
    Westfield House,
    Scotland
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneScotland
    Numero di registrazioneSc495735
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    CIRRUS LOGIC INTERNATIONAL (UK) LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 31 gen 2014
    Consegnato il 07 feb 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 feb 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 feb 2014Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 03 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    • Ha modifiche all'ordine:
    A registered charge
    Creato il 31 gen 2014
    Consegnato il 07 feb 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 07 feb 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 feb 2014Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 10 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Standard security
    Creato il 09 set 2003
    Consegnato il 17 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Westfield house, 22 westfield road, edinburgh MID48025.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 set 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 10 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 07 set 1988
    Consegnato il 26 set 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The whole assets of the company.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 26 set 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 20 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0