CIRRUS LOGIC INTERNATIONAL (UK) LTD
Panoramica
Nome della società | CIRRUS LOGIC INTERNATIONAL (UK) LTD |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | SC089839 |
Giurisdizione | Scozia |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CIRRUS LOGIC INTERNATIONAL (UK) LTD?
- fabbricazione di componenti elettronici (26110) / Industrie manifatturiere
Dove si trova CIRRUS LOGIC INTERNATIONAL (UK) LTD?
Indirizzo della sede legale | 7 B Nightingale Way Quartermile EH3 9EG Edinburgh Scotland |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CIRRUS LOGIC INTERNATIONAL (UK) LTD?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
WOLFSON MICROELECTRONICS LIMITED | 21 ago 2014 | 21 ago 2014 |
WOLFSON MICROELECTRONICS PLC | 28 ott 2002 | 28 ott 2002 |
WOLFSON MICROELECTRONICS LIMITED | 05 nov 1984 | 05 nov 1984 |
WMI ELECTRONICS LIMITED | 26 set 1984 | 26 set 1984 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CIRRUS LOGIC INTERNATIONAL (UK) LTD?
Scaduto | No |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 31 mar 2025 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 dic 2025 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 30 mar 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per CIRRUS LOGIC INTERNATIONAL (UK) LTD?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 26 giu 2025 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 10 lug 2025 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 26 giu 2024 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per CIRRUS LOGIC INTERNATIONAL (UK) LTD?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichiarazione di conformità presentata il 26 giu 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 mar 2024 | 64 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Venkatesh Rengarajan Nathamuni come amministratore in data 24 mag 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 giu 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 25 mar 2023 | 63 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 giu 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Venkatesh Rengarajan Nathamuni il 07 lug 2022 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 26 mar 2022 | 61 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Venkatesh Rengarajan Nathamuni come amministratore in data 05 mag 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Thurman Klay Case come amministratore in data 18 apr 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 giu 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 27 mar 2021 | 58 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Gregory Scott Thomas come segretario in data 12 feb 2021 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Pedro Andrade come amministratore in data 22 gen 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Andrew Findlay Keir come segretario in data 12 feb 2021 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Nomina di Mrs Sarah Ann Wallis come amministratore in data 12 feb 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 giu 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 28 mar 2020 | 54 pagine | AA | ||||||||||||||
Stato del capitale al 04 ott 2019
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 giu 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 mar 2019 | 55 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 giu 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di CIRRUS LOGIC INTERNATIONAL (UK) LTD?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEIR, Andrew Findlay | Segretario | Nightingale Way Quartermile EH3 9EG Edinburgh 7 B Scotland | 279700340001 | |||||||
HUGHES, Allan William | Amministratore | Nightingale Way Quartermile EH3 9EG Edinburgh 7 B Scotland | United Kingdom | British | Director | 75476260001 | ||||
WALLIS, Sarah Ann | Amministratore | 835 W 6th Street 78703 Austin Shoal Creek United States | United States | American | Accountant | 279693460001 | ||||
CUBITT, Mark | Segretario | Duncraggan House 34 Airthrey Road FK9 5JS Stirling | British | 64309900002 | ||||||
ELLIOTT, George Reginald | Segretario | Whinfield Paterson Street TD1 3DD Galashiels Selkirkshire | British | 1231960002 | ||||||
GOLDSMITH, Jill Louise | Segretario | Hopetoun Street EH7 4NG Edinburgh 55/3 Midlothian | British | 130571800001 | ||||||
HATTERSLEY, Neil Graham | Segretario | 6 Bramdean Place EH10 6JS Edinburgh Midlothian | British | 17832980001 | ||||||
MURDOCH, Fiona Kathryn | Segretario | 5/2 Bruntsfield Gardens EH10 4DX Edinburgh Midlothian | British | 102360100001 | ||||||
THOMAS, Gregory Scott | Segretario | Nightingale Way Quartermile EH3 9EG Edinburgh 7 B Scotland | 216428310001 | |||||||
ALLCOTT, John Alfred | Amministratore | Bedruthan Cowal Crescent PA19 1EY Gourock Renfrewshire Scotland | British | Business Advisor | 11752840001 | |||||
ANDRADE, Pedro | Amministratore | Austin 800 W.6th Street Tx 78701 United States | United States | American | Director | 194330920002 | ||||
CAREY, John | Amministratore | 15320 Peach Hill Road 95070 Saratago California Usa | British | Company Director | 65559540001 | |||||
CARMICHAEL, Peter | Amministratore | 86 Craiglea Drive EH10 5PH Edinburgh Midlothian | British | Self Employed | 98740001 | |||||
CASE, Thurman Klay | Amministratore | Nightingale Way Quartermile EH3 9EG Edinburgh 7 B Scotland | United States | American | Vice President | 147568610002 | ||||
CAUBLE, Ky Lane | Amministratore | Westfield House 26 Westfield Road EH11 2QB Edinburgh | United States Of America | American | Director | 119118450001 | ||||
COLLINSON, Glenn | Amministratore | 56 High Street Chippenham CB7 5PP Ely Cambridgeshire | England | British | Consultant | 61120210002 | ||||
CUBITT, Mark | Amministratore | Duncraggan House 34 Airthrey Road FK9 5JS Stirling | Scotland | British | Accountant | 64309900002 | ||||
ECKELMANN, Robert Laurence | Amministratore | 1751 Sw Prospect Drive 97201 Portland Oregon Usa | France | Usa | Director | 101303830002 | ||||
ELLIOTT, George Reginald | Amministratore | Whinfield Paterson Street TD1 3DD Galashiels Selkirkshire | British | Chartered Accountant | 1231960002 | |||||
GAMMELL, James Gilbert Sydney | Amministratore | Foxhall EH29 9ER Kirkliston West Lothian | British | Chartered Accountant | 130980001 | |||||
GERMIES, Jurgen | Amministratore | Stenbenstr.12 47447 Moers Germany | German | Director | 90736800001 | |||||
GINMAN, Maria Charlotta | Amministratore | Westfield House 26 Westfield Road EH11 2QB Edinburgh | England | Finnish | Chartered Accountant | 179801010002 | ||||
GRAHAM, Ross King | Amministratore | Sale Place W2 1PJ London 5 London | United Kingdom | British | Director | 61733920005 | ||||
GRANT, John Albert Martin | Amministratore | Westfield House 26 Westfield Road EH11 2QB Edinburgh | England | British | Company Director | 55161940001 | ||||
HATTERSLEY, Neil Graham | Amministratore | 6 Bramdean Place EH10 6JS Edinburgh Midlothian | British | Accountant | 17832980001 | |||||
HICKEY, Joseph Michael | Amministratore | Clease Way Compton SO21 2AL Winchester Larchwood, Hampshire | England | British | General Manager | 133409490001 | ||||
LOCKWOOD, Gregory Kilbourn | Amministratore | 89 Overstrand Mansions Prince Of Wales Drive SW11 4EU London | Canadian | Banker | 80094870001 | |||||
MCPATE, John | Amministratore | 7 Clufflat Brae EH30 9YQ South Queensferry West Lothian | British | Sales Director | 1119070002 | |||||
MCSWAN, Malcolm | Amministratore | Latch House Abernyte PH14 9SU Perth Perthshire | Scotland | British | Chartered Accountant | 108155240001 | ||||
MILNE, Alastair David, Dr | Amministratore | 18 Napier Road EH10 5AY Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | Director | 17832990002 | ||||
NATHAMUNI, Venkatesh Rengarajan | Amministratore | 835 W 6th Street 78703 Austin Shoal Creek United States | United States | American | Chief Financial Officer | 295544180001 | ||||
PYE, Michael Richard | Amministratore | Redwood House Milnthorpe Lane SO22 4NP Winchester Hampshire | British | Director | 79970980001 | |||||
REID, James Robert Craig | Amministratore | 38 Fountainhall Road EH9 2LW Edinburgh Midlothian | British | Engineering Director | 668820001 | |||||
ROSE, Barry Michael | Amministratore | 8 Spylaw Bank Road Colinton EH13 0JP Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | Director | 1044490001 | ||||
RUETTGERS, Michael C | Amministratore | 453 Bedford Road Carlisle Massachusetts 01741 Usa | American | Director | 68808240001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CIRRUS LOGIC INTERNATIONAL (UK) LTD?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cirrus Logic International Holdings Ltd | 26 mar 2018 | The Sector Newbury Business Park London Road RG14 2PZ Newbury 3 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Cirrus Logic International Semiconductor Ltd. | 09 giu 2016 | 26 Westfield Road EH11 2QB Edinburgh Westfield House, Scotland | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
CIRRUS LOGIC INTERNATIONAL (UK) LTD ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 31 gen 2014 Consegnato il 07 feb 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
A registered charge | Creato il 31 gen 2014 Consegnato il 07 feb 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
Standard security | Creato il 09 set 2003 Consegnato il 17 set 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Westfield house, 22 westfield road, edinburgh MID48025. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Bond & floating charge | Creato il 07 set 1988 Consegnato il 26 set 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari The whole assets of the company. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0