ROSE & BOYLE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ROSE & BOYLE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC091975 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ROSE & BOYLE LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova ROSE & BOYLE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 204 Polmadie Road Hampden Park Industrial Estate G5 0HD Glasgow |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ROSE & BOYLE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| IROSSEN LIMITED | 05 mar 1985 | 05 mar 1985 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ROSE & BOYLE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2012 |
Quali sono le ultime deposizioni per ROSE & BOYLE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Nomina di Mrs Wendy Margaret Hall come amministratore in data 01 gen 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di William Shepherd come amministratore in data 31 dic 2013 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 set 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 12 set 2013
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 set 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Mr Thorsten Beer come amministratore in data 03 set 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew John Willetts come amministratore in data 03 set 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mrs Nichola Louise Legg come segretario in data 25 lug 2012 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jennifer Anne Brierley come segretario in data 25 lug 2012 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 set 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter Smerdon come amministratore in data 01 ago 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr William Shepherd come amministratore in data 01 ago 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 set 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Jennifer Anne Brierley il 01 ott 2009 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 set 2009 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ROSE & BOYLE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGG, Nichola Louise | Segretario | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | 163214890001 | |||||||
| BEER, Thorsten | Amministratore | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | United Kingdom | German | 172030260001 | |||||
| HALL, Wendy Margaret | Amministratore | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | 172979860001 | |||||
| BRIERLEY, Jennifer Anne | Segretario | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | British | 118563210001 | ||||||
| BUCKELL, Stephen William | Segretario | Wykin House Wykin LE10 3PN Hinckley Leicestershire | British | 20341960001 | ||||||
| DAVIES, John Richard Bridge | Segretario | Amberley 5 Primrose Hill Waste Lane CW6 0PE Kelsall Cheshire | British | 51554100001 | ||||||
| HEATON, Janet Ruth | Segretario | 7 Hunters Row Portland Street LE9 1TQ Cosby Leicestershire | British | 81228260001 | ||||||
| NASH, Andrew | Segretario | Lych Gates Angel Street Upper Bentley B97 5TA Redditch Worcestershire | British | 48592890001 | ||||||
| ROSE, Agnes Ann Moore | Segretario | 48b Whitehouse Road EH4 6PH Edinburgh | British | 41128730001 | ||||||
| SADLER, John Michael | Segretario | 12 Cransley Grove B91 3ZA Solihull West Midland | British | 44018260001 | ||||||
| SMERDON, Peter | Segretario | 40 Stoneton Crescent Balsall Common CV7 7QG Coventry Warwickshire | British | 16898700002 | ||||||
| BOYLE, Denis | Amministratore | 51 Hailes Gardens EH13 0JH Edinburgh Midlothian | British | 608450002 | ||||||
| BOYLE, Margaret Grace | Amministratore | 51 Hailes Gardens EH13 0JH Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 608460003 | |||||
| BUCKELL, Stephen William | Amministratore | Wykin House Wykin LE10 3PN Hinckley Leicestershire | British | 20341960001 | ||||||
| COWAN, Ian Campbell | Amministratore | 31 Saint Andrews Crescent Sunningdale Park LL13 9GY Wrexham | Wales | British | 86854400001 | |||||
| FELLOWS, Jonathan | Amministratore | 26 Ladywood Road Four Oaks B74 2QN Sutton Coldfield West Midlands | England | British | 118296490001 | |||||
| HARDY, Martyn James | Amministratore | The Corner House Preston Bagott B95 5EH Henley-In-Arden Warwickshire | British | 74148120001 | ||||||
| HOOD, John | Amministratore | 27 Medina House, Diglis Dock Road WR5 3DD Worcester | British | 39644740002 | ||||||
| KERSHAW, Graham Anthony | Amministratore | Selsley House Westhorpe LE16 9UL Sibbertoft Leicestershire | United Kingdom | British | 8991780003 | |||||
| LLOYD, Allen John | Amministratore | Yew House Freasley B78 2EY Tamworth Staffordshire | British | 2270630001 | ||||||
| LLOYD, Peter Edward | Amministratore | Southfield Coventry Road CV8 2FT Kenilworth Warwickshire | British | 35546210001 | ||||||
| MEISTER, Stefan Mario | Amministratore | Rosengartenstrasse 19 70184 Stuttgart Germany | Swiss | 43550520003 | ||||||
| MISCHKE, Gerhard Viktor | Amministratore | Whitehill Farmhouse Alderminster CV37 8BW Stratford Upon Avon Warwickshire | Germany | 62107000001 | ||||||
| MOORE, Dean | Amministratore | Bleak House Oaks Road LE67 5UP Whitwick Leicestershire | British | 94541520001 | ||||||
| ROSE, Agnes Ann Moore | Amministratore | 48b Whitehouse Road EH4 6PH Edinburgh | British | 41128730001 | ||||||
| ROSE, Archibald | Amministratore | 48 Whitehouse Road Cramond EH4 6PH Edinburgh Midlothian | British | 608440001 | ||||||
| SHEPHERD, William | Amministratore | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | Great Britain | British | 162873980001 | |||||
| SMERDON, Peter | Amministratore | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | 16898700002 | |||||
| TURNER, Richard Gill | Amministratore | The Old Coach House Mill Lane Sheepy Parva CV9 3RL Atherstone Warwickshire | British | 51796560002 | ||||||
| VIZARD, Ronald Charles, Harold | Amministratore | Fieldfare Pigeon Green, Snitterfield CV37 OLP Stratford-Upon-Avon Warwickshire | British | 122881190001 | ||||||
| WARD, Michael Ashley | Amministratore | Flat 603 Shad Thames SE1 2YL London | England | British | 114711020001 | |||||
| WILLETTS, Andrew John | Amministratore | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | 120451550002 |
ROSE & BOYLE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Creato il 03 ago 1992 Consegnato il 07 ago 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 57 high street, tranent. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 03 ago 1992 Consegnato il 07 ago 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 57 high street, tranent. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of variation of a standard security | Creato il 14 lug 1992 Consegnato il 04 ago 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due in terms of a personel bond dated 26/06/92. | |
Brevi particolari Plot of ground lying in dalmeny bounded on the north by roseberry avenue, south queensferry. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of variation of a standard security | Creato il 14 lug 1992 Consegnato il 04 ago 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due in terms of a personal bond dated 26/06/92. | |
Brevi particolari Plot of ground lying on the west side of richmond terrace, bo'ness. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 14 lug 1992 Consegnato il 24 lug 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Plot of ground bounded on the north by roseberry avenue, south queensferry, as relative to disposition by david watson watson in favour of robert falconer marshall shorthouse recoreded grs 26/04/77. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 14 lug 1992 Consegnato il 24 lug 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Plot of ground on the west side of richmond terrace, bo'ness as relative to disposition by jessie wallace foster. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 14 lug 1992 Consegnato il 24 lug 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari All and whole that plot of ground containing 575 square yards in kilmarnock as relative to disposition by thomas cuthbertson as trustee therin mentioned with consent in favour of william pollock. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 14 lug 1992 Consegnato il 24 lug 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari That plot of ground containing 575 square yards in kilmarnock as relative to disposition by thomas cuthbertson as trustee therein mentioned with consent in favour of william pollock recorded grs 08/06/1892. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 14 lug 1992 Consegnato il 24 lug 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari All and whole the shop premises known as 52 high street, tranent. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 14 lug 1992 Consegnato il 24 lug 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari All and whole the shop premises known as 52 high street, tranent. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 09 dic 1991 Consegnato il 19 dic 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Medical centre 29B summerside place edinburgh. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 01 mar 1990 Consegnato il 05 mar 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 01 mar 1990 Consegnato il 05 mar 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 23 mag 1988 Consegnato il 02 giu 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Plot of ground in burgh of kilmarnock, ayr. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 23 mag 1988 Consegnato il 02 giu 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Plot of ground on west side of richmond terrace, bo'ness. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 23 mag 1988 Consegnato il 02 giu 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Plot of ground north of rosebery avenue, south queensferry. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 30 nov 1987 Consegnato il 10 dic 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Richmond terrace dean road bo'ness, west lothian. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 08 dic 1986 Consegnato il 15 dic 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 81 john finnie street kilmarnock. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Bond & floating charge | Creato il 18 ago 1986 Consegnato il 04 set 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0