CRIFFEL MICRO BUSINESS SYSTEMS LIMITED
Panoramica
Nome della società | CRIFFEL MICRO BUSINESS SYSTEMS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | SC093413 |
Giurisdizione | Scozia |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CRIFFEL MICRO BUSINESS SYSTEMS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova CRIFFEL MICRO BUSINESS SYSTEMS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Campsie House 4 Lister Way Hamilton International Technology Park, Blantyre G72 0FT Glasgow Scotland |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CRIFFEL MICRO BUSINESS SYSTEMS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
EDGEBAR LIMITED | 22 mag 1985 | 22 mag 1985 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CRIFFEL MICRO BUSINESS SYSTEMS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per CRIFFEL MICRO BUSINESS SYSTEMS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Scissione delle azioni al 21 dic 2021 | 4 pagine | SH02 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Stato del capitale al 29 dic 2021
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 giu 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 giu 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Alan Smith il 11 giu 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr David Lewis Mcglennon il 11 giu 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Notifica di Daisy Telecoms Limited come persona con controllo significativo il 28 mar 2019 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione di Daisy It Computer Group (Scotland) Limited come persona con controllo significativo il 28 mar 2019 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Lewis Mcglennon come segretario in data 01 feb 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nathan Richard Marke come amministratore in data 01 feb 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr David Lewis Mcglennon come amministratore in data 22 giu 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Neil Keith Muller come amministratore in data 22 giu 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 giu 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CRIFFEL MICRO BUSINESS SYSTEMS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGLENNON, David Lewis | Amministratore | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Lindred House Lancashire England | United Kingdom | British | Company Director | 181536600001 | ||||
SMITH, Stephen Alan | Amministratore | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Lindred House Lancashire England | United Kingdom | British | Company Director | 161471940001 | ||||
MACDONALD, Jean | Segretario | 178 Annan Road DG1 3HA Dumfries Dumfriesshire | British | 30994900001 | ||||||
MARTIN, William Thomas | Segretario | Weavers Wainhill OX39 4AB Chinnor Oxfordshire | British | Solicitor | 57302660001 | |||||
MCCLUNE, James Smith | Segretario | 6 Beechgrove DG11 2QS Lockerbie Dumfriesshire | British | 840960001 | ||||||
MCGLENNON, David Lewis | Segretario | Lindred Road Business Park Nelson BB9 5SR Lancashire Daisy House England England | 199438680001 | |||||||
MCKEAN, William Stewart | Segretario | Isla Cottage Springholm DG7 3LP Castle Douglas Kirkcudbrightshire | British | 361660001 | ||||||
ROBSON, Donald Brian | Segretario | Woodlea Holland Bush Hightae DG11 1JL Lockerbie Dumfriesshire | British | 66509430001 | ||||||
STOKES, Reeta | Segretario | Technology Avenue Hamilton International Technology G72 0HT Park, Blantyre Icm House, Glasgow, Lanarkshire | 173997620001 | |||||||
TOULMIN-VAN SITTERT, Dirk Johannes | Segretario | The Lakes Bedford Road NN4 7HD Northampton Lakeside House Northamptonshire England | 179708550001 | |||||||
WRAGG, Keith | Segretario | 80 Slayley View Road Barlborough S43 4WU Chesterfield Derbyshire | British | Chartered Accountant | 50768630002 | |||||
AIKMAN, Elizabeth Jane | Amministratore | The Lakes NN4 7HD Northampton Lakeside House England | England | British | Director | 294355310001 | ||||
AIRLEY, Linda | Amministratore | Avielochan Corstorphine Road DG3 5NB Thornhill Dumfriesshire | British | Company Director | 30994880002 | |||||
BARRON, Douglas John | Amministratore | 1 Nunholm Place DG1 1JR Dumfries Dumfriesshire Scotland | United Kingdom | British | Company Director | 1392360001 | ||||
CLUTTON, Steven | Amministratore | Technology Avenue Hamilton International Technology G72 0HT Park, Blantyre Icm House, Glasgow, Lanarkshire | United Kingdom | British | Director | 158269660001 | ||||
COURTLEY, David John | Amministratore | Hunsbury Hill Avenue NN4 8QS Northampton Technology House Northamptonshire England | England | British | Director | 141213480001 | ||||
FARROW, Matthew James | Amministratore | 34 Lychgate Close LE10 2ES Burbage Leicestershire | England | British | Finance Director | 194105960001 | ||||
JOHNSTON, Keith Alexander | Amministratore | Allanton Mill Auldgirth DG2 0UB Dumfries Dumfriesshire | British | Company Director | 361670001 | |||||
JOHNSTONE, Shirley Jane | Amministratore | Allanton Mill Auldgirth DG2 0UB Dumfries Dumfriesshire | British | Company Director | 361680002 | |||||
MACDONALD, Jean | Amministratore | 178 Annan Road DG1 3HA Dumfries Dumfriesshire | British | Company Secretary | 30994900001 | |||||
MARKE, Nathan Richard | Amministratore | Lindred Road Business Park Nelson BB9 5SR Lancashire Daisy House England England | United Kingdom | British | Company Director | 194292450001 | ||||
MARTIN, William Thomas | Amministratore | Weavers Wainhill OX39 4AB Chinnor Oxfordshire | United Kingdom | British | Director | 57302660001 | ||||
MULLER, Neil Keith | Amministratore | Lindred Road Business Park Nelson BB9 5SR Lancashire Daisy House England England | England | British | Company Director | 252490400001 | ||||
RILEY, Matthew Robinson | Amministratore | Lindred Road Business Park Nelson BB9 5SR Lancashire Daisy House England England | United Kingdom | British | Company Director | 178585250001 | ||||
ROBINSON, Nicholas John | Amministratore | Technology Avenue Hamilton International Technology G72 0HT Park, Blantyre Icm House, Glasgow, Lanarkshire | United Kingdom | British | Company Director | 54873290006 | ||||
ROBINSON, Nicholas | Amministratore | 1 Wethered Road SL7 2BH Marlow Buckinghamshire | British | Director | 54873290005 | |||||
ROBSON, Donald Brian | Amministratore | Woodlea Holland Bush Hightae DG11 1JL Lockerbie Dumfriesshire | British | Financial Director | 66509430001 | |||||
SIMPSON, David Alan | Amministratore | Draycott Cottage Draycott Lane WR5 3NY Kempsey Worcestershire | England | British | Group Finance Director | 80817560001 | ||||
SMITH, William Joe | Amministratore | Belstead Old Rectory Copdock IP8 3JS Ipswich Suffolk | England | British | Company Director | 20327120001 | ||||
TOULMIN-VAN SITTERT, Dirk Johannes | Amministratore | The Lakes Bedford Road NN4 7HD Northampton Lakeside House Northamptonshire England | England | British | Director | 180239190001 | ||||
WRAGG, Keith | Amministratore | 80 Slayley View Road Barlborough S43 4WU Chesterfield Derbyshire | British | Chartered Accountant | 50768630002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CRIFFEL MICRO BUSINESS SYSTEMS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daisy Telecoms Limited | 28 mar 2019 | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Daisy It Computer Group (Scotland) Limited | 06 apr 2016 | 4 Lister Way Hamilton International Technology Park, Blantyre G72 0FT Glasgow Campsie House Scotland | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
CRIFFEL MICRO BUSINESS SYSTEMS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Floating charge | Creato il 30 lug 1985 Consegnato il 09 ago 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari The whole assets of the company. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0