GRANITE COUNTRY GROUP LIMITED

GRANITE COUNTRY GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGRANITE COUNTRY GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC100976
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GRANITE COUNTRY GROUP LIMITED?

    • Allevamento di bovini da latte (01410) / Agricoltura, silvicultura e pesca
    • Allevamento di pollame (01470) / Agricoltura, silvicultura e pesca

    Dove si trova GRANITE COUNTRY GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GRANITE COUNTRY GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GRAMPIAN COUNTRY FOOD GROUP LIMITED22 set 198622 set 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di GRANITE COUNTRY GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 nov 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per GRANITE COUNTRY GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    legacy

    4 pagineMG05s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    Bilancio annuale redatto al 09 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 dic 2011

    Stato del capitale al 28 dic 2011

    • Capitale: GBP 58,381,015
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 nov 2010

    8 pagineAA

    Bilancio redatto al 30 nov 2009

    20 pagineAA

    Varie

    Section 519
    1 pagineMISC

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Varie

    AA03
    2 pagineMISC

    Varie

    Auditors resignation
    1 pagineMISC

    Bilancio annuale redatto al 09 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 nov 2008

    24 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mag 2007

    37 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di GRANITE COUNTRY GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    Segretario
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    119967690001
    DUNCAN, Alfred John
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish402690001
    IAIN SMITH AND COMPANY
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    Segretario
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    93547510001
    BARNES, Richard Garth
    Whistler House Green North
    Warborough
    OX10 7DW Wallingford
    Oxfordshire
    Amministratore
    Whistler House Green North
    Warborough
    OX10 7DW Wallingford
    Oxfordshire
    British46366230001
    BENNET, Gordon Iain
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Amministratore
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    British119604660001
    BENZIE, Alan Athol Emslie
    Oakbarn, Higher House Farm
    Hocker Lane
    SK10 4SD Over Alderley
    Cheshire
    Amministratore
    Oakbarn, Higher House Farm
    Hocker Lane
    SK10 4SD Over Alderley
    Cheshire
    EnglandBritish83412170001
    CARNEY, Joseph Gerard
    18 Devonshire Road
    HA1 4LR Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    18 Devonshire Road
    HA1 4LR Harrow
    Middlesex
    United KingdomIrish89273480001
    FYFE, Archibald
    8 Turin Way
    Foveran
    AB41 6HG Ellon
    Aberdeenshire
    Amministratore
    8 Turin Way
    Foveran
    AB41 6HG Ellon
    Aberdeenshire
    British957330003
    GILBERT, Martin James
    17 Rubislaw Den North
    AB15 4AL Aberdeen
    Amministratore
    17 Rubislaw Den North
    AB15 4AL Aberdeen
    ScotlandBritish48820002
    HOPLEY, Philip Thomas
    Greenmoss Farmhouse
    Castle Fraser
    AB51 7LB Aberdeenshire
    Amministratore
    Greenmoss Farmhouse
    Castle Fraser
    AB51 7LB Aberdeenshire
    British957150007
    IMRAY, Iain Murray
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish63444910001
    JOHNSON, Peter George
    41 Lingfield Road
    Wimbledon
    SW19 4PZ London
    Amministratore
    41 Lingfield Road
    Wimbledon
    SW19 4PZ London
    British34190650001
    LIND, John
    Overton Of Keithfield
    AB41 0EU Methlick
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Overton Of Keithfield
    AB41 0EU Methlick
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish515220001
    MACKIE, Grant Stephen
    First Floor
    15 Leven Terrace
    AB3 9LW Edinburgh
    Lothian
    Amministratore
    First Floor
    15 Leven Terrace
    AB3 9LW Edinburgh
    Lothian
    British143161970001
    MILNE, Kevin Dawson
    Heathcot
    1 Culter House Road
    AB13 0EN Milltimber
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Heathcot
    1 Culter House Road
    AB13 0EN Milltimber
    Aberdeenshire
    ScotlandScottish66083160001
    MONK, Paul John
    White Place
    River Road Taplow
    SL6 0BG Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    White Place
    River Road Taplow
    SL6 0BG Maidenhead
    Berkshire
    British71562530002
    PARIS, Walter Walker
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    Amministratore
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    British338220001
    PARTINGTON, Roger Evans
    The Peppers
    Mustard Lane
    RG4 6GH Sonning On Thames
    Berkshire
    Amministratore
    The Peppers
    Mustard Lane
    RG4 6GH Sonning On Thames
    Berkshire
    United KingdomBritish14091850003
    PEARCE, Anthony Michael
    Timbers Combe
    Carlton Road, South Godstone
    RH9 8LG Godstone
    Surrey
    Amministratore
    Timbers Combe
    Carlton Road, South Godstone
    RH9 8LG Godstone
    Surrey
    British15241750002
    POWER, Eddie
    Kincora Lodge
    Brennanston Road
    IRISH Carrackmines
    County Dublin 18
    Ireland
    Amministratore
    Kincora Lodge
    Brennanston Road
    IRISH Carrackmines
    County Dublin 18
    Ireland
    IrelandIrish98491380001
    SALKELD, David John
    The Old Hall Back Lane
    Bramham
    LS23 6QR Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Old Hall Back Lane
    Bramham
    LS23 6QR Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish111995510001
    SMITH, Malcolm
    Old Hall
    Rockcliffe
    CA6 4BL Carlisle
    Cumbria
    Amministratore
    Old Hall
    Rockcliffe
    CA6 4BL Carlisle
    Cumbria
    United KingdomBritish93227360001
    STEPHEN, Andrew Michael Duthie
    Speymuir 3 Victoria Street
    AB53 4RE Turriff
    Aberdeenshire
    Scotland
    Amministratore
    Speymuir 3 Victoria Street
    AB53 4RE Turriff
    Aberdeenshire
    Scotland
    ScotlandBritish338210001
    TOCHER, Henry John
    17 Cliff Park
    Cults
    AB15 9JT Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    17 Cliff Park
    Cults
    AB15 9JT Aberdeen
    Aberdeenshire
    British2581920001
    WALLIS, David William
    Low Garth Church Lane
    Collingham
    LS22 5AU Wetherby
    England
    Amministratore
    Low Garth Church Lane
    Collingham
    LS22 5AU Wetherby
    England
    EnglandBritish48299920002
    WHITTAKER, Thomas Geoffrey
    6 Beresford House
    Palace Terrace
    IM2 4NE Douglas
    Isle Of Man
    Amministratore
    6 Beresford House
    Palace Terrace
    IM2 4NE Douglas
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish43919360002
    WITHAM, David Peter
    6 Heatherside Gardens
    SL2 3RR Farnham Common
    Buckinghamshire
    Amministratore
    6 Heatherside Gardens
    SL2 3RR Farnham Common
    Buckinghamshire
    EnglandBritish97409950001

    GRANITE COUNTRY GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 09 giu 2008
    Consegnato il 17 giu 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Land and buildings at old hall farm, attleborough, norfolk.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 17 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Legal charge
    Creato il 30 mag 2008
    Consegnato il 10 giu 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Land and buildings on east side of old buckenham road, attleborough, norfolk.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 07 mag 2008
    Consegnato il 14 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects at badentoy, portlethen KNC2009.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 07 mag 2008
    Consegnato il 14 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Land at burnhouse industrial estate, whitburn.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 07 mag 2008
    Consegnato il 14 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Ground at main street kinglassie.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 07 mag 2008
    Consegnato il 14 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects to the southside of oakbank road, east calder in the county of midlothian.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 07 mag 2008
    Consegnato il 14 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects at tannery street, banff.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 07 mag 2008
    Consegnato il 14 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects at mugiemoss road, bucksburn, aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Legal charge
    Creato il 02 mag 2008
    Consegnato il 08 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due all sums due or to become due
    Brevi particolari
    Hendall wood, lying to the west side of the A26 road, buxted east sussex ESX202801.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Legal charge
    Creato il 02 mag 2008
    Consegnato il 08 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    North east side of dewsbury road, ossett & land at warneford avenue, ossett WYK703096 WYK226999 WYK218832.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 mag 2008
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Floating charge
    Creato il 29 mag 2007
    Consegnato il 13 giu 2007
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 13 giu 2007Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 08 ago 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (MG05s)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Floating charge
    Creato il 29 mag 2007
    Consegnato il 13 giu 2007
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 13 giu 2007Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Bond & floating charge
    Creato il 07 dic 1998
    Consegnato il 24 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 28 lug 1998
    Consegnato il 14 ago 1998
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transazioni
    • 14 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 17 ago 1998Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 13 giu 2007Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Shares mortgage
    Creato il 31 ott 1997
    Consegnato il 14 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transazioni
    • 14 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Shares pledge
    Creato il 31 ott 1997
    Consegnato il 14 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transazioni
    • 14 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 31 ott 1997
    Consegnato il 14 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transazioni
    • 14 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Assignation in security
    Creato il 29 apr 1997
    Consegnato il 08 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    (Assignation of book debt) policies of assurance.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transazioni
    • 08 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Shares mortgage
    Creato il 23 ago 1996
    Consegnato il 06 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All shares and dividends.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent and Trustee for Others
    Transazioni
    • 06 set 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 05 ott 1990
    Consegnato il 22 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Canadian Imperial Bank of Commerce for Itself and as Agent and Trustee
    Transazioni
    • 22 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 21 ott 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Bond & floating charge
    Creato il 01 lug 1988
    Consegnato il 13 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Canadian Imperial Bank of Commerce as Agent and Trustee for Itself & Others
    Transazioni
    • 13 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 08 giu 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Bond & floating charge
    Creato il 01 lug 1988
    Consegnato il 12 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Canadian Imperial Bank of Commerce as Agent and Trustee for Itself & Others
    Transazioni
    • 12 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0