SKELLY'S LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SKELLY'S LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC105552 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SKELLY'S LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova SKELLY'S LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | c/o WRIGHT, JOHNSTON & MACKENZIE LLP 302 St. Vincent Street G2 5RZ Glasgow Scotland |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SKELLY'S LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| IAN SKELLY (MANCHESTER) LIMITED | 09 nov 1987 | 09 nov 1987 |
| PACIFIC SHELF 125 LIMITED | 07 lug 1987 | 07 lug 1987 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SKELLY'S LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per SKELLY'S LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 27 lug 2020
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
legacy | 49 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE1 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Matthew Bishop come amministratore in data 01 gen 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr David John Muir come amministratore in data 01 gen 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
legacy | 44 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE1 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
legacy | 49 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE1 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
legacy | 51 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 pagine | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE1 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SKELLY'S LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINCH, Mark | Segretario | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | 175766960001 | |||||||
| FINCH, Mark Charles | Amministratore | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 175612870001 | |||||
| MUIR, David John | Amministratore | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | England | British | 254017640001 | |||||
| HOUSTON, David Oliver | Segretario | 3 Eden Park Castlepark Bothwell G71 3NW Glasgow | British | 75910100001 | ||||||
| MACNAMARA, Richard James | Segretario | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | 149324740001 | |||||||
| MAHAFFEY, Matthew Ian | Segretario | 23 St Oswalds Road Fulford YO1 4PF York North Yorkshire | British | 507940001 | ||||||
| WARD, Andrew Ian | Segretario | 6 Coniston Way LS22 6TT Wetherby West Yorkshire | British | 360770001 | ||||||
| WATSON, Deirdre Mary Alison | Segretario | 51 Park Avenue Hutton CM13 2QP Brentwood Essex | Uk | 74385360001 | ||||||
| MATHESON & CO LIMITED | Segretario | 3 Lombard Street EC3V 9AQ London | 1947590001 | |||||||
| ATKIN, John Richard | Amministratore | Baillie Gate Queens Drive LS29 9QW Ilkley West Yorkshire | British | 20102900001 | ||||||
| ATKIN, John Richard | Amministratore | Baillie Gate Queens Drive LS29 9QW Ilkley West Yorkshire | British | 20102900001 | ||||||
| BEATTIE, Craig Alan | Amministratore | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 177627900001 | |||||
| BEYNON, Peter | Amministratore | Stonehurst Elm Lane Copdock IP8 3ET Ipswich Suffolk | England | British | 38504390006 | |||||
| BISHOP, Matthew | Amministratore | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 206755450002 | |||||
| CHAMBERS, Paul Jonathan | Amministratore | 24 Constable Road Ben Rhydding LS29 8RW Ilkley West Yorkshire | British | 1188140001 | ||||||
| HEALEY, Derek John | Amministratore | 5 Tudor Court Prince Of Wales Mansions HG1 1JB Harrogate North Yorkshire | British | 46399230001 | ||||||
| HERBERT, Mark Philip | Amministratore | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | England | British | 123285980005 | |||||
| HOPE, John Alexander | Amministratore | Riverside,5 School Brae EH4 6JN Edinburgh Midlothian | British | 71318590002 | ||||||
| HOUSTON, David Oliver | Amministratore | 3 Eden Park Castlepark Bothwell G71 3NW Glasgow | British | 75910100001 | ||||||
| HOUSTON, Samuel George | Amministratore | Flat 59 Medland House 11 Branch Road E14 7JT London | British | 75730290003 | ||||||
| JONES, Alun Morton | Amministratore | Fen Walk IP12 4BG Woodbridge Fen House Suffolk United Kingdom | United Kingdom | British | 12785600004 | |||||
| MACNAMARA, Richard James | Amministratore | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 149294820002 | |||||
| O'DONNELL, Joseph Peter | Amministratore | 5 Brodie Park Avenue PA2 6JH Paisley Renfrewshire | British | 18421870001 | ||||||
| POTTS, Derek | Amministratore | 55 East Street Coggeshall CO6 1SJ Colchester Essex | United Kingdom | British | 52485510001 | |||||
| RITCHIE, John Muir | Amministratore | High House Snipe Farm Road IP13 6SL Clopton Suffolk | British | 22325820001 | ||||||
| SKELLY, Ian Barr | Amministratore | Leewood House ML11 9JA Lanark | United Kingdom | British | 9845580001 | |||||
| SKELLY, Margaret Richmond | Amministratore | Leewood House ML11 9JA Lanarkshire | British | 548730001 | ||||||
| STUART, John Morris | Amministratore | Cromdale 26 Foxglove Avenue LS8 2QR Leeds West Yorkshire | British | 507950001 | ||||||
| WATSON, Deirdre Mary Alison | Amministratore | 51 Park Avenue Hutton CM13 2QP Brentwood Essex | England | Uk | 74385360001 | |||||
| WILLIAMS, Steven Wyn | Amministratore | 199 Finchampstead Road RG40 3HE Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | 54580940001 | |||||
| WILLIAMSON, Michael Granville | Amministratore | Church Green Old Church Lane Pateley Bridge HG3 5LZ Harrogate North Yorkshire | British | 57360160001 | ||||||
| WITT, John Raymond | Amministratore | 28 Westerfield Road IP4 2YJ Ipswich Suffolk | Canadian | 51303670001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SKELLY'S LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Skelly Group Limited | 06 apr 2016 | 302 St Vincent Street G2 5RZ Glasgow C/O Wright, Johnston & Mackenzie Llp Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
SKELLY'S LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Assignation in security | Creato il 17 gen 1991 Consegnato il 27 gen 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari All refund of monies paid to vag united kingdom limited. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Bond & floating charge | Creato il 06 mar 1989 Consegnato il 22 mar 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari The whole assets of the company. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 21 ott 1988 Consegnato il 27 ott 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Agreement for lease in respect of premises at every st, manchester. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0