SCT CELLULAR LIMITED
Panoramica
Nome della società | SCT CELLULAR LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | SC106314 |
Giurisdizione | Scozia |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SCT CELLULAR LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova SCT CELLULAR LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Lochside House 7 Lochside Avenue Edinburgh Park EH12 9DJ Edinburgh Scotland Scotland |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SCT CELLULAR LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
PINNACLE CELLULAR LIMITED | 11 set 1987 | 11 set 1987 |
ARTLEN LIMITED | 28 ago 1987 | 28 ago 1987 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SCT CELLULAR LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per SCT CELLULAR LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Stato del capitale al 18 apr 2012
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 feb 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 feb 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Joanne Sarah Finch come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Richard Wolfgang Henry Schäfer come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christian Allen come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Thomas Nowak come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Martin John Purkess il 01 lug 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 feb 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Memorandum e Statuto | 30 pagine | MA | ||||||||||
Dichiarazione degli oggetti sociali | 2 pagine | CC04 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Lomond House 9 George Square Glasgow G2 1QQ in data 22 dic 2009 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Thomas Nowak il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Christian Philip Quentin Allen il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Martin Purkess il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SCT CELLULAR LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAWE-LANE, Patrick John Beachim | Segretario | Marsh Lane Rowde SN10 1RE Devizes Upper Foxhangers Farm Wiltshire England | Other | 130771170001 | ||||||
FINCH, Joanne Sarah | Amministratore | 7 Lochside Avenue Edinburgh Park EH12 9DJ Edinburgh Lochside House Scotland Scotland | United Kingdom | British | Senior Finance Manager | 158146620001 | ||||
PURKESS, Martin John | Amministratore | 7 Lochside Avenue Edinburgh Park EH12 9DJ Edinburgh Lochside House Scotland Scotland | England | British | Director | 139360020001 | ||||
SCHÄFER, Richard Wolfgang Henry | Amministratore | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Head Of Finance Technology & Support | 158146600001 | ||||
BALCHIN, Mark Nicholas | Segretario | 6 Fleming Close GU14 8BT Farnborough Hampshire | British | 812680001 | ||||||
COX, Homersham Martin | Segretario | Littlewood Park View Buxted TN22 4LS Uckfield East Sussex | British | Director | 1058000001 | |||||
EMETULU, Lola | Segretario | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 88619360002 | ||||||
JEFFERSON, Karen | Segretario | 8 Bailey Close SN9 5HU Pewsey Wiltshire | British | 79393480001 | ||||||
LAFFERTY, Gerard | Segretario | 18 Coney Park FK7 9LU Stirling Stirlingshire | British | 281740001 | ||||||
SCOTT, Stephen Roy | Segretario | Bracken House Bunces Shaw Farley Hill RG7 1UU Reading Berkshire | British | 25660590003 | ||||||
ALLEN, Christian Philip Quentin | Amministratore | 7 Lochside Avenue Edinburgh Park EH12 9DJ Edinburgh Lochside House Scotland Scotland | British | Director | 123612980001 | |||||
BALCHIN, Mark Nicholas | Amministratore | 6 Fleming Close GU14 8BT Farnborough Hampshire | Uk | British | Accountant | 812680001 | ||||
BREWER, Stephen | Amministratore | Flat 10 Rushworth House Enborne Lodge Lane RG14 6RH Newbury Berkshire | British | Company Director | 79186090002 | |||||
BROCKLEHURST, Nigel | Amministratore | 1 The Hollyhocks Reading Road, Harwell OX11 0LX Didcot Oxfordshire | British | Director | 83126790001 | |||||
CARDELL, Michael Southwell | Amministratore | 26 Scotts Avenue BR2 0LQ Bromley Kent | England | British | Director | 34712930001 | ||||
CHESWORTH, Paul | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | Director | 99525280001 | |||||
COX, Homersham Martin | Amministratore | Littlewood Park View Buxted TN22 4LS Uckfield East Sussex | British | Director | 1058000001 | |||||
DIPRE, Paul Vincent | Amministratore | Junta Waterhouse Lane KT20 6HT Kingswood Surrey | British | Company Director | 3747590001 | |||||
DIPRE, Remo | Amministratore | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 35117250001 | ||||
EVANS, Mark | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | Chief Financial Officer | 127017870001 | |||||
HALFORD, Andrew Nigel | Amministratore | The Oxdrove House Burghclere RG20 9HJ Newbury Berkshire | British | Director | 33951180005 | |||||
HANFORD, Raymond Clifford | Amministratore | Romney Cottage Park Horsley East Horsley KT24 5RZ Leatherhead Surrey | United Kingdom | British | Accountant | 45868080001 | ||||
HERROD, Harry Alan | Amministratore | Dakar, 40 Camelon Road FK1 5SH Falkirk | British | Sales Manager | 93998280001 | |||||
JONES, David Leslie | Amministratore | Three Oak Barn RH14 0PY Plaistow West Sussex | British | Director | 83517310001 | |||||
LAFFERTY, Gerard | Amministratore | 18 Coney Park FK7 9LU Stirling Stirlingshire | British | Chartered Accountant | 281740001 | |||||
LANGSTON, Edward | Amministratore | 23 Manilla Road Clifton BS8 4EB Bristol Avon | Uk | British | Director | 24471140001 | ||||
LEE, Simon Christopher | Amministratore | Moorlands Harrow Road West RH4 3BH Dorking Surrey | United Kingdom | British | Director | 86697870001 | ||||
LEE, Simon Christopher | Amministratore | Moorlands Harrow Road West RH4 3BH Dorking Surrey | United Kingdom | British | Director | 86697870001 | ||||
MCNEILL, Ronald | Amministratore | 32 Drummond Place EH3 6PW Edinburgh Midlothian | British | Corporate Adviser | 205550001 | |||||
NOWAK, Thomas, Dr | Amministratore | 7 Lochside Avenue Edinburgh Park EH12 9DJ Edinburgh Lochside House Scotland Scotland | United Kingdom | German | Director | 174443800001 | ||||
READ, Nicholas Jonathan | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Company Director | 87149560001 | ||||
TOURNON, Emanuele | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | Italian | Director | 103542080002 | ||||
TOWNSEND, John Raymond | Amministratore | Knowle House Chapel Corner Hamstead Marshall RG20 0HP Newbury Berkshire | British | Director | 95223480001 | |||||
WALKER, Allan Ronald | Amministratore | Highfield House Falkirk Road EH49 7SF Linlithgow West Lothian | United Kingdom | British | Sales Manager | 106150070001 | ||||
WEBB, Denys William | Amministratore | Oakfield Stud Whitemoor Lane, Upper Basildon RG8 8SF Reading Berkshire | United Kingdom | British | Director | 76074580001 |
SCT CELLULAR LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Floating charge | Creato il 28 apr 1992 Consegnato il 08 mag 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 15 giu 1989 Consegnato il 30 giu 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Bond & floating charge | Creato il 16 ott 1987 Consegnato il 28 ott 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari The whole assets of the company. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0