SCT CELLULAR LIMITED

SCT CELLULAR LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSCT CELLULAR LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC106314
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SCT CELLULAR LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova SCT CELLULAR LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Lochside House 7 Lochside Avenue
    Edinburgh Park
    EH12 9DJ Edinburgh
    Scotland
    Scotland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SCT CELLULAR LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PINNACLE CELLULAR LIMITED11 set 198711 set 1987
    ARTLEN LIMITED28 ago 198728 ago 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di SCT CELLULAR LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per SCT CELLULAR LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Stato del capitale al 18 apr 2012

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Joanne Sarah Finch come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Richard Wolfgang Henry Schäfer come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Christian Allen come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Thomas Nowak come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    6 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Martin John Purkess il 01 lug 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Memorandum e Statuto

    30 pagineMA

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Indirizzo della sede legale modificato da Lomond House 9 George Square Glasgow G2 1QQ in data 22 dic 2009

    1 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per Thomas Nowak il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christian Philip Quentin Allen il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Martin Purkess il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di SCT CELLULAR LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DAWE-LANE, Patrick John Beachim
    Marsh Lane
    Rowde
    SN10 1RE Devizes
    Upper Foxhangers Farm
    Wiltshire
    England
    Segretario
    Marsh Lane
    Rowde
    SN10 1RE Devizes
    Upper Foxhangers Farm
    Wiltshire
    England
    Other130771170001
    FINCH, Joanne Sarah
    7 Lochside Avenue
    Edinburgh Park
    EH12 9DJ Edinburgh
    Lochside House
    Scotland
    Scotland
    Amministratore
    7 Lochside Avenue
    Edinburgh Park
    EH12 9DJ Edinburgh
    Lochside House
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritishSenior Finance Manager158146620001
    PURKESS, Martin John
    7 Lochside Avenue
    Edinburgh Park
    EH12 9DJ Edinburgh
    Lochside House
    Scotland
    Scotland
    Amministratore
    7 Lochside Avenue
    Edinburgh Park
    EH12 9DJ Edinburgh
    Lochside House
    Scotland
    Scotland
    EnglandBritishDirector139360020001
    SCHÄFER, Richard Wolfgang Henry
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishHead Of Finance Technology & Support158146600001
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    Segretario
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    British812680001
    COX, Homersham Martin
    Littlewood Park View
    Buxted
    TN22 4LS Uckfield
    East Sussex
    Segretario
    Littlewood Park View
    Buxted
    TN22 4LS Uckfield
    East Sussex
    BritishDirector1058000001
    EMETULU, Lola
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Segretario
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British88619360002
    JEFFERSON, Karen
    8 Bailey Close
    SN9 5HU Pewsey
    Wiltshire
    Segretario
    8 Bailey Close
    SN9 5HU Pewsey
    Wiltshire
    British79393480001
    LAFFERTY, Gerard
    18 Coney Park
    FK7 9LU Stirling
    Stirlingshire
    Segretario
    18 Coney Park
    FK7 9LU Stirling
    Stirlingshire
    British281740001
    SCOTT, Stephen Roy
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    Segretario
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    British25660590003
    ALLEN, Christian Philip Quentin
    7 Lochside Avenue
    Edinburgh Park
    EH12 9DJ Edinburgh
    Lochside House
    Scotland
    Scotland
    Amministratore
    7 Lochside Avenue
    Edinburgh Park
    EH12 9DJ Edinburgh
    Lochside House
    Scotland
    Scotland
    BritishDirector123612980001
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    Amministratore
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    UkBritishAccountant812680001
    BREWER, Stephen
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    BritishCompany Director79186090002
    BROCKLEHURST, Nigel
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    Amministratore
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    BritishDirector83126790001
    CARDELL, Michael Southwell
    26 Scotts Avenue
    BR2 0LQ Bromley
    Kent
    Amministratore
    26 Scotts Avenue
    BR2 0LQ Bromley
    Kent
    EnglandBritishDirector34712930001
    CHESWORTH, Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    BritishDirector99525280001
    COX, Homersham Martin
    Littlewood Park View
    Buxted
    TN22 4LS Uckfield
    East Sussex
    Amministratore
    Littlewood Park View
    Buxted
    TN22 4LS Uckfield
    East Sussex
    BritishDirector1058000001
    DIPRE, Paul Vincent
    Junta
    Waterhouse Lane
    KT20 6HT Kingswood
    Surrey
    Amministratore
    Junta
    Waterhouse Lane
    KT20 6HT Kingswood
    Surrey
    BritishCompany Director3747590001
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director35117250001
    EVANS, Mark
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    BritishChief Financial Officer127017870001
    HALFORD, Andrew Nigel
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    BritishDirector33951180005
    HANFORD, Raymond Clifford
    Romney Cottage Park Horsley
    East Horsley
    KT24 5RZ Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Romney Cottage Park Horsley
    East Horsley
    KT24 5RZ Leatherhead
    Surrey
    United KingdomBritishAccountant45868080001
    HERROD, Harry Alan
    Dakar, 40 Camelon Road
    FK1 5SH Falkirk
    Amministratore
    Dakar, 40 Camelon Road
    FK1 5SH Falkirk
    BritishSales Manager93998280001
    JONES, David Leslie
    Three Oak Barn
    RH14 0PY Plaistow
    West Sussex
    Amministratore
    Three Oak Barn
    RH14 0PY Plaistow
    West Sussex
    BritishDirector83517310001
    LAFFERTY, Gerard
    18 Coney Park
    FK7 9LU Stirling
    Stirlingshire
    Amministratore
    18 Coney Park
    FK7 9LU Stirling
    Stirlingshire
    BritishChartered Accountant281740001
    LANGSTON, Edward
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    Amministratore
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    UkBritishDirector24471140001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritishDirector86697870001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritishDirector86697870001
    MCNEILL, Ronald
    32 Drummond Place
    EH3 6PW Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    32 Drummond Place
    EH3 6PW Edinburgh
    Midlothian
    BritishCorporate Adviser205550001
    NOWAK, Thomas, Dr
    7 Lochside Avenue
    Edinburgh Park
    EH12 9DJ Edinburgh
    Lochside House
    Scotland
    Scotland
    Amministratore
    7 Lochside Avenue
    Edinburgh Park
    EH12 9DJ Edinburgh
    Lochside House
    Scotland
    Scotland
    United KingdomGermanDirector174443800001
    READ, Nicholas Jonathan
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director87149560001
    TOURNON, Emanuele
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomItalianDirector103542080002
    TOWNSEND, John Raymond
    Knowle House
    Chapel Corner Hamstead Marshall
    RG20 0HP Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Knowle House
    Chapel Corner Hamstead Marshall
    RG20 0HP Newbury
    Berkshire
    BritishDirector95223480001
    WALKER, Allan Ronald
    Highfield House
    Falkirk Road
    EH49 7SF Linlithgow
    West Lothian
    Amministratore
    Highfield House
    Falkirk Road
    EH49 7SF Linlithgow
    West Lothian
    United KingdomBritishSales Manager106150070001
    WEBB, Denys William
    Oakfield Stud
    Whitemoor Lane, Upper Basildon
    RG8 8SF Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Oakfield Stud
    Whitemoor Lane, Upper Basildon
    RG8 8SF Reading
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector76074580001

    SCT CELLULAR LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Floating charge
    Creato il 28 apr 1992
    Consegnato il 08 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Svenska Handelsbanken
    Transazioni
    • 08 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 24 mag 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • 24 mag 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • 07 giu 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Debenture
    Creato il 15 giu 1989
    Consegnato il 30 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Svenska Handelsbanken
    Transazioni
    • 30 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 24 mag 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • 24 mag 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 16 ott 1987
    Consegnato il 28 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The whole assets of the company.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 05 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0