MAINSTREAM (HOLDINGS) LIMITED

MAINSTREAM (HOLDINGS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMAINSTREAM (HOLDINGS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC107209
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MAINSTREAM (HOLDINGS) LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova MAINSTREAM (HOLDINGS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    16 Charlotte Square
    Edinburgh
    EH2 4DF
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MAINSTREAM (HOLDINGS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EWOS (ALNESS) LIMITED05 lug 200405 lug 2004
    AQUASCOT GROUP LIMITED27 giu 199527 giu 1995
    AQUASCOT MARKETING LIMITED19 ott 198719 ott 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di MAINSTREAM (HOLDINGS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per MAINSTREAM (HOLDINGS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 14 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 mar 2011

    Stato del capitale al 14 mar 2011

    • Capitale: GBP 438,812
    SH01

    Nomina di Mr Douglas Low come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Roger Dart come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr John Alexander Christie come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Tarald Sivertsen come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Geir Sjaastad come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di William Young come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 dic 2009

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 dic 2008

    16 pagineAA

    Nomina di Roger John Dart come segretario

    2 pagineAP03

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Bilancio redatto al 30 dic 2007

    15 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di MAINSTREAM (HOLDINGS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CHRISTIE, John Alexander
    Maxwell Street
    EH10 5HT Edinburgh
    23/16
    Scotland
    Segretario
    Maxwell Street
    EH10 5HT Edinburgh
    23/16
    Scotland
    154184170001
    HOMBLE, Synne
    N-0491
    Oslo
    Solligrenda 11
    Norway
    Amministratore
    N-0491
    Oslo
    Solligrenda 11
    Norway
    NorwayNorwegian131062490001
    LOW, Douglas Robert Duncan
    16 Charlotte Square
    Edinburgh
    EH2 4DF
    Amministratore
    16 Charlotte Square
    Edinburgh
    EH2 4DF
    ScotlandBritish108811280002
    CHRISTIE, John Alexander
    Maxwell Street
    EH10 5HT Edinburgh
    23/16
    Midlothian
    Segretario
    Maxwell Street
    EH10 5HT Edinburgh
    23/16
    Midlothian
    British140170170001
    DART, Roger John
    Craigie Crescent
    KW15 1EP Kirkwall
    4
    Orkney
    Segretario
    Craigie Crescent
    KW15 1EP Kirkwall
    4
    Orkney
    British146392500001
    MACKAY, Heather Florence
    Claddagh
    Achterneed
    IV14 9AA Strathpeffer
    Ross Shire
    Segretario
    Claddagh
    Achterneed
    IV14 9AA Strathpeffer
    Ross Shire
    British67953990002
    MURRAY, Robert Russell
    The Old Manse
    Fodderty
    IV14 9AB Strathpeffer
    Segretario
    The Old Manse
    Fodderty
    IV14 9AB Strathpeffer
    British67953970001
    OVERTON, Dennis Karl
    Braefoot Cottages
    Fodderty
    IV15 9UE Strathpeffer
    Segretario
    Braefoot Cottages
    Fodderty
    IV15 9UE Strathpeffer
    British80737760001
    STUART, Matthew Gordon
    11 Drummond Road
    IV2 4NA Inverness
    Inverness Shire
    Segretario
    11 Drummond Road
    IV2 4NA Inverness
    Inverness Shire
    British64033870001
    AGNEW, Keith Dalway
    White Gates
    West Moulin Road
    PH16 5EQ Pitlochry
    Perthshire
    Amministratore
    White Gates
    West Moulin Road
    PH16 5EQ Pitlochry
    Perthshire
    British45855000002
    FILS, Pierre Yves
    123 Rue De La Tour
    Paris
    France
    Amministratore
    123 Rue De La Tour
    Paris
    France
    French32799380001
    HERRERA, Luis Javier
    Vanskavaig Carness Road
    St Ola
    KW15 1UE Kirkwall
    Orkney
    Amministratore
    Vanskavaig Carness Road
    St Ola
    KW15 1UE Kirkwall
    Orkney
    Chilean98594970001
    LAWRIE, Charles Sharp
    Aniton House
    48 Rubislaw Den South
    AB2 6AX Aberdeen
    Amministratore
    Aniton House
    48 Rubislaw Den South
    AB2 6AX Aberdeen
    British41249220002
    MEAKIN, Nicholas St John
    Runcton House Lorraine Way
    Bramford
    IP8 4JA Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    Runcton House Lorraine Way
    Bramford
    IP8 4JA Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritish35721600001
    MORALES, Francisco Miranda
    36 Braemar, Clay Loan
    KW15 1QQ Kirkwall
    Orkney
    Amministratore
    36 Braemar, Clay Loan
    KW15 1QQ Kirkwall
    Orkney
    Chilean121143130001
    MURRAY, Robert Russell
    The Old Manse
    Fodderty
    IV14 9AB Strathpeffer
    Amministratore
    The Old Manse
    Fodderty
    IV14 9AB Strathpeffer
    United KingdomBritish67953970001
    MURRAY, Robert Russell
    The Old Manse
    Fodderty
    IV14 9AB Strathpeffer
    Amministratore
    The Old Manse
    Fodderty
    IV14 9AB Strathpeffer
    United KingdomBritish67953970001
    OVERTON, Dennis Karl
    The Braefoot
    Fodderty
    IV15 9UE Strathpeffer
    Ross Shire
    Amministratore
    The Braefoot
    Fodderty
    IV15 9UE Strathpeffer
    Ross Shire
    ScotlandBritish80737760001
    OVERTON, Dennis Karl
    Braefoot Cottages
    Fodderty
    IV15 9UE Strathpeffer
    Amministratore
    Braefoot Cottages
    Fodderty
    IV15 9UE Strathpeffer
    ScotlandBritish80737760001
    PALMER, Ronald Mackay
    Green Acres
    No 5 Knockfarrel
    IV15 9TQ Dingwall
    Ross Shire
    Amministratore
    Green Acres
    No 5 Knockfarrel
    IV15 9TQ Dingwall
    Ross Shire
    British49741450001
    PARRY, John
    Dundonnel
    IV23 2QU Garvie
    Ross-Shire
    Amministratore
    Dundonnel
    IV23 2QU Garvie
    Ross-Shire
    British1087410001
    PAYNE, James Gladstone
    Ardvar Lodge
    Drumbeg
    IV27 4NJ Lairg
    Sutherland
    Amministratore
    Ardvar Lodge
    Drumbeg
    IV27 4NJ Lairg
    Sutherland
    ScotlandBritish6196670001
    PHILLIPS, William Charles Henry
    Ivybank
    Bishopmill
    IV30 2DE Elgin
    Amministratore
    Ivybank
    Bishopmill
    IV30 2DE Elgin
    British454980001
    REEVE, Andrew James
    30 Vyner Place
    IV26 2XR Ullapool
    Amministratore
    30 Vyner Place
    IV26 2XR Ullapool
    British50186870002
    REX, Stepehen Charles
    Airor, St Martins,
    Cullicudden,By Culbokie,, Ross-Shire
    IV7 8JT By Dingwall
    Amministratore
    Airor, St Martins,
    Cullicudden,By Culbokie,, Ross-Shire
    IV7 8JT By Dingwall
    British97608220001
    SINCLAIR, Charles John
    51 Feddon Hill
    IV10 8SP Fortrose
    Ross Shire
    Scotland
    Amministratore
    51 Feddon Hill
    IV10 8SP Fortrose
    Ross Shire
    Scotland
    British50197000001
    SIVERTSEN, Tarald
    8286 Nordfold
    Norway
    Amministratore
    8286 Nordfold
    Norway
    NorwayNorwegian134255990001
    SJAASTAD, Geir
    C, 0587
    Oslo
    Fagerliveien 24
    Norway
    Amministratore
    C, 0587
    Oslo
    Fagerliveien 24
    Norway
    NorwayNorwegian133629360001
    SMITH, Philip
    Van Zuylen
    Van Nijevelstraat 102
    2242 At Wassenaar
    2242
    Netherlands
    Amministratore
    Van Zuylen
    Van Nijevelstraat 102
    2242 At Wassenaar
    2242
    Netherlands
    British73918640001
    SOUTER, William Graham
    Mid Clashdoran
    IV4 7AN Beauly
    Inverness-Shire
    Amministratore
    Mid Clashdoran
    IV4 7AN Beauly
    Inverness-Shire
    British4973520001
    STEIRO, Oystein
    Furstlia 15
    1367 Snaroya
    Norway
    Amministratore
    Furstlia 15
    1367 Snaroya
    Norway
    Norwegian81729570001
    STUART, Matthew Gordon
    11 Drummond Road
    IV2 4NA Inverness
    Inverness Shire
    Amministratore
    11 Drummond Road
    IV2 4NA Inverness
    Inverness Shire
    British64033870001
    TAIT, Michael Laurence
    1 Hayfield Court
    Commercial Street
    ZE1 0WN Lerwick
    Isle Of Shetland
    Amministratore
    1 Hayfield Court
    Commercial Street
    ZE1 0WN Lerwick
    Isle Of Shetland
    ScotlandBritish267768460002
    WHYTE, George Mccurrach Mcintosh
    Ruarach, Inverinate
    IV40 8HG Kyle
    Ross-Shire
    Amministratore
    Ruarach, Inverinate
    IV40 8HG Kyle
    Ross-Shire
    United KingdomBritish85024920001
    WILLIAMS, Peter Clifford
    13a Nelson Street
    EH3 6LF Edinburgh
    Amministratore
    13a Nelson Street
    EH3 6LF Edinburgh
    British47212810004

    MAINSTREAM (HOLDINGS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security
    Creato il 04 apr 1996
    Consegnato il 11 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Units 12, 13, 14 and 15 teaninich industrial estate, alness.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 23 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Marine mortgage
    Creato il 29 gen 1996
    Consegnato il 05 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    64 shares in the vessel "aqua-marra-lass".
    Persone aventi diritto
    • Nws Bank PLC
    Transazioni
    • 05 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 30 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 07 feb 1995
    Consegnato il 16 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fish farm at rhunahoarine point, kintyre, argyll.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 23 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 27 lug 1994
    Consegnato il 29 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Kellock Limited
    Transazioni
    • 29 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 13 giu 1995Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 08 gen 1996Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (419b)
    • 07 set 1998Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 02 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Floating charge
    Creato il 28 feb 1994
    Consegnato il 08 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Ross & Cromarty Enterprise Limited
    Transazioni
    • 08 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 12 giu 1995Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 08 gen 1996Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (419b)
    • 07 set 1998Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 25 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Standard security
    Creato il 03 set 1993
    Consegnato il 10 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Area of ground situated at rhunahoarine point, kintyre.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 10 set 1993Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 25 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 31 ago 1993
    Consegnato il 03 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 03 set 1993Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 15 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 21 ott 1989
    Consegnato il 26 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Highlands and Islands Development Board
    Transazioni
    • 26 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 12 giu 1995Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 08 gen 1996Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (419b)
    • 07 set 1998Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 25 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    • Ha modifiche ai divieti
    Bond & floating charge
    Creato il 03 giu 1988
    Consegnato il 14 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The whole assets of the company.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 12 giu 1995Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 08 gen 1996Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (419b)
    • 10 set 1998Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 23 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    • Ha modifiche ai divieti

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0