STIRLING MARINE LIMITED

STIRLING MARINE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTIRLING MARINE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC108613
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STIRLING MARINE LIMITED?

    • (6110) /

    Dove si trova STIRLING MARINE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Stirling & Gilmour
    Pavilion Court
    G81 1BL 45 Kilbowie Road, Clydebank
    Dunbartonshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STIRLING MARINE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    AIDEN SHIPPING COMPANY LIMITED07 mag 199207 mag 1992
    HARRISONS INTERNATIONAL LIMITED 02 ott 198902 ott 1989
    PACIFIC SHELF 150 LIMITED11 gen 198811 gen 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di STIRLING MARINE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per STIRLING MARINE LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per STIRLING MARINE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Verbale della riunione finale di liquidazione volontaria

    4 pagine4.26(Scot)

    Cessazione della carica di Richard Ryan come amministratore

    2 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    4 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    4 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 lug 2010

    Stato del capitale al 02 lug 2010

    • Capitale: GBP 334,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    12 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    11 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    12 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    14 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di STIRLING MARINE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ALAIS, Steven Morton
    9 Grays Inn Square
    WC1R 5JF London
    Segretario
    9 Grays Inn Square
    WC1R 5JF London
    British2988490001
    CAMBURN, Clyde Martin
    1 Marsh Cottage
    Shepherds Lane Reydon
    IP18 6SB Southwold
    Amministratore
    1 Marsh Cottage
    Shepherds Lane Reydon
    IP18 6SB Southwold
    EnglandBritish44503380004
    GELLERT, John Matthew
    25th Floor
    1370 Avenue Of The Americas
    10010 New York
    Ny 10019
    Usa
    Amministratore
    25th Floor
    1370 Avenue Of The Americas
    10010 New York
    Ny 10019
    Usa
    United StatesAmerican70080070001
    BAIRD, David George
    19 Blackwood Avenue
    Newton Mearns
    G77 5JY Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    19 Blackwood Avenue
    Newton Mearns
    G77 5JY Glasgow
    Lanarkshire
    British25620001
    MD SECRETARIES LIMITED
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Segretario nominato
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    900005110001
    BAIRD, David George
    19 Blackwood Avenue
    Newton Mearns
    G77 5JY Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    19 Blackwood Avenue
    Newton Mearns
    G77 5JY Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish25620001
    BENSON, David Gillies
    Ducks Farm
    Eastcott
    SN10 4PJ Devizes
    Wiltshire
    Amministratore
    Ducks Farm
    Eastcott
    SN10 4PJ Devizes
    Wiltshire
    British1856390001
    BURROWS, Ian Edwin
    32 Queen Street
    G84 9QL Helensburgh
    Dunbartonshire
    Amministratore
    32 Queen Street
    G84 9QL Helensburgh
    Dunbartonshire
    British25670001
    CADENHEAD, Kenneth Caldwell
    6 Kinnoul Lane
    G12 9HF Glasgow
    Amministratore
    6 Kinnoul Lane
    G12 9HF Glasgow
    British25680002
    CADENHEAD, Kenneth Caldwell
    6 Kinnoul Lane
    G12 9HF Glasgow
    Amministratore
    6 Kinnoul Lane
    G12 9HF Glasgow
    British25680002
    COWDEROY, James Anthony Frank
    The Glassert
    Lochard Road
    FK8 3TJ Aberfoyle
    Stirlingshire
    Amministratore
    The Glassert
    Lochard Road
    FK8 3TJ Aberfoyle
    Stirlingshire
    ScotlandBritish40380390001
    HARRISON, Iain Victor Robinson
    Craighat
    Killearn
    G63 9QL Glasgow
    Amministratore
    Craighat
    Killearn
    G63 9QL Glasgow
    ScotlandBritish38290001
    LENTHALL, Rodney Desmonde Morgan
    Mulberry Lodge
    Lodge Hill Road
    GU10 3RD Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Mulberry Lodge
    Lodge Hill Road
    GU10 3RD Farnham
    Surrey
    British64332640001
    RYAN, Richard James
    6 Redcliffe Way
    NR13 5LS Brundall
    Norfolk
    Amministratore
    6 Redcliffe Way
    NR13 5LS Brundall
    Norfolk
    United KingdomBritish75873300001
    WILSON, Andrew George
    Little Carbeth
    G63 9QJ Killearn
    Glasgow
    Amministratore
    Little Carbeth
    G63 9QJ Killearn
    Glasgow
    British782420001
    WORDIE, Peter Jeffrey
    The Row
    FK15 9NZ Dunblane
    Perthshire
    Amministratore
    The Row
    FK15 9NZ Dunblane
    Perthshire
    British25640001
    MD SECRETARIES LIMITED
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Amministratore delegato nominato
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    900005110001

    STIRLING MARINE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of covenant
    Creato il 10 lug 1998
    Consegnato il 30 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Earnings in respect of the vessel "stirling tay".
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 15 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Deed of covenant
    Creato il 09 lug 1998
    Consegnato il 10 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    64/64TH shares,the earnings & requisition compensation the vessel "stirling tay".
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 15 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Second priority statutory ship mortgage
    Creato il 09 lug 1998
    Consegnato il 10 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    64/64TH shares in the ship "stirling tay".
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 08 ott 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    First priority statutory ship mortgage
    Creato il 09 lug 1998
    Consegnato il 10 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    64/64TH shares in the ship "stirling tay".
    Persone aventi diritto
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transazioni
    • 10 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 08 ott 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Performance guarantee assignation
    Creato il 22 ago 1997
    Consegnato il 28 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All the companys beneficial interest & its rights & titles.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 15 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Assignation in security
    Creato il 22 ago 1997
    Consegnato il 28 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The whole right,title and interest under the contracts.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 15 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Delivery order
    Creato il 22 ago 1997
    Consegnato il 28 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The vessel, her engines,equipment,machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 15 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Shipowners form
    Creato il 22 ago 1997
    Consegnato il 28 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The company's obligations under the shipowners form
    Brevi particolari
    Any moneys payable in accordance with the terms of the security documents.
    Persone aventi diritto
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transazioni
    • 28 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 15 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Deed of covenant
    Creato il 26 ago 1996
    Consegnato il 28 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Companys right,title and interest in all money payable by shell U.K. limited.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 15 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Deed of covenant
    Creato il 23 ago 1996
    Consegnato il 28 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All rights,title and interest in & to the mortgaged property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 15 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Second priority statutory mortgage
    Creato il 23 ago 1996
    Consegnato il 26 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    64/64TH shares in the vessel "stirling forth" registered on the bahamas no. 728058.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 26 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    First priority statutory ship mortgage
    Creato il 23 ago 1996
    Consegnato il 26 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    64/64TH shares on the vessel "stirling forth" registered in the bahamas no.728508.
    Persone aventi diritto
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transazioni
    • 26 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Mortgage
    Creato il 09 gen 1996
    Consegnato il 22 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    51/64TH shares in the ship "stirling fyne", off no 726104, registered at nassau, and her boats, guns, etc....... see ch microfiche for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and Others
    Transazioni
    • 22 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Deed of covenant
    Creato il 09 gen 1996
    Consegnato il 22 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The company's rights, title and interest in the ship and its shares.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent and Trustee for Others
    Transazioni
    • 22 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Assignment
    Creato il 09 gen 1996
    Consegnato il 22 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The earnings, requisition compensation, etc....... see ch microfiche for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent and Trustee for Others
    Transazioni
    • 22 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 08 gen 1996
    Consegnato il 22 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent and Trustee for Others
    Transazioni
    • 22 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 22 gen 1996Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 13 set 1996Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 09 set 1997Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 09 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    • Ha modifiche ai divieti
    Bond & floating charge
    Creato il 08 gen 1996
    Consegnato il 22 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due by stirling offshore limited
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 22 gen 1996Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 22 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 13 set 1996Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 09 set 1997Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 09 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    • Ha modifiche ai divieti
    Performance guarantee assignation
    Creato il 15 dic 1995
    Consegnato il 19 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The company's whole beneficial interest and all its benefits, rights and titles (but not its obligations) in and under the performance guarantee dated 30/3/95 made by kvaerner A.S. in favour of the company.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 15 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Contract assignation
    Creato il 15 dic 1995
    Consegnato il 19 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The company's whole rights, interests and benefits (but not its obligations) under the ship building contract dated 30/3/95, relating to the construction of a vessel to be known during construction as yard no. 310....... see ch microfiche for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 15 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Delivery order
    Creato il 15 dic 1995
    Consegnato il 19 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The vessel known as yard no. 310 and all her engines, equipment, etc....... see ch microfiche.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 15 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Shipowners form
    Creato il 15 dic 1995
    Consegnato il 19 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All sums payable under clause 10.2 of a contract assignation and clause 10 of the general terms by the company....... See ch microfiche for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transazioni
    • 19 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 15 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Deed of covenant
    Creato il 21 nov 1994
    Consegnato il 12 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due and to become due under a loan agreement, guarantee and security documents
    Brevi particolari
    By way of security for the secured indebtedness the chargor as beneficial owner mortgages and charges and agrees to mortgage asnd charge to and in favour of the chargee all its rights, title and interest, present and future, to and in the ship and to and in the shares of the ship owned by the chargor.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Four party agreement
    Creato il 21 nov 1994
    Consegnato il 12 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due and to become due in terms of a loan agreement
    Brevi particolari
    1) the head charterparty and the head charter rights 2) any requisition compensation and the earnings.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Mortgage
    Creato il 21 nov 1994
    Consegnato il 12 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due and to become due in terms of a loan agreement and a deed of covenant
    Brevi particolari
    51/64 shares, of which the chargee is owner, in the motor ship "stirling fyne" (ex edda fjord) registered on the bahamian flag at the port of nassau.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 21 nov 1994
    Consegnato il 12 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,650,000 and all further sums due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 21 dic 1995Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 13 set 1996Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 09 set 1997Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 09 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    • Ha modifiche ai divieti

    STIRLING MARINE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    01 feb 2011Inizio della liquidazione
    02 ott 2015Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Notescottish-insolvency-info

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0