ENACO MUDCAT SYSTEMS LIMITED

ENACO MUDCAT SYSTEMS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàENACO MUDCAT SYSTEMS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC110053
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ENACO MUDCAT SYSTEMS LIMITED?

    • (9999) /

    Dove si trova ENACO MUDCAT SYSTEMS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O National Oilwell Varco
    Badentoy Crescent, Badentoy Park
    AB12 4YD Portlethen, Aberdeen
    Aberdeenshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ENACO MUDCAT SYSTEMS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    OILTOOLS MUDCAT SYSTEMS LIMITED 15 set 199215 set 1992
    INMARX LIMITED24 mar 198824 mar 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di ENACO MUDCAT SYSTEMS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per ENACO MUDCAT SYSTEMS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Nomina di Alastair James Fleming come segretario in data 30 set 2011

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Christopher Paul O'neil come segretario in data 30 set 2011

    1 pagineTM02

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di David Keener come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Christopher Paul O'neil come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di David James Keener come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Thomas Boyle come amministratore

    2 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Katherine Leighton come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Katherine Leighton come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 ott 2010

    Stato del capitale al 06 ott 2010

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Steven Grenville Valentine il 30 set 2010

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    4 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG03s

    legacy

    1 pagine353

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Nomina di Christopher Paul O'neil come segretario

    1 pagineAP03

    legacy

    1 pagine353

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    4 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    2 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di ENACO MUDCAT SYSTEMS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FLEMING, Alastair James
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    Segretario
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    163563510001
    O'NEIL, Christopher Paul
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish162062160001
    VALENTINE, Steven Grenville
    4 Barnes Close
    Haslington
    CW1 5ZG Crewe
    Amministratore
    4 Barnes Close
    Haslington
    CW1 5ZG Crewe
    EnglandBritish92773870002
    FITZGERALD, John Raymond
    Rocklands Cottage Rocklands Road
    Cults
    AB15 9JS Aberdeen
    Segretario
    Rocklands Cottage Rocklands Road
    Cults
    AB15 9JS Aberdeen
    British57109840001
    LEIGHTON, Katherine Jennifer
    Kirk House
    Victoria Terrace, Kemnay
    AB51 5RL Inverurie
    Aberdeenshire
    Segretario
    Kirk House
    Victoria Terrace, Kemnay
    AB51 5RL Inverurie
    Aberdeenshire
    British110703040002
    MORRIS, Russell Earl
    58 Forest Avenue
    AB1 6TH Aberdeen
    Aberdeenshire
    Segretario
    58 Forest Avenue
    AB1 6TH Aberdeen
    Aberdeenshire
    British1500640001
    O'NEIL, Christopher Paul
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    Segretario
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    British145998000001
    YULE, Alyson Irene
    13 Airyhall Drive
    AB1 7QE Aberdeen
    Aberdeenshire
    Segretario
    13 Airyhall Drive
    AB1 7QE Aberdeen
    Aberdeenshire
    British855140001
    PAULL & WILLIAMSONS
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    Segretario
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    24280001
    BOYLE, Thomas Douglas
    Lanark
    Old Inn Road, Findon Portlethen
    AB12 3RT Aberdeen
    Amministratore
    Lanark
    Old Inn Road, Findon Portlethen
    AB12 3RT Aberdeen
    UkBritish61611910001
    FITZGERALD, John Raymond
    Rocklands Cottage Rocklands Road
    Cults
    AB15 9JS Aberdeen
    Amministratore
    Rocklands Cottage Rocklands Road
    Cults
    AB15 9JS Aberdeen
    British57109840001
    GEDDES, Graham Mclachlan
    4 Rainnieshill Road
    Newmachar
    AB2 0XG Aberdeen
    Amministratore
    4 Rainnieshill Road
    Newmachar
    AB2 0XG Aberdeen
    British57118870001
    HUNTER, Brian Austin
    8 Westfield Avenue
    AB3 2EE Stonehaven
    Kincardineshire
    Amministratore
    8 Westfield Avenue
    AB3 2EE Stonehaven
    Kincardineshire
    British36693320001
    KEENER, David James
    4819 Xp
    Rijsbergen
    Oranjestraat 33
    Netherlands
    Amministratore
    4819 Xp
    Rijsbergen
    Oranjestraat 33
    Netherlands
    NetherlandsUsa161469350001
    LEIGHTON, Katherine Jennifer
    Kirk House
    Victoria Terrace, Kemnay
    AB51 5RL Inverurie
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Kirk House
    Victoria Terrace, Kemnay
    AB51 5RL Inverurie
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish110703040002
    MILLETT, Ronald James
    Hofkoppel 34, 29303
    Bergen
    O T Wohlde
    Germany
    Amministratore
    Hofkoppel 34, 29303
    Bergen
    O T Wohlde
    Germany
    British61611860003
    PHELPS, John
    58 Forest Avenue
    AB1 6TH Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    58 Forest Avenue
    AB1 6TH Aberdeen
    Aberdeenshire
    American75765340001
    PIANCA, Christopher Robert
    14 Farrer Road
    1/2 Waterfall Gardens
    437934 Singapore
    Singapore
    Amministratore
    14 Farrer Road
    1/2 Waterfall Gardens
    437934 Singapore
    Singapore
    British33227220001
    STUART, Peter John
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    Amministratore
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish48638880001
    SUTTIE, Ian Alexander, Mr.
    Parklea North Deeside Road
    Pitfodels
    AB15 0PB Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Parklea North Deeside Road
    Pitfodels
    AB15 0PB Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish52794240001
    THOMSON, Brian St John
    Wedderhill Robert Street
    AB39 2DJ Stonehaven
    Kincardineshire
    Amministratore
    Wedderhill Robert Street
    AB39 2DJ Stonehaven
    Kincardineshire
    ScotlandBritish57263610001

    ENACO MUDCAT SYSTEMS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Bond & floating charge
    Creato il 29 ott 1993
    Consegnato il 04 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The whole assets of the company.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 10 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    Standard security
    Creato il 18 apr 1991
    Consegnato il 30 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Ground lying in virginia st aberdeen being the subjects in theatre lane aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    Bond & floating charge
    Creato il 13 lug 1990
    Consegnato il 20 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 09 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0