STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED

STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC111734
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED?

    • Alberghi e simili strutture ricettive (55100) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    1 George Square
    G2 1AL Glasgow
    Scotland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ORRMAC (NO:63) LIMITED20 giu 198820 giu 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio dall'amministrazione allo scioglimento

    38 pagine2.26B(Scot)

    Proposta riveduta dell'amministratore

    2 pagine2.17B(Scot)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore

    31 pagine2.20B(Scot)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore

    29 pagine2.20B(Scot)

    Dimissioni di un amministratore

    1 pagine2.29B(Scot)

    Dimissioni di un amministratore

    1 pagine2.29B(Scot)

    Proposta presunta dell'amministratore

    1 pagine2.16BZ(Scot)

    Stato patrimoniale con modulo allegato 2.13B(Scot)

    16 pagine2.15B(Scot)

    Proposta dell'amministratore

    147 pagine2.16B(Scot)

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O C/O Maclay Murray & Spens Llp 1 George Square Glasgow G2 1AL Scotland a C/O Maclay Murray & Spens Llp 1 George Square Glasgow G2 1AL in data 26 set 2014

    1 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    3 pagine2.11B(Scot)

    Indirizzo della sede legale modificato da 15 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8HA a C/O Maclay Murray & Spens Llp 1 George Square Glasgow G2 1AL in data 15 set 2014

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Michael Edward Jourdain come amministratore in data 01 ago 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Peter Procopis come amministratore in data 01 ago 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Declan Mckelvey come amministratore in data 01 ago 2014

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 09 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 apr 2014

    Stato del capitale al 28 apr 2014

    • Capitale: GBP 500,000
    SH01

    Cessazione della carica di David Kaye come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Kaye come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    19 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    legacy

    19 pagineMG01s

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    16 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCKELVEY, Declan
    Melrose Court
    Lincoln Road
    SK9 2HD Wilmslow
    1
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Melrose Court
    Lincoln Road
    SK9 2HD Wilmslow
    1
    Cheshire
    England
    EnglandIrishChartered Accountant172282530001
    CAMERON, William Alasdair
    115 Bentinck Drive
    KA10 6JB Troon
    Ayrshire
    Segretario
    115 Bentinck Drive
    KA10 6JB Troon
    Ayrshire
    BritishCa1244320001
    GOULDING, Ian Don
    44 Daisy Lea Lane
    Lindley
    HD3 3LP Huddersfield
    Segretario
    44 Daisy Lea Lane
    Lindley
    HD3 3LP Huddersfield
    BritishChartered Accountant39828490004
    HENDERSON, William Shields
    23 Dundas Street
    EH3 6QQ Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    23 Dundas Street
    EH3 6QQ Edinburgh
    Midlothian
    British893760001
    KAYE, David Robert
    6 Copthall Gardens
    Mill Hill
    NW7 2NG London
    Segretario
    6 Copthall Gardens
    Mill Hill
    NW7 2NG London
    British110817160002
    LANGRIDGE, Megan Joy
    42 Everest Drive
    Hoo St Werburgh
    ME3 9AW Rochester
    Kent
    Segretario
    42 Everest Drive
    Hoo St Werburgh
    ME3 9AW Rochester
    Kent
    British86459820005
    ORR MACQUEEN W S
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    Segretario
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    39211930001
    ANDERSON, Alan William
    24 Hillside Terrace
    Edinburgh
    Amministratore
    24 Hillside Terrace
    Edinburgh
    BritishSolicitor740310001
    BRYNES, Peter
    19 Viking Crescent
    Houston
    PA6 7LQ Johnstone
    Renfrewshire
    Amministratore
    19 Viking Crescent
    Houston
    PA6 7LQ Johnstone
    Renfrewshire
    BritishCivil Engineer71545500001
    CAMERON, William Alasdair
    115 Bentinck Drive
    KA10 6JB Troon
    Ayrshire
    Amministratore
    115 Bentinck Drive
    KA10 6JB Troon
    Ayrshire
    BritishCa1244320001
    CAMPBELL, Colin John
    25 Wycombe End
    HP9 1LZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    25 Wycombe End
    HP9 1LZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishDirector99161140001
    GALGANI, Franco
    13 Keppel Road
    EH39 4QF North Berwick
    East Lothian
    Amministratore
    13 Keppel Road
    EH39 4QF North Berwick
    East Lothian
    BritishHotelier43293400002
    GOULDING, Ian Don
    44 Daisy Lea Lane
    Lindley
    HD3 3LP Huddersfield
    Amministratore
    44 Daisy Lea Lane
    Lindley
    HD3 3LP Huddersfield
    United KingdomBritishChartered Accountant39828490004
    HENDERSON, William Shields
    Park House 13 Greenhill Park
    EH10 4DW Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    Park House 13 Greenhill Park
    EH10 4DW Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishFinancial Advisor55090001
    JOURDAIN, Michael Edward
    The Sticks
    Hatchgate Lane
    RH17 5DU Cuckfield
    Sussex
    Amministratore
    The Sticks
    Hatchgate Lane
    RH17 5DU Cuckfield
    Sussex
    EnglandBritishDirector58412670001
    KAYE, David Robert
    14 Clifford Street
    W1S 4JU London
    Bond Street House
    England
    Amministratore
    14 Clifford Street
    W1S 4JU London
    Bond Street House
    England
    United KingdomBritishDirector110817160002
    MARCOVECCHIO, Massimo Mario
    27 Manor Wood Road
    CR8 4LG Purley
    Surrey
    Amministratore
    27 Manor Wood Road
    CR8 4LG Purley
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Surveyor75936930001
    MURRAY, Rodger Grant
    24 Moston Terrace
    Edinburgh
    Amministratore delegato nominato
    24 Moston Terrace
    Edinburgh
    British900000170001
    PAISNER, Jonathan Samuel
    Bond Street House
    14 Clifford Street
    W1S 4JU London
    Amministratore
    Bond Street House
    14 Clifford Street
    W1S 4JU London
    United KingdomBritishSolicitor78399950005
    PROCOPIS, Peter
    7a Lauderdale Road
    W9 1LT London
    Amministratore
    7a Lauderdale Road
    W9 1LT London
    United KingdomAustralianFinance Director66047970002
    PURTILL, Michael Edward
    Froghall
    Barmby Moor
    YO42 4DA Pocklington
    East Yorkshire
    Amministratore
    Froghall
    Barmby Moor
    YO42 4DA Pocklington
    East Yorkshire
    EnglandIrishChartered Accountant7856280001
    ROGERS, Paul
    Ash Barton
    20 The Ridgeway
    WD7 8PR Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    Ash Barton
    20 The Ridgeway
    WD7 8PR Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor41216370001
    SIMMERS, Brian Maxwell
    Remuera
    Kirkhouse Road, Killearn
    G63 9NB Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    Remuera
    Kirkhouse Road, Killearn
    G63 9NB Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritishChartered Accountant1064940001
    SIMMERS, Graeme Maxwell
    Kincaple
    Balfron
    G63 ORW Glasgow
    Amministratore
    Kincaple
    Balfron
    G63 ORW Glasgow
    ScotlandBritishCa1064950001
    SMITH, Paul Murray
    Woodlands 3 The Lade
    EH14 7LB Balerno
    Midlothian
    Amministratore
    Woodlands 3 The Lade
    EH14 7LB Balerno
    Midlothian
    BritishDirector1064970001
    WATSON, David James
    18 Saville Row
    London
    Amministratore
    18 Saville Row
    London
    BritishCompany Director1123110001

    STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 03 apr 2012
    Consegnato il 05 apr 2012
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Irish Bank Resolution Corporation Limited
    Transazioni
    • 05 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    Assignation of rents
    Creato il 24 lug 2009
    Consegnato il 28 lug 2009
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Right, title and interest in and to the rental income over stirling highland hotel, stirling.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 28 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    Deed of confirmation
    Creato il 07 lug 2009
    Consegnato il 21 lug 2009
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Variation of previously registered floating charge, assignation of rents and standard securities-see form for further details.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 21 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    Assignation of rents
    Creato il 20 set 2007
    Consegnato il 11 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Present and future right, title and interest in and to the rental income over the stirling highland hotel, spittal street, stirling.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporatiin PLC
    Transazioni
    • 11 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 22 lug 2004
    Consegnato il 29 lug 2004
    In corso
    Importo garantito
    All sums due under the transaction documents
    Brevi particolari
    The tenant's interest in the lease in respect of the subjects comprising 1.88 acres of ground and known as and forming the stirling highland hotel, spittal street, stirling.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 29 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    Floating charge
    Creato il 12 lug 2004
    Consegnato il 16 lug 2004
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC as Security Trustee for Itself and Others
    Transazioni
    • 16 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 12 apr 2002
    Consegnato il 23 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The stirling highland hotel, spittal street, stirling.
    Persone aventi diritto
    • Nib Capital Bank N.V.
    Transazioni
    • 23 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 10 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 04 apr 2002
    Consegnato il 12 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Nib Capital Bank N.V.
    Transazioni
    • 12 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 21 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 21 lug 2000
    Consegnato il 04 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Stirling highland hotel, spittal street, stirling.
    Persone aventi diritto
    • Nib Capital Bank N.V.
    Transazioni
    • 04 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 10 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 13 lug 2000
    Consegnato il 27 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Nib Capital Bank N.V.
    Transazioni
    • 27 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 21 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 14 gen 2000
    Consegnato il 03 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The stirling highland hotel, stirling.
    Persone aventi diritto
    • De Nationale Investeringsbank N.V.
    Transazioni
    • 03 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 10 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 23 dic 1999
    Consegnato il 13 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • De Nationale Investeringsbank N.V
    Transazioni
    • 13 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 21 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 04 mag 1990
    Consegnato il 11 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £400,000 and all sums due or to become due
    Brevi particolari
    Lease out property between central doc. Council and company dated 20/4/90.
    Persone aventi diritto
    • Scottish Development Agency
    Transazioni
    • 11 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 03 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 04 mag 1990
    Consegnato il 11 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Lease over 1.88 acres at old high school stirling.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 08 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Instrument of charge
    Creato il 20 apr 1990
    Consegnato il 03 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £400,000 together with all further sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Scottish Development Agency
    Transazioni
    • 03 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 11 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Bond & floating charge
    Creato il 20 apr 1990
    Consegnato il 30 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 03 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:

    STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    11 set 2014Inizio dell'amministrazione
    10 set 2015Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Paul David Williams
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Praticante
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    David John Whitehouse
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Praticante
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Paul John Clark
    The Shard 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Praticante
    The Shard 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0