REGENERSIS (GLASGOW) LIMITED

REGENERSIS (GLASGOW) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàREGENERSIS (GLASGOW) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC112872
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di REGENERSIS (GLASGOW) LIMITED?

    • Altre attività di telecomunicazioni (61900) / Informazione e comunicazione
    • Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi

    Dove si trova REGENERSIS (GLASGOW) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 James Watt Avenue
    Westwood Park
    KY7 4UA Glenrothes
    Fife
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di REGENERSIS (GLASGOW) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TOTAL REPAIR SOLUTIONS LIMITED06 lug 201106 lug 2011
    REGENERSIS (GLASGOW) LIMITED19 feb 201019 feb 2010
    TOTAL REPAIR SOLUTIONS LIMITED18 apr 200018 apr 2000
    WESTWOOD COMMUNICATIONS LIMITED 22 ago 198822 ago 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di REGENERSIS (GLASGOW) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per REGENERSIS (GLASGOW) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 feb 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 feb 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2018

    14 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 32 Fountain Drive Inchinnan Business Park Inchinnan Renfrewshire PA4 9RF a 1 James Watt Avenue Westwood Park Glenrothes Fife KY7 4UA in data 25 feb 2019

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 feb 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2017

    15 pagineAA

    Nomina di Clc Secretarial Services Ltd come segretario in data 01 lug 2018

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Lorraine Young Company Secretaries Limited come segretario in data 30 giu 2018

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 feb 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere SC1128720011 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC1128720012 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2016

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 giu 2016 al 31 dic 2016

    1 pagineAA01

    Dettagli del segretario cambiati per Lorraine Young Company Secretaries Limited il 22 dic 2016

    1 pagineCH04

    Nomina di Mr Christopher Howe come amministratore in data 04 apr 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Gerald Joseph Parsons come amministratore in data 04 apr 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Leo David Parsons come amministratore in data 04 apr 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jog Dhody come amministratore in data 04 apr 2016

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio redatto al 30 giu 2015

    16 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di REGENERSIS (GLASGOW) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CLC SECRETARIAL SERVICES LTD
    Aldersgate Street
    EC1A 4HJ London
    10 Aldersgate Street
    England
    Segretario
    Aldersgate Street
    EC1A 4HJ London
    10 Aldersgate Street
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione03567116
    249037320001
    HOWE, Christopher
    James Watt Avenue
    Westwood Park
    KY7 4UA Glenrothes
    1
    Fife
    United Kingdom
    Amministratore
    James Watt Avenue
    Westwood Park
    KY7 4UA Glenrothes
    1
    Fife
    United Kingdom
    United StatesAmerican207227000001
    PARSONS, Gerald Joseph
    James Watt Avenue
    Westwood Park
    KY7 4UA Glenrothes
    1
    Fife
    United Kingdom
    Amministratore
    James Watt Avenue
    Westwood Park
    KY7 4UA Glenrothes
    1
    Fife
    United Kingdom
    United StatesAmerican,207226980001
    PARSONS, Leo David
    James Watt Avenue
    Westwood Park
    KY7 4UA Glenrothes
    1
    Fife
    United Kingdom
    Amministratore
    James Watt Avenue
    Westwood Park
    KY7 4UA Glenrothes
    1
    Fife
    United Kingdom
    United StatesAmerican207226970001
    DICK, William Austin
    Broomfield Avenue
    Newton Mearns
    G77 5JP Glasgow
    92
    Segretario
    Broomfield Avenue
    Newton Mearns
    G77 5JP Glasgow
    92
    British134203250001
    EMANUEL, Richard John Metcalfe
    Le Formentor
    27 Avenue Princesse Grace
    Monaco
    98000
    Segretario
    Le Formentor
    27 Avenue Princesse Grace
    Monaco
    98000
    British91766020001
    JOHNSTON, Philip James
    10 Mclaren Grove
    Kittoch Glen, East Kilbride
    G74 4SR Glasgow
    Segretario
    10 Mclaren Grove
    Kittoch Glen, East Kilbride
    G74 4SR Glasgow
    British90598180001
    SINCLAIR, Margaret
    37 Turnberry Drive
    Newton Mearns
    G77 5SE Glasgow
    Segretario
    37 Turnberry Drive
    Newton Mearns
    G77 5SE Glasgow
    British39627650002
    TANSINI, Sergio
    55 Gamekeepers Road
    EH4 6LR Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    55 Gamekeepers Road
    EH4 6LR Edinburgh
    Midlothian
    Italian106858140001
    TELFORD, Bruce
    Westwood,51 Broompark Drive
    Newton Mearns
    G77 5EH Renfrewshire
    Segretario
    Westwood,51 Broompark Drive
    Newton Mearns
    G77 5EH Renfrewshire
    British1165580001
    TEMPLE, John Nicholas
    Windfalls Highfield Road
    West Moors
    BH22 0NA Ferndown
    Dorset
    Segretario
    Windfalls Highfield Road
    West Moors
    BH22 0NA Ferndown
    Dorset
    British84493950001
    WEATHERALL, Sally
    32 Fountain Drive
    Inchinnan Business Park
    PA4 9RF Inchinnan
    Renfrewshire
    Segretario
    32 Fountain Drive
    Inchinnan Business Park
    PA4 9RF Inchinnan
    Renfrewshire
    152389640001
    WILLIAMS, Paul
    18 Kirkhouse Road
    Blanefield
    G63 9DA Glasgow
    Segretario
    18 Kirkhouse Road
    Blanefield
    G63 9DA Glasgow
    British83461940001
    LORRAINE YOUNG COMPANY SECRETARIES LIMITED
    6th Floor
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    Shakespeare Martineau Llp
    United Kingdom
    Segretario
    6th Floor
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    Shakespeare Martineau Llp
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione07873246
    165261700001
    PRISM COSEC LIMITED
    Regent Street
    W1B 2ES London
    271
    England
    Segretario
    Regent Street
    W1B 2ES London
    271
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione06633248
    160987360001
    DHODY, Jog
    32 Fountain Drive
    Inchinnan Business Park
    PA4 9RF Inchinnan
    Renfrewshire
    Amministratore
    32 Fountain Drive
    Inchinnan Business Park
    PA4 9RF Inchinnan
    Renfrewshire
    EnglandBritish104269910005
    EMANUEL, Richard John Metcalfe
    Le Formentor
    27 Avenue Princesse Grace
    Monaco
    98000
    Amministratore
    Le Formentor
    27 Avenue Princesse Grace
    Monaco
    98000
    MonacoBritish91766020001
    GORMAN, Christopher Simon
    Ravenswood Prieston Road
    PA11 3AN Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    Amministratore
    Ravenswood Prieston Road
    PA11 3AN Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    ScotlandBritish38525620002
    JOHNSTON, Philip James
    10 Mclaren Grove
    Kittoch Glen, East Kilbride
    G74 4SR Glasgow
    Amministratore
    10 Mclaren Grove
    Kittoch Glen, East Kilbride
    G74 4SR Glasgow
    ScotlandBritish90598180001
    KELHAM, David William
    32 Fountain Drive
    Inchinnan Business Park
    PA4 9RF Inchinnan
    Renfrewshire
    Amministratore
    32 Fountain Drive
    Inchinnan Business Park
    PA4 9RF Inchinnan
    Renfrewshire
    EnglandBritish87146390001
    KELHAM, David William
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    EnglandBritish87146390001
    LEE, Andrew Stephen
    Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    4th
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    4th
    United Kingdom
    United KingdomBritish159105430001
    SIMPSON, William Alexander
    8 Airbles Farm Road
    ML1 3AZ Motherwell
    Lanarkshire
    Amministratore
    8 Airbles Farm Road
    ML1 3AZ Motherwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritish206100001
    STOKES, Gary Martin
    16a Fiery Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LG Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    16a Fiery Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LG Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish71396660002
    TANSINI, Sergio
    32 Fountain Drive
    Inchinnan Business Park
    PA4 9RF Inchinnan
    Renfrewshire
    Amministratore
    32 Fountain Drive
    Inchinnan Business Park
    PA4 9RF Inchinnan
    Renfrewshire
    ScotlandItalian106858140001
    TANSINI, Sergio
    55 Gamekeepers Road
    EH4 6LR Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    55 Gamekeepers Road
    EH4 6LR Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandItalian106858140001
    TELFORD, Bruce
    Westwood,51 Broompark Drive
    Newton Mearns
    G77 5EH Renfrewshire
    Amministratore
    Westwood,51 Broompark Drive
    Newton Mearns
    G77 5EH Renfrewshire
    British1165580001
    TELFORD, Robert
    1-102 Byres Road
    G11 5RD Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    1-102 Byres Road
    G11 5RD Glasgow
    Lanarkshire
    British27186030001
    WHYTE, John Joseph
    8 Greenbank Avenue
    Whitecraigs
    G46 6SG Glasgow
    Amministratore
    8 Greenbank Avenue
    Whitecraigs
    G46 6SG Glasgow
    ScotlandBritish9384550003
    WILSON, Jeremy Michael Charles
    Hinchingbrooke Business Park
    Huntingdon
    PE29 6FN Cambridgeshire
    Kingfisher Way
    United Kingdom
    Amministratore
    Hinchingbrooke Business Park
    Huntingdon
    PE29 6FN Cambridgeshire
    Kingfisher Way
    United Kingdom
    EnglandBritish151756520001

    Chi sono le persone con controllo significativo di REGENERSIS (GLASGOW) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    MK12 5TH Wolverton Mill
    Featherstone Road
    Milton Keynes
    United Kingdom
    06 apr 2016
    MK12 5TH Wolverton Mill
    Featherstone Road
    Milton Keynes
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2966414
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    REGENERSIS (GLASGOW) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 04 apr 2016
    Consegnato il 08 apr 2016
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Citizens Bank of Pennsylvania as Security Trustee
    Transazioni
    • 08 apr 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 12 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 04 apr 2016
    Consegnato il 08 apr 2016
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Citizens Bank of Pennsylvania as Security Trustee
    Transazioni
    • 08 apr 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 12 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal assignment of contract monies
    Creato il 21 dic 2012
    Consegnato il 04 gen 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Rights title and interest in and to the contract monies see form for further details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 04 gen 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 31 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge
    Creato il 20 dic 2012
    Consegnato il 09 gen 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 09 gen 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 09 gen 2013Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 31 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Floating charge
    Creato il 12 mag 2011
    Consegnato il 25 mag 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 09 gen 2013Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 13 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Bond & floating charge
    Creato il 03 set 2009
    Consegnato il 15 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Kbc Bank Nv
    Transazioni
    • 15 set 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    Standard security
    Creato il 04 lug 2003
    Consegnato il 11 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    28-32 fountain drive, inchinnan, renfrew ren 96005.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 26 giu 2003
    Consegnato il 07 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    Floating charge
    Creato il 01 giu 1998
    Consegnato il 10 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    Floating charge
    Creato il 03 nov 1993
    Consegnato il 05 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 17 lug 1991
    Consegnato il 24 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 24 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 18 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 28 mar 1990
    Consegnato il 04 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 apr 1990Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0