STOLT SEA FARM LTD.

STOLT SEA FARM LTD.

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTOLT SEA FARM LTD.
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC114037
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STOLT SEA FARM LTD.?

    • (0502) /

    Dove si trova STOLT SEA FARM LTD.?

    Indirizzo della sede legale
    Ratho Park, 88 Glasgow Road
    Ratho Station
    EH28 8PP Newbridge
    Midlothian
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STOLT SEA FARM LTD.?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STOLT SEAFARM (UK) LTD.05 gen 199805 gen 1998
    GAELIC SEAFOODS (SCOTLAND) LIMITED28 apr 199328 apr 1993
    SHIANT ISLES LIMITED13 ott 198813 ott 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di STOLT SEA FARM LTD.?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per STOLT SEA FARM LTD.?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 gen 2010

    Stato del capitale al 26 gen 2010

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Kenneth James Mcintosh il 31 dic 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    4 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    4 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    14 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    16 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    1 pagine244

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di STOLT SEA FARM LTD.?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    THOMPSON, Lorraine Elizabeth
    40 Gardiner Road
    EH4 3RN Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    40 Gardiner Road
    EH4 3RN Edinburgh
    Midlothian
    British69247060001
    MCINTOSH, Kenneth James
    7 Nursery Park
    PH34 4EW Spean Bridge
    Inverness-Shire
    Amministratore
    7 Nursery Park
    PH34 4EW Spean Bridge
    Inverness-Shire
    ScotlandBritish124854160001
    SUTHERLAND, Alan George
    35 Corton Lea
    Alloway
    KA6 6GJ Ayr
    Amministratore
    35 Corton Lea
    Alloway
    KA6 6GJ Ayr
    ScotlandBritish121052220002
    BRADSHAW, Stephen John
    2 Collingwood Close
    Saltford
    BS31 3HZ Bristol
    Segretario
    2 Collingwood Close
    Saltford
    BS31 3HZ Bristol
    British36433080001
    CUNNINGHAM, Roderick
    1 East Street
    Sandwick
    HS2 OAG Isle Of Lewis
    Segretario
    1 East Street
    Sandwick
    HS2 OAG Isle Of Lewis
    British744890002
    CUNNINGHAM, Roderick
    1 East Street
    Sandwick
    HS2 OAG Isle Of Lewis
    Segretario
    1 East Street
    Sandwick
    HS2 OAG Isle Of Lewis
    British744890002
    DREW, Dan Hamilton
    Lower Poswick
    Whitbourne
    WR6 5SS Worcester
    Segretario
    Lower Poswick
    Whitbourne
    WR6 5SS Worcester
    British2128120001
    MACDONALD, Yvonne Frances
    21 West Kilbride Road
    KA24 5DZ Dalry
    Ayrshire
    Segretario
    21 West Kilbride Road
    KA24 5DZ Dalry
    Ayrshire
    British82618570002
    WILSON, Roger
    25 Beech Tree Avenue
    SL7 3NH Marlow
    Buckinghamshire
    Segretario
    25 Beech Tree Avenue
    SL7 3NH Marlow
    Buckinghamshire
    British9209680001
    SECRETAR SECURITIES LIMITED
    249 West George Street
    G2 4RB Glasgow
    Segretario
    249 West George Street
    G2 4RB Glasgow
    77605900001
    BAILLIE, Stuart Malcolm
    1 Victoria Terrace
    IV2 3QA Inverness
    Scotland
    Amministratore
    1 Victoria Terrace
    IV2 3QA Inverness
    Scotland
    Scottish16614750002
    BRADSHAW, Stephen John
    2 Collingwood Close
    Saltford
    BS31 3HZ Bristol
    Amministratore
    2 Collingwood Close
    Saltford
    BS31 3HZ Bristol
    British36433080001
    CUNNINGHAM, Roderick
    1 East Street
    Sandwick
    HS2 OAG Isle Of Lewis
    Amministratore
    1 East Street
    Sandwick
    HS2 OAG Isle Of Lewis
    ScotlandBritish744890002
    DREW, Dan Hamilton
    Lower Poswick
    Whitbourne
    WR6 5SS Worcester
    Amministratore
    Lower Poswick
    Whitbourne
    WR6 5SS Worcester
    EnglandBritish2128120001
    FALLER, Guy Nicholas Anthony
    Jongskollen 27
    1337 Sanbvika
    FOREIGN Norway
    Amministratore
    Jongskollen 27
    1337 Sanbvika
    FOREIGN Norway
    British55284040002
    GABRIEL, Richard
    Huntley Manor
    GL19 3HQ Huntley
    Gloucestershire
    Amministratore
    Huntley Manor
    GL19 3HQ Huntley
    Gloucestershire
    British35002520003
    GILLEN, Patrick Francis
    44 Lambourne Wood
    Brennanstown Road
    IRISH Cabin Teely
    Dublin 18
    Ireland
    Amministratore
    44 Lambourne Wood
    Brennanstown Road
    IRISH Cabin Teely
    Dublin 18
    Ireland
    Irish51824730001
    GRONTVEOT, Havard Johannes
    9 Wedderburn Road
    FK15 0FN Dunblane
    Perthshire
    Amministratore
    9 Wedderburn Road
    FK15 0FN Dunblane
    Perthshire
    Norwegian114924300001
    INGRAM, Michael Peter, Dr
    Bisgood
    Thie-Ny-Chibbyr Surby
    ISLE MAN Port Erin
    Isle Of Man
    Amministratore
    Bisgood
    Thie-Ny-Chibbyr Surby
    ISLE MAN Port Erin
    Isle Of Man
    British878460001
    LORENTZEN, James Stove
    Dr. Holsvei 21a
    0787 Oslo
    Norway
    Amministratore
    Dr. Holsvei 21a
    0787 Oslo
    Norway
    Norwegian83761400001
    MAGUIRE, Brian Donal
    32
    Gravir
    PA86 9QX Isle Of Lewis
    Amministratore
    32
    Gravir
    PA86 9QX Isle Of Lewis
    British35616260001
    MATON, John Charles
    Hillsdown House
    32 Hampstead High Street
    NW3 1QD London
    Amministratore
    Hillsdown House
    32 Hampstead High Street
    NW3 1QD London
    British4953530001
    NICOLSON, Angus
    42-46 Point Street
    PA87 2XF Stornoway
    Isle Of Lewis
    Amministratore
    42-46 Point Street
    PA87 2XF Stornoway
    Isle Of Lewis
    British779730001
    STEIRO, Oystein
    Furstlia 15
    1367 Snaroya
    Norway
    Amministratore
    Furstlia 15
    1367 Snaroya
    Norway
    Norwegian81729570001
    STOLT-NIELSEN, Niels Gregers
    Thomas Heftyesgt 38
    N 0264 Oslo
    Norway
    Amministratore
    Thomas Heftyesgt 38
    N 0264 Oslo
    Norway
    Norwegian48417140001
    WILSON, Robert
    3 Pikes Knowe Court
    Cardrona
    EH45 9LP Peebles
    Borders
    Amministratore
    3 Pikes Knowe Court
    Cardrona
    EH45 9LP Peebles
    Borders
    ScotlandBritish84079420001

    STOLT SEA FARM LTD. ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security
    Creato il 09 giu 1998
    Consegnato il 29 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Land at tavay island,isle of lewis.
    Persone aventi diritto
    • Sea Farm Europe Limited
    Transazioni
    • 29 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 03 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 09 giu 1998
    Consegnato il 29 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Ground at sponish,north uist.
    Persone aventi diritto
    • Sea Farm Europe Limited
    Transazioni
    • 29 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 03 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 09 giu 1998
    Consegnato il 29 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Ground near geocrab,south harris.
    Persone aventi diritto
    • Sea Farm Europe Limited
    Transazioni
    • 29 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 03 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 18 mar 1998
    Consegnato il 08 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Sea Farm Europe Limited
    Transazioni
    • 08 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 03 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 11 ago 1995
    Consegnato il 18 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All fish stocks.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Ewos Limited
    Transazioni
    • 18 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 feb 1996Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 30 mar 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Standard security
    Creato il 10 ago 1994
    Consegnato il 24 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    One acre or thereby of ground at sponish, north uist as relative to disposition by the lees group (scotland) limited (in receivership) ifo oval (759) limited dated 18TH august and recorded grs (inverness) 11TH nov 1992.
    Persone aventi diritto
    • Abacus (C.I.) Limited as Trustee of the D.H. Drew Settlement
    Transazioni
    • 24 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 29 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 10 ago 1994
    Consegnato il 24 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    2.258 acres near geocrab, south harris on the west of loch beacravik described in feu charter by lewis and harris welfare and development company limited ifo kenneth mackenzie limited dated 16TH and recorded grs (inverness) 20TH nov 1922 under exception.
    Persone aventi diritto
    • Abacus (C.I.) Limited as Trustee of the D.H. Drew Settlement
    Transazioni
    • 24 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 29 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 03 ago 1994
    Consegnato il 12 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Ground at sponish, north uist..... See ch microfiche.
    Persone aventi diritto
    • Hambros Channel Islands Trust Corporation Limited as Trustee
    Transazioni
    • 12 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 29 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 03 ago 1994
    Consegnato il 12 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Ground near geocrab, south harris as relative to feu charter by lewis and harris welfare and development company limited ifo kenneth mackenzie limited dated 16TH and recorded grs inverness 20TH nov 1922 under exception..... See ch microfiche.
    Persone aventi diritto
    • Hambros Channel Islands Trust Corporation Limited as Trustee
    Transazioni
    • 12 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 29 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 03 ago 1994
    Consegnato il 12 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Ground near geocrab, south harris as relative to feu charter by lewis and harris welfare and development company LTD ifo kenneth mackenzie limited dated 16TH and recorded grs inverness 20TH nov 1922 under exception... See ch microfiche.
    Persone aventi diritto
    • Hambros Channel Islands Trust Corporation Limited as Trustee
    Transazioni
    • 12 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 29 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 03 ago 1994
    Consegnato il 12 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Ground at sponish, north uist as relative to disposition by the lees group (scotland) limited (in receivership) ifo oval (759) limited dated 18TH aug and recorded grs inverness 11TH nov 1992.
    Persone aventi diritto
    • Hambros Channel Islands Trust Corporation Limited as Trustee
    Transazioni
    • 12 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 29 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 06 lug 1994
    Consegnato il 27 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Abacus (C.I.) Limited as Trustee of the D.H. Drew Settlement
    Transazioni
    • 27 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 05 ago 1994Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 08 feb 1996Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 28 feb 1996Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 03 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    • Ha modifiche ai divieti
    Bond & floating charge
    Creato il 06 lug 1994
    Consegnato il 27 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Hambros Channel Islands Trust Corporation Limited as Trustee
    Transazioni
    • 27 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 05 ago 1994Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 08 feb 1996Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 28 feb 1996Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 03 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    • Ha modifiche ai divieti
    Bond & floating charge
    Creato il 06 lug 1994
    Consegnato il 27 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Hambros Channel Islands Trust Corporation Limited as Trustee
    Transazioni
    • 27 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 05 ago 1994Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 08 feb 1996Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 28 feb 1996Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 03 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    • Ha modifiche ai divieti
    Floating charge
    Creato il 06 lug 1994
    Consegnato il 27 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due by the company and others
    Brevi particolari
    See ch microfiche.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Hambros Channel Islands Trust Corporation Limited as Trustee
    Transazioni
    • 27 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 05 ago 1994Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 03 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Floating charge
    Creato il 06 lug 1994
    Consegnato il 27 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due by the company and others
    Brevi particolari
    See ch microfiche.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Abacus (C.I.) Limited as Trustee of the D.H. Drew Settlement
    Transazioni
    • 27 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 05 ago 1994Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 03 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Floating charge
    Creato il 06 lug 1994
    Consegnato il 27 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due by the company and others
    Brevi particolari
    See ch microfiche.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Hambros Channel Islands Trust Corporation Limited as Trustee
    Transazioni
    • 27 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 05 ago 1994Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 03 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0