MECO INTERNATIONAL LIMITED

MECO INTERNATIONAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMECO INTERNATIONAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC114465
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MECO INTERNATIONAL LIMITED?

    • (2924) /

    Dove si trova MECO INTERNATIONAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Fao A Joss 3rd Floor
    206 Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MECO INTERNATIONAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DMWS 105 LIMITED15 nov 198815 nov 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di MECO INTERNATIONAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 ott 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per MECO INTERNATIONAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Verbale della riunione finale di liquidazione volontaria

    3 pagine4.26(Scot)

    Indirizzo della sede legale modificato da 3rd Floor, 206 st. Vincent Street Glasgow G2 5SG in data 11 lug 2012

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Mitchells Roberton George House, 36 North Hanover Street, Glasgow G1 2AD in data 15 giu 2012

    2 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 31 mag 2012

    LRESSP

    Dettagli del segretario cambiati per Miss Catherine Leith il 24 giu 2011

    1 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 07 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 giu 2011

    Stato del capitale al 17 giu 2011

    • Capitale: GBP 8,824
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Nicholas Mannion il 17 giu 2011

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 ott 2010

    3 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 30 ott 2009

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Wayne Kisten il 03 nov 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Nicholas Mannion il 03 nov 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Gerard Keenan il 03 nov 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Miss Catherine Leith il 03 nov 2009

    1 pagineCH03

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 ott 2008

    3 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio di esenzione totale redatto al 26 ott 2007

    10 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di MECO INTERNATIONAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HODGETTS, Catherine
    Bromyard Road
    St Johns
    WR2 5EG Worcester
    Meco Works
    Worcestershire
    England
    Segretario
    Bromyard Road
    St Johns
    WR2 5EG Worcester
    Meco Works
    Worcestershire
    England
    British134612370013
    KEENAN, Gerard
    Seaman Way
    Ince
    WN2 2LE Wigan
    Wigan Enterprise Park,
    Lancashire
    England
    Amministratore
    Seaman Way
    Ince
    WN2 2LE Wigan
    Wigan Enterprise Park,
    Lancashire
    England
    United KingdomBritish80800810001
    KISTEN, Wayne
    Bromyard Road
    St Johns
    WR2 5EG Worcester
    Meco Works
    Worcestershire
    England
    Amministratore
    Bromyard Road
    St Johns
    WR2 5EG Worcester
    Meco Works
    Worcestershire
    England
    United KingdomSouth African124137710002
    MANNION, Michael Nicholas
    Kirkby Lane
    Pinxton
    NG16 6HX Nottingham
    Sales And Service Centre
    England
    Amministratore
    Kirkby Lane
    Pinxton
    NG16 6HX Nottingham
    Sales And Service Centre
    England
    EnglandBritish160671010001
    CARPENTER, David Noel Arthur
    East Folly
    Gretton Road Gotherington
    GL52 4QY Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    East Folly
    Gretton Road Gotherington
    GL52 4QY Cheltenham
    Gloucestershire
    British2438120001
    MAHMOOD, Tariq
    23 Cedar Avenue
    SK15 3GD Stalybridge
    Cheshire
    Segretario
    23 Cedar Avenue
    SK15 3GD Stalybridge
    Cheshire
    British108366970001
    RICHARDSON, Keith John
    17 Ilkeston Drive
    Aspull
    WN2 1QZ Wigan
    Segretario
    17 Ilkeston Drive
    Aspull
    WN2 1QZ Wigan
    British47835670001
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Segretario nominato
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    900000320001
    BODDINGTON, Kenneth William
    4 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    4 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    British1343490001
    BRUCE, Roderick Lawrence
    Rosehill
    23 Inveresk Village
    Inveresk
    East Lothian
    Amministratore delegato nominato
    Rosehill
    23 Inveresk Village
    Inveresk
    East Lothian
    British900003110001
    BUCKMASTER, Adrian Charles
    The Close Holdfast
    Upton Upon Severn
    WR8 0QZ Worcester
    Amministratore
    The Close Holdfast
    Upton Upon Severn
    WR8 0QZ Worcester
    EnglandBritish56273950001
    CARPENTER, David Noel Arthur
    East Folly
    Gretton Road Gotherington
    GL52 4QY Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    East Folly
    Gretton Road Gotherington
    GL52 4QY Cheltenham
    Gloucestershire
    British2438120001
    CORBY, Francis Michael
    18960 Alta Vista Drive
    Brookfield
    Wisconsin Wi 53045-4885
    Usa
    Amministratore
    18960 Alta Vista Drive
    Brookfield
    Wisconsin Wi 53045-4885
    Usa
    American44507660001
    HANSON, John Nils
    4015 West Canterbury Court
    WI 53092 Mequon
    Wisconsin
    Usa
    Amministratore
    4015 West Canterbury Court
    WI 53092 Mequon
    Wisconsin
    Usa
    American45718750001
    HARDING, Peter
    Bungalow
    Low Road
    DN10 6AG Scrooby
    New Farm
    South Yorkshire
    Amministratore
    Bungalow
    Low Road
    DN10 6AG Scrooby
    New Farm
    South Yorkshire
    EnglandBritish3743800002
    JOHNSON, Arthur David
    Rufford Lodge
    Rufford Abbey Park
    NG22 9DE Ollerton Newark
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Rufford Lodge
    Rufford Abbey Park
    NG22 9DE Ollerton Newark
    Nottinghamshire
    EnglandBritish1150990001
    JORDAN, Robert
    Ledgewood
    Ryland Road Barford
    CV35 8BY Warwick
    Warwickshire
    Amministratore
    Ledgewood
    Ryland Road Barford
    CV35 8BY Warwick
    Warwickshire
    United KingdomBritish12834990001
    LOEWENTHAL, Andrew James
    27 Britannia Road
    SW6 2HJ London
    Amministratore
    27 Britannia Road
    SW6 2HJ London
    Australian1327430001
    MINTO, Bruce Watson
    1 Oxford Terrace
    EH4 1PX Edinburgh
    Amministratore
    1 Oxford Terrace
    EH4 1PX Edinburgh
    British36629160001
    PARSONS, Howard Robert
    Briar House
    Church Lane
    WR7 4RS Stoulton Pershore
    Worcestershire
    Amministratore
    Briar House
    Church Lane
    WR7 4RS Stoulton Pershore
    Worcestershire
    British108355830001
    POWELL, George Christopher James
    16 Wellington Square
    GL50 4JS Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    16 Wellington Square
    GL50 4JS Cheltenham
    Gloucestershire
    British71388200001
    POWELL, James
    27 Ellington Street
    N7 8PN London
    Amministratore
    27 Ellington Street
    N7 8PN London
    British893290001
    RICHARDSON, Keith John
    17 Ilkeston Drive
    Aspull
    WN2 1QZ Wigan
    Amministratore
    17 Ilkeston Drive
    Aspull
    WN2 1QZ Wigan
    British47835670001
    ROONEY, Gerard
    354 Oakmount Drive
    Abingdon Virginia 24210
    Usa
    Amministratore
    354 Oakmount Drive
    Abingdon Virginia 24210
    Usa
    British18080080001
    SPEDDING, Matthew
    PO BOX 409 Rd.No.4
    Canterbury Trail, Mars
    FOREIGN Pennsylvania
    Usa
    Amministratore
    PO BOX 409 Rd.No.4
    Canterbury Trail, Mars
    FOREIGN Pennsylvania
    Usa
    British1176160001
    WALKER, John Hirst
    25 Hallside Park
    WA16 6BP Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    25 Hallside Park
    WA16 6BP Knutsford
    Cheshire
    British1176150003
    WILLS, Robert Joseph
    Perry Mill House
    Flyford Flavel
    WR7 4DA Worcester
    Amministratore
    Perry Mill House
    Flyford Flavel
    WR7 4DA Worcester
    British1176170001

    MECO INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Floating charge
    Creato il 05 lug 2001
    Consegnato il 13 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transazioni
    • 13 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 15 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 22 mar 2001
    Consegnato il 30 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 26 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 22 feb 1993
    Consegnato il 01 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due by longwall international LTD and others
    Brevi particolari
    See paper apart to document.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC as Trustee for Itself & Others
    Transazioni
    • 01 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Guarantee & debenture (junior)
    Creato il 12 ago 1989
    Consegnato il 23 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Westpac Banking Corporation as Agent and Trustee for Itself and Others
    Transazioni
    • 23 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • Ha modifiche all'ordine:
    Guarantee & debenture (senior)
    Creato il 12 mag 1989
    Consegnato il 23 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Westpac Banking Corporation as Agent and Trustee for Itself and Others
    Transazioni
    • 23 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 24 feb 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:

    MECO INTERNATIONAL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 ago 2013Data di scioglimento
    31 mag 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Gilbert John Lemon
    Portwell Place Portwell Lane
    BS1 6NA Bristol
    Praticante
    Portwell Place Portwell Lane
    BS1 6NA Bristol
    Neil Francis Hickling
    Marmion House 3 Copenhagen Street
    WR1 2HB Worcester
    Praticante
    Marmion House 3 Copenhagen Street
    WR1 2HB Worcester
    Notescottish-insolvency-info

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0