MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC115235 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED?
- Costruzione di edifici commerciali (41201) / Costruzioni
Dove si trova MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 201 West George Street C/O Miller Developments G2 2LW Glasgow Lanarkshire Scotland |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| MILLER (ASIA) LIMITED | 28 ott 1996 | 28 ott 1996 |
| MILLER OVERSEAS LIMITED | 29 nov 1994 | 29 nov 1994 |
| MILLER JOINT VENTURES LIMITED | 30 mag 1989 | 30 mag 1989 |
| SLOTBRIGHT LIMITED | 16 dic 1988 | 16 dic 1988 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 apr 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Sutherland il 16 ott 2020 | 2 pagine | CH01 | ||
Notifica di Milsut2 Limited come persona con controllo significativo il 30 lug 2020 | 2 pagine | PSC02 | ||
Cessazione di F&J Ventures Limited come persona con controllo significativo il 30 lug 2020 | 1 pagine | PSC07 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 apr 2020 | 10 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 mag 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2019 al 30 apr 2020 | 1 pagine | AA01 | ||
Modifica dei dettagli di F&J Ventures Limited come persona con controllo significativo il 11 feb 2020 | 2 pagine | PSC05 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 201 West George Street C/O Miller Developments Glasgow G2 2LW Scotland a 201 West George Street C/O Miller Developments Glasgow Lanarkshire G2 2LW in data 05 feb 2020 | 1 pagine | AD01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL a 201 West George Street C/O Miller Developments Glasgow G2 2LW in data 04 feb 2020 | 1 pagine | AD01 | ||
Cessazione di Mdl Investments Limited come persona con controllo significativo il 22 apr 2019 | 3 pagine | PSC07 | ||
Notifica di F&J Ventures Limited come persona con controllo significativo il 22 apr 2019 | 4 pagine | PSC02 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 mag 2019 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2018 | 12 pagine | AA | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Miller House 2 Lochside View Edinburgh Park Edinburgh EH12 9DH a 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL in data 25 gen 2019 | 2 pagine | AD01 | ||
Soddisfazione dell'onere SC1152350004 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2017 | 15 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 mag 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2016 | 16 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Euan James Edward Haggerty come amministratore in data 30 giu 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di un amministratore | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Kirsty Fraser Macgregor come segretario in data 31 mag 2017 | 1 pagine | TM02 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Chi sono gli amministratori di MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLOY, David Thomas | Amministratore | West George Street C/O Miller Developments G2 2LW Glasgow 201 Lanarkshire Scotland | Scotland | British | 76474600001 | |||||
| SUTHERLAND, Andrew | Amministratore | West George Street C/O Miller Developments G2 2LW Glasgow 201 Lanarkshire Scotland | Canada | British | 66368290041 | |||||
| DONALDSON, Euan James | Segretario | 28 Trainers Brae EH39 4NR North Berwick East Lothian | British | 41273760002 | ||||||
| DUFFIELD, Sheelagh Jane | Segretario | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | British | 170591090001 | ||||||
| LAWSON, Gordon Kenneth | Segretario | 5 Trench Knowe EH10 7HL Edinburgh | British | 145330001 | ||||||
| MACGREGOR, Kirsty Fraser | Segretario | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | 195963090001 | |||||||
| MACKINNON, Iain Lachlan | Segretario | 1 Hermitage Drive EH10 6DE Edinburgh | British | 66282570001 | ||||||
| SMYTH, Pamela June | Segretario | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | British | 65057960002 | ||||||
| BALLARD, Michael George | Amministratore | 72 Craigleith View EH4 3JY Edinburgh Midlothian | British | 42894290001 | ||||||
| BORLAND, Donald William | Amministratore | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | United Kingdom | British | 66010670002 | |||||
| BRADBURY, Toby Jonathan | Amministratore | Hillsgate Chapel Lane Penistone S36 6AQ Sheffield | British | 55511210001 | ||||||
| CLARK, Alexander Wilson | Amministratore | 44 Birkhill Road Cambusbarron FK7 9JS Stirling Stirlingshire | British | 500420001 | ||||||
| CLARKE, Robert Anthony | Amministratore | 6 The Paddock Sandy Loan EH31 2BW Gullane East Lothian | British | 3221280003 | ||||||
| HAGGERTY, Euan James Edward | Amministratore | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | Scotland | British | 162679260001 | |||||
| HODSDEN, Richard David | Amministratore | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | England | British | 183337930001 | |||||
| IKE, Henry Max | Amministratore | 6 Hutton Close Nether Poppleton YO26 6PJ York North Yorkshire | Dutch | 67313250001 | ||||||
| JACKSON, Julie Mansfield | Amministratore | 31 Inverleith Gardens EH3 5PR Edinburgh | United Kingdom | British | 94193070001 | |||||
| JOHNSTON, Neil William | Amministratore | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | United Kingdom | British | 109876070001 | |||||
| JOHNSTON, Neil William | Amministratore | 12 Winton Gardens EH10 7ET Edinburgh | British | 58059470001 | ||||||
| LAMB, Alan Clive | Amministratore | 17 Chetwynd Road SO16 3JA Southampton Hampshire | British | 61933620001 | ||||||
| MCCULLOCH, Robert Mitchell Ogilvie | Amministratore | The Saplings 16 Church Lane Bardsey LS17 9DN Leeds West Yorkshire | British | 27174530001 | ||||||
| MILLER, Keith Manson | Amministratore | Cherry Hollows 1(B)Easter Belmont Road EH12 6EX Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 546650002 | |||||
| MILLER, Philip Hartley | Amministratore | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | Scotland | British | 28512070005 | |||||
| OGILVIE, Ian | Amministratore | 12 Old Boyne Hill Farm Wood Lane Chapelthorpe WF4 3JL Wakefield West Yorkshire | British | 42582570002 | ||||||
| PEET, Roderick | Amministratore | Laughton House 23 Hailgate, Howden DN14 7SL Goole North Humberside | England | British | 67313470001 | |||||
| RICHARDS, John Steel | Amministratore | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | United Kingdom | British | 1318380002 | |||||
| RICHARDS, John Steel | Amministratore | 21 Lovedale Road EH14 7DW Balerno Glendaruel | United Kingdom | British | 1318380001 | |||||
| SHAW, John Clifford Barratt | Amministratore | Portelet 61 Oldway Drive B91 3HP Solihull West Midlands | United Kingdom | British | 18542070001 | |||||
| SMYTH, Pamela June | Amministratore | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | Scotland | British | 65057960002 | |||||
| WOOD, Marlene | Amministratore | 15 Ormidale Terrace EH12 6DY Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 31152030002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milsut2 Limited | 30 lug 2020 | West George Street G2 2LW Glasgow 201 Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| F&J Ventures Limited | 22 apr 2019 | West George Street C/O Miller Developments G2 2LW Glasgow 201 Lanarkshire Scotland | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Mdl Investments Limited | 06 apr 2016 | 133-137 Alexandra Road Wimbledon SW19 7JY London Connect House United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 08 ott 2015 Consegnato il 14 ott 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 29 feb 2012 Consegnato il 08 mar 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Bond & floating charge | Creato il 29 feb 2012 Consegnato il 08 mar 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 20 apr 1999 Consegnato il 30 apr 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0