JAMES KENNEDY & CO LIMITED

JAMES KENNEDY & CO LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJAMES KENNEDY & CO LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC115708
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di JAMES KENNEDY & CO LIMITED?

    • (7011) /

    Dove si trova JAMES KENNEDY & CO LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    33 Castle Street
    Edinburgh
    EH2 3DN
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di JAMES KENNEDY & CO LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    JAMES KENNEDY CO. LIMITED20 gen 198920 gen 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di JAMES KENNEDY & CO LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per JAMES KENNEDY & CO LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Andrew White come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Kennedy come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 15 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 dic 2009

    Stato del capitale al 15 dic 2009

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Possible conflict of interest 15/12/2008
    RES13

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 30 giu 2008

    10 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 lug 2007

    10 pagineAA

    legacy

    1 pagine225

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 lug 2006

    11 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 lug 2005

    11 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 lug 2004

    11 pagineAA

    legacy

    8 pagine363s

    Chi sono gli amministratori di JAMES KENNEDY & CO LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    Segretario
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    BritishChartered Accountant462890002
    KENNEDY, Patricia Alice
    Hazlieburn
    EH46 7AS West Linton
    Peeblesshire
    Segretario
    Hazlieburn
    EH46 7AS West Linton
    Peeblesshire
    British224880001
    MCCALL, Peter Michael
    19 Bonaly Terrace
    EH13 0EL Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    19 Bonaly Terrace
    EH13 0EL Edinburgh
    Midlothian
    BritishSolicitor119269620001
    CHIENE & TAIT
    61 Dublin Street
    EH3 6NL Edinburgh
    Segretario
    61 Dublin Street
    EH3 6NL Edinburgh
    99191230001
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    Amministratore
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    ScotlandBritishChartered Accountant462890002
    KENNEDY, John Anthony Bingham
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    Amministratore
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    ScotlandBritishChartered Surveyor71043680001
    KENNEDY, Patricia Alice
    Newhall
    EH26 9LY Carlops
    Midlothian
    Scotland
    Amministratore
    Newhall
    EH26 9LY Carlops
    Midlothian
    Scotland
    ScotlandBritishDirector168440970002
    ROBSON, Ronald Alexander
    19 Glasclune Gardens
    EH39 4RB North Berwick
    East Lothian
    Amministratore
    19 Glasclune Gardens
    EH39 4RB North Berwick
    East Lothian
    ScotlandBritishChartered Accountant104673590001
    THOMSON, William George Ritchie
    6 Oswald Road
    EH9 2HF Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    6 Oswald Road
    EH9 2HF Edinburgh
    Midlothian
    BritishChartered Accountant72331280001
    WHITE, Andrew Edward
    Craigend
    2 Cromwell Road
    EH39 4LZ North Berwick
    East Lothian
    Amministratore
    Craigend
    2 Cromwell Road
    EH39 4LZ North Berwick
    East Lothian
    ScotlandBritishChartered Surveyor110163980001

    JAMES KENNEDY & CO LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 24 mar 1999
    Consegnato il 06 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    10, 12 and 14 egerton street, and 22, 24 and 26 lord street, wrexham.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 27 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 24 mar 1999
    Consegnato il 30 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    10, 12 and 14 egerton street & 22, 24 and 26 lord street, wrexham.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 27 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 05 nov 1998
    Consegnato il 11 nov 1998
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    26 & 28 reform street,dundee.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    Legal charge
    Creato il 25 mar 1998
    Consegnato il 06 apr 1998
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    213 & 215 commercial road,portsmouth,hampshire.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 18 dic 1997
    Consegnato il 19 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Regent house, renfield street, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 08 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 24 giu 1997
    Consegnato il 04 lug 1997
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    A fixed charge over all free-hold property known as 73-75 granger street and 1-3 newgate street,newcastle-upon-tyne.......with floating charge.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    Legal charge
    Creato il 24 giu 1997
    Consegnato il 04 lug 1997
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    A fixed cahrge over all freehold property known as units 2,3 and 4 grange road,birkenhead.................with floating charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 12 mar 1997
    Consegnato il 19 mar 1997
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    2,4,6,8 & 10 alloway street,ayr.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    Legal charge
    Creato il 30 ago 1996
    Consegnato il 10 set 1996
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Westminster house,fleet road,fleet,hampshire.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 set 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    Legal charge
    Creato il 15 mag 1995
    Consegnato il 02 giu 1995
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The woolmarket, dyer street, cirencester, gloucestershire.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    Legal charge
    Creato il 06 mag 1994
    Consegnato il 13 mag 1994
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due by the company and another
    Brevi particolari
    The freehold and leasehold property known as land and buildings at dunford road and elliot road, lincoln.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    Legal charge
    Creato il 06 mag 1994
    Consegnato il 13 mag 1994
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due by the company and another
    Brevi particolari
    The freehold and leasehold property known as land and buildings at dunford road & elliott road, lincoln.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 29 nov 1993
    Consegnato il 06 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    227/241 high street, arbroath.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 15 lug 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 11 nov 1993
    Consegnato il 23 nov 1993
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 27 nov 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (419b)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0