SCOTTISH SEAFOODS LIMITED
Panoramica
Nome della società | SCOTTISH SEAFOODS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | SC118977 |
Giurisdizione | Scozia |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SCOTTISH SEAFOODS LIMITED?
- Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi (10200) / Industrie manifatturiere
Dove si trova SCOTTISH SEAFOODS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 319 St. Vincent Street G2 5AS Glasgow |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SCOTTISH SEAFOODS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
M M & S (2013) LIMITED | 10 lug 1989 | 10 lug 1989 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SCOTTISH SEAFOODS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per SCOTTISH SEAFOODS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Conto finale prima della dissoluzione in MVL (conto finale allegato) | 7 pagine | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Kpmg Llp Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG a 319 st. Vincent Street Glasgow G2 5AS in data 14 mag 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 60-64 Port Street Annan Dumfriesshire DG12 6BW a C/O Kpmg Llp Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG in data 17 lug 2020 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Stato del capitale al 23 mar 2020
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Jenny Nancy Loncaster come amministratore in data 25 set 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 lug 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy Mark Busby come amministratore in data 12 set 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2019 al 31 mar 2020 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Nomina di Mr Michael Kamiel Jan Alfons Kestemont come amministratore in data 04 lug 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Wilkin Chapman Company Secretarial Services Limited come segretario in data 04 lug 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 lug 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Timothy Mark Busby come amministratore in data 31 dic 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Malcolm Herbert Lofts come amministratore in data 31 dic 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 lug 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2016 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 lug 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 lug 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di SCOTTISH SEAFOODS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESTEMONT, Michael Kamiel Jan Alfons | Amministratore | St. Vincent Street G2 5AS Glasgow 319 | United Kingdom | Belgian | Director | 231792890001 | ||||||||
WILSON, Andrew George Richard | Segretario | Cononley Hall Main Street Cononley BD20 8LJ Skipton West Yorkshire | British | 47433990002 | ||||||||||
WRIGHT, James Leonard | Segretario | 32 Devonshire Avenue DN32 0BW Grimsby N.E. Lincolnshire | British | 714180001 | ||||||||||
MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5NJ Glasgow 151 | 900003400001 | |||||||||||
MITRE SECRETARIES LIMITED | Segretario | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 38565160001 | |||||||||||
MITRE SECRETARIES LIMITED | Segretario | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 38565160001 | |||||||||||
WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | PO BOX 16 New Oxford House Town Hall Square DN31 1HE Grimsby New Oxford House North East Lincolnshire United Kingdom |
| 75197930001 | ||||||||||
BRITTON, Christopher Paul | Amministratore | Main Street Sicklinghall LS22 4AP Wetherby Park Grange West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 127835580001 | ||||||||
BUSBY, Timothy Mark | Amministratore | 60-64 Port Street Annan DG12 6BW Dumfriesshire | England | English | Director | 169852920001 | ||||||||
CANE, James Robert | Amministratore | Chapel House Brigg Road LN7 6PQ South Kelsey Lincolnshire | United Kingdom | British | Company Director | 104635350001 | ||||||||
FLEAR, Frank Alan | Amministratore | 93 High Street Waltham DN37 0PN Grimsby North East Lincolnshire | British | Company Director | 2785880001 | |||||||||
FORBES, Hamish Drummond | Amministratore | 60-64 Port Street Annan DG12 6BW Dumfriesshire | England | British | Chartered Accountant | 66295550001 | ||||||||
GRIFFITHS, Wynne Philip Morgan | Amministratore | Hawerby Hall DN36 5PX Hawerby Cum Beesby Lincolnshire | United Kingdom | British | Director | 58713750002 | ||||||||
HARKJAER, Per | Amministratore | Oakridge House 6 Montrose Gardens Oxshott KT22 0UU Leatherhead Surrey | England | Danish | Director | 127032620001 | ||||||||
LEADBETTER, Stephen Paul | Amministratore | Mill Lane Legbourne LN11 8LT Louth Allt-Nam-Breac Lincolnshire | England | British | Director | 132911790001 | ||||||||
LOFTS, Malcolm Herbert | Amministratore | 60-64 Port Street Annan DG12 6BW Dumfriesshire | England | British | Finance Director | 177239110001 | ||||||||
LOFTS, Malcolm Herbert | Amministratore | 37 Brigsley Road Waltham DN37 0JX Grimsby North East Lincolnshire | United Kingdom | British | Director | 31098840002 | ||||||||
LONCASTER, Jenny Nancy | Amministratore | 60-64 Port Street Annan DG12 6BW Dumfriesshire | England | British | Finance Director | 185296540001 | ||||||||
PARKER, Michael | Amministratore | Humber Lodge Old Post Office Lane South Ferriby DN18 6HH Barton Upon Humber N E Lincolnshire | United Kingdom | British | Director | 2785890001 | ||||||||
RUFFELL WARD, Brian | Amministratore | Tudor Garth 18a Stallingborough Road Healing DN41 7QN Grimsby North East Lincolnshire | British | Company Director | 72694900001 | |||||||||
SUTHERLAND, Innes | Amministratore | Sutherley Nook Elsham DN20 0RG Brigg North East Lincolnshire | England | British | Company Director | 1064160001 | ||||||||
THOMAS, Andrew George | Amministratore | 14 Mount View Woodgates Lane HU14 3JG North Ferriby East Yorkshire | British | Company Director | 40002910008 | |||||||||
WILSON, Andrew George Richard | Amministratore | Cononley Hall Main Street Cononley BD20 8LJ Skipton West Yorkshire | British | Finance Director | 47433990002 | |||||||||
VINDEX LIMITED | Amministratore delegato nominato | 151 St Vincent Street G2 5NJ Glasgow | 900003390001 | |||||||||||
VINDEX SERVICES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 151 St Vincent Street G2 5NJ Glasgow | 900003380001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SCOTTISH SEAFOODS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Young's Seafood Limited | 06 apr 2016 | Wickham Road DN31 3SW Grimsby Ross House North East Lincolnshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
SCOTTISH SEAFOODS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 23 ott 2008 Consegnato il 05 nov 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due all sums due or to become due | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 21 mar 2007 Consegnato il 31 mar 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Fixed charges by way of legal mortgage all material premises, all the subsidary shares and investments and distribution rights, all other interests in any material premises, all plant machinery vehicles computers office and other equipment, all book debts - see form 410 appendix 2 for further details including floating charge over all assets. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 16 mar 2006 Consegnato il 29 mar 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due under the finance documents | |
Brevi particolari First legal mortgage over all material premises; first fixed and floating charges over assets. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Floating charge | Creato il 12 dic 2005 Consegnato il 20 dic 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 23 set 2002 Consegnato il 03 ott 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Tenants interest in the lease over goat island, stornoway. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Floating charge | Creato il 05 ago 2002 Consegnato il 13 ago 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Legal mortgage over property; fixed charges over asets; floating charge over same. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 10 dic 1998 Consegnato il 18 dic 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Tenants interest in the lease over goat island 1,stornoway. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of charge | Creato il 25 ott 1998 Consegnato il 09 nov 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari The land and premises in folio 28273,folio 33933,folio 3222, county down. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of charge | Creato il 25 ott 1998 Consegnato il 09 nov 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Factory no.2,rooney road,kilkeel,county down. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of charge | Creato il 25 ott 1998 Consegnato il 09 nov 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Factory no.1,harbour road,kilkeel,county down,northern ireland. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed charge on book debts | Creato il 25 ott 1998 Consegnato il 09 nov 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari All the book debts of the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Bond & floating charge | Creato il 25 ott 1998 Consegnato il 09 nov 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
SCOTTISH SEAFOODS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0