TELEWEST COMMUNICATIONS (GLENROTHES) LIMITED
Panoramica
Nome della società | TELEWEST COMMUNICATIONS (GLENROTHES) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | SC119523 |
Giurisdizione | Scozia |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TELEWEST COMMUNICATIONS (GLENROTHES) LIMITED?
- Altre attività di telecomunicazioni (61900) / Informazione e comunicazione
Dove si trova TELEWEST COMMUNICATIONS (GLENROTHES) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Atria One 144 Morrison Street EH3 8EX Edinburgh |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TELEWEST COMMUNICATIONS (GLENROTHES) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
KINGDOM CABLEVISION LIMITED | 22 mar 1990 | 22 mar 1990 |
PLACE D'OR 197 LIMITED | 16 ago 1989 | 16 ago 1989 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TELEWEST COMMUNICATIONS (GLENROTHES) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per TELEWEST COMMUNICATIONS (GLENROTHES) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Conto finale prima della dissoluzione in MVL (conto finale allegato) | 9 pagine | LIQ13(Scot) | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 1 South Gyle Crescent Lane Edinburgh EH12 9EG | 2 pagine | AD03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 1 South Gyle Crescent Lane Edinburgh EH12 9EG | 2 pagine | AD02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 1 South Gyle Crescent Lane Edinburgh EH12 9EG a Atria One 144 Morrison Street Edinburgh EH3 8EX in data 16 dic 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Vmed O2 Secretaries Limited come segretario in data 01 nov 2021 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Gillian Elizabeth James come segretario in data 01 nov 2021 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mine Ozkan Hifzi come amministratore in data 01 nov 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
legacy | 91 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT1 | ||||||||||
Cessazione della carica di Caroline Bernadette Elizabeth Withers come amministratore in data 01 ott 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Roderick Gregor Mcneil come amministratore in data 01 ott 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Mark David Hardman come amministratore in data 01 ott 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Julia Louise Boyle come amministratore in data 01 ott 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Luke Milner come amministratore in data 31 ago 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE1 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Caroline Bernadette Elizabeth Withers il 26 apr 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Luke Milner come amministratore in data 01 mar 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
legacy | 89 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 2 pagine | AGREEMENT1 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Severina-Pompilia Pascu come amministratore in data 16 nov 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE1 | ||||||||||
Nomina di Caroline Bernadette Elizabeth Withers come amministratore in data 23 apr 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di TELEWEST COMMUNICATIONS (GLENROTHES) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMED O2 SECRETARIES LIMITED | Segretario | Bath Road SL1 4DX Slough 260 Berkshire United Kingdom |
| 79050630041 | ||||||||||
BOYLE, Julia Louise | Amministratore | 144 Morrison Street EH3 8EX Edinburgh Atria One | United Kingdom | British | Solicitor | 287980330001 | ||||||||
HARDMAN, Mark David | Amministratore | 144 Morrison Street EH3 8EX Edinburgh Atria One | United Kingdom | British | Accountant | 201468840001 | ||||||||
BROADEST, Guy David | Segretario | Tile House Woodland Drive KT24 5AN East Horsley Surrey | British | 96454660001 | ||||||||||
BURNS, Clive | Segretario | The Cottage Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood AL4 8RX Wheathampstead Hertfordshire | British | 71073800001 | ||||||||||
HULL, Victoria Mary, Sol | Segretario | Flat 2 53 Palace Gardens Terrace Kensington W8 4SB London | British | 77283810001 | ||||||||||
JAMES, Gillian Elizabeth | Segretario | 1 South Gyle Crescent Lane Edinburgh EH12 9EG | 151396100001 | |||||||||||
LAVER, John Michael | Segretario | Brook House Homestead Road TN8 6JD Edenbridge Kent | British | 8207040001 | ||||||||||
PETERKINS, SOLICITORS | Segretario nominato | 100 Union Street AB10 1QR Aberdeen | 900006310001 | |||||||||||
SHEPHERD & WEDDERBURN | Segretario nominato | Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2ET Edinburgh | 900030690001 | |||||||||||
THORNTONS WS | Segretario nominato | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee Tayside | 900003090001 | |||||||||||
VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED | Segretario | 160 Great Portland Street W1W 5QA London | 101107380002 | |||||||||||
ANDERSON, Philip Edward | Amministratore | 29 Rubislaw Den North AB2 4AL Aberdeen Aberdeenshire | British | Solicitor | 395240001 | |||||||||
BRYAN, Danny Frank | Amministratore | The Marble Suite The Mansion Ottershaw Park KT16 0QG Ottershaw Surrey | American | Director | 41071470001 | |||||||||
BRYSON, Gary Spath | Amministratore | 5132 South Hanover Street 80111 Englewood Colorado Usa | American | Executive | 36182070001 | |||||||||
BURDICK, Charles James | Amministratore | 9 Ormonde Place SW1W 8HX London | British-American | Managing Director | 52311710004 | |||||||||
CARLETON, Lawrence James | Amministratore | The Marble Suite The Mansion KT16 0QG Ottershaw Park Ottershaw Surrey | American | Cable Television Executive | 36182000001 | |||||||||
CASTELL, William Thomas | Amministratore | 1 South Gyle Crescent Lane Edinburgh EH12 9EG | England | British | Chief Financial Officer | 248424970001 | ||||||||
COHEN, Martin | Amministratore | 5024 Baltan Road Bethesda 20816 Maryland | American | Director | 1161930003 | |||||||||
COOK, Stephen Sands | Amministratore | 24a Redcliffe Square SW10 9JY London | British | Solicitor | 73000530008 | |||||||||
DAVIDSON, Stephen James | Amministratore | Hughenden Close Denner Hill HP16 0JJ Great Missenden Buckinghamshire | United Kingdom | British | Financial Director | 92784240001 | ||||||||
DUNCAN, Graham John | Amministratore | Craigentoul 16 Hillhead Road Bieldside AB15 9EJ Aberdeen Grampian | British | Ca | 869820001 | |||||||||
DUNN, Robert Dominic | Amministratore | 1 South Gyle Crescent Lane Edinburgh EH12 9EG | England | British | Chief Financial Officer | 179134020002 | ||||||||
GALE, Robert Charles | Amministratore | 1 South Gyle Crescent Lane Edinburgh EH12 9EG | England | British | Accountant | 96956740001 | ||||||||
HAMACHEK, Ross Frank | Amministratore | 5011 Sedgwick Street 20016 Nw Washington Dc Usa 20016 | American | 4948230001 | ||||||||||
HARTSON, Ted Ellito | Amministratore | 10012 North 77th Street 85285 Scottsdale Arizona Usa | American | Director | 32560160001 | |||||||||
HIFZI, Mine Ozkan | Amministratore | 1 South Gyle Crescent Lane Edinburgh EH12 9EG | England | British | Solicitor | 182167230001 | ||||||||
HILLMAN, Antony Royston | Amministratore | La Chasse La Cache De Leglise, St. Ouen JE3 2LA Jersey Channel Islands | British | Solicitor | 88860880001 | |||||||||
HULL, Victoria Mary, Sol | Amministratore | Flat 2 53 Palace Gardens Terrace Kensington W8 4SB London | British | Solicitor | 77283810001 | |||||||||
HUNTER, Neil Cameron | Amministratore delegato nominato | Northwater House 6 High Street DD9 7TE Edzell Angus | British | 900006300001 | ||||||||||
ILLSLEY, Anthony Kim | Amministratore | 4 St Peters Road TW1 1QX Twickenham Middlesex | United Kingdom | British | Chief Executive | 43836970001 | ||||||||
LAWTIE, David Mcnab | Amministratore | 46 Gray Street AB1 6JE Aberdeen Aberdeenshire | British | Solicitor | 740200001 | |||||||||
MACKENZIE, Robert Mario | Amministratore | Great Portland Street W1W 5QA London 160 London United Kingdom | United Kingdom | British | Solicitor | 47785600002 | ||||||||
MCNEIL, Roderick Gregor | Amministratore | 1 South Gyle Crescent Lane Edinburgh EH12 9EG | United Kingdom | British | Deputy Chief Financial Officer | 267964620001 | ||||||||
MICHELS, Alan | Amministratore | Catalina Abbotswood Drive St Georges Hill KT13 0LT Weybridge Surrey | British | Managing Director | 43658810001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di TELEWEST COMMUNICATIONS (GLENROTHES) LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Cable Limited | 04 lug 2017 | Brook Drive RG2 6UU Reading 500 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Telewest Communications (Scotland Holdings) Limited | 06 apr 2016 | South Gyle Crescent Lane EH12 9EG Edinburgh 1 United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
TELEWEST COMMUNICATIONS (GLENROTHES) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 21 mar 2017 Consegnato il 23 mar 2017 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 01 feb 2017 Consegnato il 07 feb 2017 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione N/A. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 26 apr 2016 Consegnato il 27 apr 2016 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 30 apr 2015 Consegnato il 07 mag 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 30 mar 2015 Consegnato il 02 apr 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione N/A. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 28 gen 2015 Consegnato il 06 feb 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 04 apr 2014 Consegnato il 10 apr 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 28 mar 2014 Consegnato il 02 apr 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 07 giu 2013 Consegnato il 18 giu 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Confirmation deed | Creato il 03 mar 2011 Consegnato il 21 mar 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Pursuant to clause 12 of the group intercreditor agreement the new notes were hereby designated (see form MG01S). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite debenture | Creato il 10 giu 2010 Consegnato il 23 giu 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
Floating charge | Creato il 26 set 1998 Consegnato il 13 ott 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Floating charge | Creato il 24 lug 1996 Consegnato il 09 ago 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due by the company and others | |
Brevi particolari Fixed and floating charges on various assets....... See ch microfiche for full details. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Bond & floating charge | Creato il 24 lug 1996 Consegnato il 08 ago 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due by the company and others | |
Brevi particolari All property etc....... see ch microfiche for full details. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Floating charge | Creato il 13 giu 1994 Consegnato il 27 giu 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due by the company and others | |
Brevi particolari Fixed and floating charge see ch microfiche. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Bond & floating charge | Creato il 13 giu 1994 Consegnato il 27 giu 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
TELEWEST COMMUNICATIONS (GLENROTHES) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0