AHR REALISATIONS LIMITED

AHR REALISATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAHR REALISATIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC119878
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AHR REALISATIONS LIMITED?

    • (5510) /

    Dove si trova AHR REALISATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Erskine House
    68-73 Queen Street
    EH2 4NH Edinburgh
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di AHR REALISATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    AVIEMORE HIGHLAND RESORT LIMITED09 nov 200109 nov 2001
    AVIEMORE MOUNTAIN RESORT LIMITED17 dic 199217 dic 1992
    MARRSIDE LIMITED01 set 198901 set 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di AHR REALISATIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 set 2006

    Quali sono le ultime deposizioni per AHR REALISATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore

    14 pagine2.20B(Scot)

    Avviso di passaggio dall'amministrazione allo scioglimento

    1 pagine2.26B(Scot)

    Proposta dell'amministratore

    186 pagine2.16B(Scot)

    Stato patrimoniale con modulo allegato 2.14B(Scot)

    3 pagine2.15B(Scot)

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed aviemore highland resort LIMITED\certificate issued on 11/08/09
    3 pagineCERTNM

    Stato patrimoniale con modulo allegato 2.13B(Scot)

    114 pagine2.15B(Scot)

    Nomina di un amministratore

    3 pagine2.11B(Scot)

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    10 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    8 pagine363a

    Bilancio consolidato redatto al 28 set 2006

    22 pagineAA

    legacy

    12 pagine363a

    legacy

    10 pagine363a

    Bilancio consolidato redatto al 29 set 2005

    19 pagineAA

    legacy

    1 pagine244

    Chi sono gli amministratori di AHR REALISATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FRASER, Robert Gordon
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    Segretario
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    British120322350001
    MCGEE, Jeremiah
    East Terrace
    PH21 1JS Kingussie
    Kildonan
    Inverness Shire
    Amministratore
    East Terrace
    PH21 1JS Kingussie
    Kildonan
    Inverness Shire
    Irish138900330001
    GILLESPIE, Brendan
    56 Blairbeth Road
    Rutherglen
    G73 4JQ Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    56 Blairbeth Road
    Rutherglen
    G73 4JQ Glasgow
    Lanarkshire
    British65199400001
    GOULD, Frederick James
    Stoneygate The Hills
    Bradwell
    S33 9HZ Hope Valley
    Segretario
    Stoneygate The Hills
    Bradwell
    S33 9HZ Hope Valley
    British33226530001
    MAUD, Glenn
    Bents House Sugworth
    Bradfield Dale The Strines
    S6 6JA Sheffield
    Segretario
    Bents House Sugworth
    Bradfield Dale The Strines
    S6 6JA Sheffield
    British35518970002
    SMITH, David
    Firley
    17 Highlands Road Sear Green
    HP5 2XL Beaconfield
    Buckinghamshire
    Segretario
    Firley
    17 Highlands Road Sear Green
    HP5 2XL Beaconfield
    Buckinghamshire
    British74298510001
    BANKIER, Ian Patrick
    Flat 2/2, 168 Crow Road
    G11 7JU Glasgow
    Amministratore
    Flat 2/2, 168 Crow Road
    G11 7JU Glasgow
    ScotlandBritish103178050001
    BLOOM, Desmond Lawrence
    8 Hall Gate
    Hall Road
    NW8 9PG London
    Amministratore
    8 Hall Gate
    Hall Road
    NW8 9PG London
    British84564020001
    BROWNING, Patrick John
    26 Portland Road
    W11 4LG London
    Amministratore
    26 Portland Road
    W11 4LG London
    British8268410001
    BUSBY, James George William
    16 Fairyknowe Court
    Bothwell
    G71 8SZ Glasgow
    Amministratore
    16 Fairyknowe Court
    Bothwell
    G71 8SZ Glasgow
    United KingdomBritish584980007
    COLLINS, David
    122 Prince George Avenue
    N14 4TA London
    Amministratore
    122 Prince George Avenue
    N14 4TA London
    British8643430001
    CONRAD, Neville Simeon
    8 Kensington Palace Gardens
    W8 4QP London
    Amministratore
    8 Kensington Palace Gardens
    W8 4QP London
    British76640680003
    MACDONALD, Donald John
    Cardrona
    Glen Road
    FK15 0DT Dunblane
    Perthshire
    Amministratore
    Cardrona
    Glen Road
    FK15 0DT Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritish557590001
    MAUD, Glenn
    Bents House Sugworth
    Bradfield Dale The Strines
    S6 6JA Sheffield
    Amministratore
    Bents House Sugworth
    Bradfield Dale The Strines
    S6 6JA Sheffield
    United KingdomBritish35518970002
    NEWETT, David Ian
    Cockshutt Farm
    Beauchief Abbey Drive Beauchief
    S8 7BB Sheffield
    Amministratore
    Cockshutt Farm
    Beauchief Abbey Drive Beauchief
    S8 7BB Sheffield
    British35554190001
    ROBERTSON, Ian
    5 Boswall Road
    EH5 3RH Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    5 Boswall Road
    EH5 3RH Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish106197810002
    SULLIVAN, Sean Michael
    3 Fairwater Close
    WR11 1GF Evesham
    Worcestershire
    Amministratore
    3 Fairwater Close
    WR11 1GF Evesham
    Worcestershire
    British79118330001
    SUTHERLAND, David Fraser
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    Amministratore
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    ScotlandBritish1321720003
    TAYLOR, David Hunter
    Primrose Villa
    19 Glenbrook
    EH14 7JE Balerno
    Midlothian
    Amministratore
    Primrose Villa
    19 Glenbrook
    EH14 7JE Balerno
    Midlothian
    British70908350001

    AHR REALISATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security
    Creato il 30 apr 2004
    Consegnato il 30 apr 2004
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Two areas of ground lying to the west side of grampian road, aviemore extending to 150 feet and 0.7374 acres respectively.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 29 apr 2004
    Consegnato il 30 apr 2004
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Land forming a visibility splay at grampian road, aviemore and the subjects lying to the west of grampian road, aviemore (title number INV6274).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 15 apr 2004
    Consegnato il 16 apr 2004
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The area of ground extending to 3651 square metres or thereby lying to the rear of the cairngorm hotel, aviemore--title number INV3598.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 09 mag 2003
    Consegnato il 12 mag 2003
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    517.37 square metres & 233.40 square metres at aviemore.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 10 apr 1997
    Consegnato il 17 apr 1997
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Four seasons,grampian road,aviemore,invernessshire.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 23 ago 1994
    Consegnato il 13 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The waverley hotel,york place,perth including the properties formerly numbered 25 and 27 york place,perth.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 set 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 05 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 02 apr 1993
    Consegnato il 08 apr 1993
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The aviemore centre, aviemore (see paper apart to document).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 02 apr 1993
    Consegnato il 08 apr 1993
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The red macgregor hotel, aviemore, inverness (see paper apart to document).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (410)
    Floating charge
    Creato il 30 mar 1993
    Consegnato il 08 apr 1993
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 08 feb 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (419b)
    Standard security
    Creato il 11 ago 1992
    Consegnato il 17 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    7 dwellinghouses in aviemore.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 17 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 23 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 05 ago 1992
    Consegnato il 14 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Aviemore centre, aviemore, inverness.
    Persone aventi diritto
    • Scottish & Newcastle PLC
    Transazioni
    • 14 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 22 lug 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 03 ago 1992
    Consegnato il 05 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Scottish & Newcastle PLC
    Transazioni
    • 05 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 07 dic 1992Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 29 set 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Standard security
    Creato il 14 lug 1992
    Consegnato il 23 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The aviemore centre aviemore.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 29 giu 1992
    Consegnato il 15 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 14 dic 1992Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 07 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:

    AHR REALISATIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 giu 2010Fine dell'amministrazione
    19 giu 2009Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John Bruce Cartwright
    Pricewaterhousecoopers Llp Erskine House
    68-73 Queen Street
    EH2 4NH Edinburgh
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp Erskine House
    68-73 Queen Street
    EH2 4NH Edinburgh
    Graham Douglas Frost
    Erskine House
    68-73 Queen Street
    EH2 4NH Edinburgh
    Praticante
    Erskine House
    68-73 Queen Street
    EH2 4NH Edinburgh

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0