EDI (INDUSTRIAL) LIMITED

EDI (INDUSTRIAL) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEDI (INDUSTRIAL) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC119939
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EDI (INDUSTRIAL) LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari
    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova EDI (INDUSTRIAL) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Waverley Court
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Scotland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EDI (INDUSTRIAL) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ENTERPRISE EDINBURGH SERVICES LIMITED10 gen 199010 gen 1990
    PACIFIC SHELF 279 LIMITED04 set 198904 set 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di EDI (INDUSTRIAL) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per EDI (INDUSTRIAL) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Modifica dei dettagli di The Edi Group Ltd come persona con controllo significativo il 25 giu 2018

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 gen 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Nomina di Cllr Lezley Marion Cameron come amministratore in data 11 lug 2018

    2 pagineAP01

    Nomina di Cllr Iain Whyte come amministratore in data 11 lug 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Eric Weir Adair come amministratore in data 30 giu 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Cllr Katherine Rosa Campbell come amministratore in data 11 lug 2018

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    7 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 3 Cockburn Street Edinburgh EH1 1QB Scotland a Waverley Court 4 East Market Street Edinburgh EH8 8BG in data 19 giu 2018

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 gen 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 gen 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    7 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 7/9 North St. David Street Edinburgh EH2 1AW a 3 Cockburn Street Edinburgh EH1 1QB in data 24 lug 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 10 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 gen 2016

    Stato del capitale al 19 gen 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 gen 2015

    Stato del capitale al 12 gen 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    7 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * Dolphin House 4 Hunter Square Edinburgh EH1 1QW* in data 08 apr 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 10 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 gen 2014

    Stato del capitale al 14 gen 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Tom Buchanan come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di EDI (INDUSTRIAL) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CAMERON, Lezley Marion, Councillor
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    Amministratore
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    ScotlandBritishElected Councillor77460160001
    CAMPBELL, Katherine Rosa
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    Amministratore
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    United KingdomBritishElected Councillor233686000001
    WHYTE, Iain, Cllr
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    Amministratore
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    ScotlandBritishElected Councillor148139080002
    BLYTH, William
    Carradale 516 Lanark Road West
    EH14 7DH Balerno
    Midlothian
    Segretario
    Carradale 516 Lanark Road West
    EH14 7DH Balerno
    Midlothian
    British514950001
    MCGOWAN, Carol Ann
    374 Leith Walk
    EH7 4PE Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    374 Leith Walk
    EH7 4PE Edinburgh
    Midlothian
    BritishSolicitor112664200001
    WILSON, Mary
    3 Belgrave Road
    EH12 6NG Edinburgh
    Segretario
    3 Belgrave Road
    EH12 6NG Edinburgh
    British42188180001
    ADAIR, Eric Weir
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    Amministratore
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    ScotlandBritishFinance Director116185430001
    AITCHISON, Thomas Nisbet
    27 Dudley Terrace
    EH6 4QQ Edinburgh
    Amministratore
    27 Dudley Terrace
    EH6 4QQ Edinburgh
    BritishChief Executive43674840001
    ANDERSON, Donald Craig
    39 The Spinney
    EH17 7LE Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    39 The Spinney
    EH17 7LE Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishElected Member / Mlso48629740001
    ATKINSON, Elspeth, Dr
    The Rectory 203 Gilmore Place
    EH3 9PN Edinburgh
    Amministratore
    The Rectory 203 Gilmore Place
    EH3 9PN Edinburgh
    BritishHead Of Economic Development51045490001
    BARRETT, John
    3 Traquair Park West
    EH12 7AN Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    3 Traquair Park West
    EH12 7AN Edinburgh
    Midlothian
    BritishCompany Director728540001
    BEGG, David, Councillor
    29/9 Castle Terrace
    EH1 2EL Edinburgh
    Amministratore
    29/9 Castle Terrace
    EH1 2EL Edinburgh
    BritishLecturer48777780002
    BLYTH, William
    Carradale 516 Lanark Road West
    EH14 7DH Balerno
    Midlothian
    Amministratore
    Carradale 516 Lanark Road West
    EH14 7DH Balerno
    Midlothian
    BritishChief Executive514950001
    BUCHANAN, Tom
    Dolphin House
    4 Hunter Square
    EH1 1QW Edinburgh
    Amministratore
    Dolphin House
    4 Hunter Square
    EH1 1QW Edinburgh
    United KingdomBritishDirector123330960001
    CAMERON, Lezley Marion, Councillor
    12/5 Mayfield Terrace
    EH9 1SA Edinburgh
    Amministratore
    12/5 Mayfield Terrace
    EH9 1SA Edinburgh
    ScotlandBritishSelf Employed77460160001
    DALGETY, Susan
    16 Temple Park Crescent
    EH11 1HT Edinburgh
    Amministratore
    16 Temple Park Crescent
    EH11 1HT Edinburgh
    BritishJournalist103240003
    DI CIACCA, John Mark
    Main Road
    KY11 1HA North Queensferry
    The Red Post
    Fife
    Amministratore
    Main Road
    KY11 1HA North Queensferry
    The Red Post
    Fife
    United KingdomBritishSurveyor77111830002
    DREVER, Peng Geik
    13 Northumberland Street
    EH3 6LL Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    13 Northumberland Street
    EH3 6LL Edinburgh
    Midlothian
    MalaysianAccountant69597360001
    GEDDES, Keith Taylor
    9 Willowbrae Avenue
    EH8 7HB Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    9 Willowbrae Avenue
    EH8 7HB Edinburgh
    Midlothian
    BritishRegional Councillor975490001
    GILCHRIST, James
    21 Heriot Row
    EH3 6EN Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    21 Heriot Row
    EH3 6EN Edinburgh
    Midlothian
    BritishInsurance Company Official318630002
    GILMORE, Sheila
    16 St Catherines Place
    EH9 1NU Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    Amministratore
    16 St Catherines Place
    EH9 1NU Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    UkBritishCouncillor27232470001
    GILMORE, Sheila
    16 St Catherines Place
    EH9 1NU Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    Amministratore
    16 St Catherines Place
    EH9 1NU Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    UkBritishSolicitor27232470001
    GORRIE, Donald Cameron Easterbrook
    9 Garscube Terrace
    EH12 6BW Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    9 Garscube Terrace
    EH12 6BW Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish76140001
    HINDS, Lesley Adelaide
    4 Easter Drylaw Place
    EH4 2QD Edinburgh
    Lothian
    Amministratore
    4 Easter Drylaw Place
    EH4 2QD Edinburgh
    Lothian
    ScotlandBritishDirector3480180001
    HUNTER, Colin Ian
    Stonelaws Farm
    EH40 3DX East Linton
    East Lothian
    Amministratore
    Stonelaws Farm
    EH40 3DX East Linton
    East Lothian
    ScotlandBritishBusiness Adviser37329910003
    KENNEDY, Sheila
    30 House O'Hill Road
    EH4 2AN Edinburgh
    Amministratore
    30 House O'Hill Road
    EH4 2AN Edinburgh
    BritishCouncillor/Teacher35269940001
    KENNEDY, Sheila
    30 House O'Hill Road
    EH4 2AN Edinburgh
    Amministratore
    30 House O'Hill Road
    EH4 2AN Edinburgh
    BritishTeacher35269940001
    KEREVAN, George
    Brunstane House South Wing
    Brunstane Road South
    EH15 2NQ Edinburgh
    Amministratore
    Brunstane House South Wing
    Brunstane Road South
    EH15 2NQ Edinburgh
    ScotlandBritishEconomist660740002
    LAZAROWICZ, Marek Jerzy
    97 Marchmont Road
    EH9 1HB Edinburgh
    Lothian
    Amministratore
    97 Marchmont Road
    EH9 1HB Edinburgh
    Lothian
    BritishVoluntary Worker6335060002
    LOWENBERG, Paul George
    37 Salisbury Road
    EH16 5AA Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    37 Salisbury Road
    EH16 5AA Edinburgh
    Midlothian
    AmericanChief Executive Of Edinburgh D70889900001
    MACKAY, Angus John
    84 Liberton Brae
    EH16 6LB Edinburgh
    Amministratore
    84 Liberton Brae
    EH16 6LB Edinburgh
    ScotlandBritishSelf Employed48624810001
    MACKINTOSH, Hugh Frederick Dundas
    204 Dalkeith Road
    EH16 5DT Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    204 Dalkeith Road
    EH16 5DT Edinburgh
    Midlothian
    BritishAdvocate71329550001
    MARSHALL, Robert Alexander
    Flat 1 Silverknowes Road
    3 Silverknowes Road
    EH4 5NX Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    Flat 1 Silverknowes Road
    3 Silverknowes Road
    EH4 5NX Edinburgh
    Midlothian
    BritishLocal Government Officer648950001
    PERRY, Ian
    Lilyhill Terrace
    EH8 7DR Edinburgh
    49
    Amministratore
    Lilyhill Terrace
    EH8 7DR Edinburgh
    49
    ScotlandBritishLecturer127893650001
    PERRY, Ian
    Lilyhill Terrace
    EH8 7DR Edinburgh
    49
    Amministratore
    Lilyhill Terrace
    EH8 7DR Edinburgh
    49
    ScotlandBritishLecturer127893650001

    Chi sono le persone con controllo significativo di EDI (INDUSTRIAL) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    East Market Street
    EH8 8BG
    EH8 8BG Edinburgh
    4
    Scotland
    01 giu 2016
    East Market Street
    EH8 8BG
    EH8 8BG Edinburgh
    4
    Scotland
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleScottish Law
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazioneSc110956
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    EDI (INDUSTRIAL) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security
    Creato il 26 nov 2008
    Consegnato il 03 dic 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Unit 10B kings haugh, peffermill industrial estate, peffermill road, edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 05 feb 2008
    Consegnato il 14 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Generally knowns as peffermill industrial estate, edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 05 feb 2008
    Consegnato il 14 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects generally known as 7,9,9A,9B,9C,10,11,12,12A,13-15, 16-22, 23 & 24 south gyle crescent, edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Bond & floating charge
    Creato il 29 gen 2008
    Consegnato il 01 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Scotland PLC
    Transazioni
    • 01 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    Assignation of rents
    Creato il 02 giu 2005
    Consegnato il 10 giu 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due under or in connection with the finance documents
    Brevi particolari
    The company's whole right, title, benefit and interest whether at the charge date or in the future to the rental income pursuant to each of the scheduled leases of the property at peffermill industrial estate, edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Postbank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 10 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Assignation of rents
    Creato il 02 giu 2005
    Consegnato il 10 giu 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due under or in connection with the finance documents
    Brevi particolari
    The company's whole right, title, benefit and interest whether at the charge date or in the future in and to the rental income in relation to the lease of the property at south gyle crescent, edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Postbank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 10 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 01 giu 2005
    Consegnato il 10 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under or in connection with the finance documents
    Brevi particolari
    All those subjects at south gyle crescent, edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Postbank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 10 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 01 giu 2005
    Consegnato il 10 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under or in connection with the finance documents
    Brevi particolari
    Those subjects at peffermill industrial estate, edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Postbank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 10 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Floating charge
    Creato il 26 mag 2005
    Consegnato il 10 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under or in connection with the finance documents
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Postbank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 10 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 12 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0