LAMBDA 2 LIMITED
Panoramica
| Nome della società | LAMBDA 2 LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC122398 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LAMBDA 2 LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova LAMBDA 2 LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O Bdo Llp 4 Atlantic Quay 70 York Street G2 8JX Glasgow |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di LAMBDA 2 LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ND OVERSEAS UK LIMITED | 30 ott 2012 | 30 ott 2012 |
| CHRISTIAN SALVESEN FOOD SERVICES LIMITED | 02 apr 1990 | 02 apr 1990 |
| DMWS 151 LIMITED | 17 gen 1990 | 17 gen 1990 |
Quali sono gli ultimi bilanci di LAMBDA 2 LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per LAMBDA 2 LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Conto finale prima della dissoluzione in MVL (conto finale allegato) | 11 pagine | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 16 Charlotte Square Edinburgh EH2 4DF a C/O Bdo Llp 4 Atlantic Quay 70 York Street Glasgow G2 8JX in data 23 apr 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Georgina Garratt come segretario in data 21 mar 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 mag 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 31 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Ms Georgina Garratt come amministratore in data 01 feb 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lyndsay Gillian Navid Lane come amministratore in data 31 gen 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Ms Georgina Garratt come segretario in data 20 feb 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lyndsay Navid Lane come segretario in data 17 feb 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di David James Thomas come amministratore in data 04 nov 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Simon Gavin Evans come amministratore in data 04 nov 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Lyndsay Navid Lane il 09 mag 2016 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr David James Thomas come amministratore in data 30 nov 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Patrick Bataillard come amministratore in data 27 nov 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Gaultier De La Rochebrochard come amministratore in data 29 set 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Ms Lyndsay Gillian Navid Lane come amministratore in data 14 ott 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 mag 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di LAMBDA 2 LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVANS, Simon Gavin | Amministratore | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Xpo House England | United Kingdom | British | 150758530001 | |||||
| GARRATT, Georgina | Amministratore | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Xpo House England | United Kingdom | British | 242693040001 | |||||
| BRADLEY, John Leslie | Segretario | The Forge Wilsthorpe PE9 4PE Stamford Lincolnshire | British | 1068430001 | ||||||
| CLARK, Andrew Gerard | Segretario | 93 Queens Walk PE9 2QF Stamford Lincolnshire | British | 1244140001 | ||||||
| GARRATT, Georgina | Segretario | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Xpo House England | 225096860001 | |||||||
| HORNE, Geoffret Wemyss | Segretario | 3 Swanston Park EH10 7BR Edinburgh Midlothian | British | 52471340001 | ||||||
| LANE, Lyndsay Navid | Segretario | Lodge Way Lodge Farm Industrial Estate NN5 7SL Northampton Xpo House England | British | 163370750001 | ||||||
| LAVELLE, James William | Segretario | Meadow Court The Lane Grafton Regis NN12 7HW Towcester Northamptonshire | British | 55957600002 | ||||||
| LYNCH, David Paul | Segretario | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Norbert Dentressangle House Northamptonshire | British | 52425370006 | ||||||
| PEPPIATT, Edward Hugh Davidson | Segretario | Church Farm Oxendon Road, Arthingworth LE16 8LA Market Harborough Leicestershire | British | 83323550001 | ||||||
| ROSE, Ian Andrew | Segretario | Trehern Close Knowle B93 9HA Solihull 3 West Midlands | British | 128431040001 | ||||||
| BATAILLARD, Patrick | Amministratore | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Norbert Dentressangle House Northamptonshire United Kingdom | French | French | 148397660002 | |||||
| BEARD, James | Amministratore | 5 Sharma Leas PE4 6ZH Peterborough Cambridgeshire | British | 30468010001 | ||||||
| BIRD, Richard William | Amministratore | 68 St Mary's Lane Louth Lincolnshire | British | 26173210001 | ||||||
| BRADLEY, John Leslie | Amministratore | The Forge Wilsthorpe PE9 4PE Stamford Lincolnshire | British | 1068430001 | ||||||
| CLARK, Andrew Gerard | Amministratore | 93 Queens Walk PE9 2QF Stamford Lincolnshire | British | 1244140001 | ||||||
| DE LA ROCHEBROCHARD, Gaultier | Amministratore | Nd House, Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Norbert Dentressangle House Northamptonshire | France | French | 163237590002 | |||||
| FASKEN, David Robert | Amministratore | The Coachhouse Edenside Road TD5 7BS Kelso | British | 30467940001 | ||||||
| FIDLER, Brian Harvey | Amministratore | The Eighth House Vernon Avenue OX2 9AU Oxford | England | British | 57282470001 | |||||
| GRINDLAY, Alfred Ritchie | Amministratore | 1 Oxford Road PE9 1BT Stamford Lincolnshire | British | 51783690003 | ||||||
| HORNE, Geoffrey Wemyss | Amministratore | 25 Oswald Road EH9 2HJ Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 66121750001 | |||||
| KING, Roy Charles | Amministratore | Roecroft Hacconby Bourne Lincs | British | 1068450001 | ||||||
| LAUGERY, Stephane Jacques Andre Philippe | Amministratore | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Norbert Dentressangle House Northamptonshire | France | French | 126820460002 | |||||
| LAVELLE, James William | Amministratore | Meadow Court The Lane Grafton Regis NN12 7HW Towcester Northamptonshire | British | 55957600002 | ||||||
| MACK, Christopher Charles Robert | Amministratore | 18 Oakley Park BL1 5XL Bolton Lancashire | British | 158640001 | ||||||
| MILES, Colin Geoffrey | Amministratore | High Bank Harlestone Road NN6 8AU Church Brampton Northamptonshire | United Kingdom | British | 52425150001 | |||||
| NAVID LANE, Lyndsay Gillian | Amministratore | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Xpo House United Kingdom | England | British | 177674310001 | |||||
| PEGG, Paul Stephen William | Amministratore | Holly House Weston Road, Edith Weston LE15 8HQ Oakham Leicestershire | England | British | 80197260001 | |||||
| PEPPIATT, Edward Hugh Davidson | Amministratore | Church Farm Oxendon Road, Arthingworth LE16 8LA Market Harborough Leicestershire | British | 83323550001 | ||||||
| REDFERN, Paul Ian | Amministratore | Tregartha Ryhall Road Great Casterton PE9 4AR Stamford Lincolnshire | British | 27208180002 | ||||||
| ROEBUCK, Roy | Amministratore | Flat 7 Windermere Court Water End Thorpe Meadows PE3 6GQ Peterborough Cambridgeshire | British | 30467980001 | ||||||
| STEADMAN, Julian Alex | Amministratore | 3 Hill Place SL2 3EW Farnham Common Buckinghamshire | United Kingdom | British | 43224360003 | |||||
| THOMAS, David James | Amministratore | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Xpo House United Kingdom | England | British | 147800590002 | |||||
| WADDELL, John Maclaren Ogilvie | Amministratore | 16 Kinghorn Place EH6 4BN Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 113233140001 | |||||
| WHEELER, Richard Neville | Amministratore | New Hunting Court 14 Thorpe Road PE3 6 Peterborough | British | 162300001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di LAMBDA 2 LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xpo Investment Uk Limited | 06 apr 2016 | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Xpo House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
LAMBDA 2 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0