TULLOCH LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTULLOCH LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC125792
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di TULLOCH LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TULLOCH LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Alexander Fleming House
    8 Southfield Drive
    IV30 6GR Elgin
    Morayshire
    Scotland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TULLOCH LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TULLOCH PLC15 dic 200315 dic 2003
    TULLOCH LIMITED21 mar 200321 mar 2003
    TULLOCH PLC24 lug 200024 lug 2000
    TULLOCH MANAGEMENT SERVICES LIMITED04 lug 199604 lug 1996
    INVERNESS LIMITED02 ago 199402 ago 1994
    INVERNESS HOLDINGS LIMITED17 giu 199417 giu 1994
    TULLOCH MANAGEMENT SERVICES LIMITED13 dic 199013 dic 1990
    TEMPLE INVESTMENTS (INVERNESS) LIMITED03 ago 199003 ago 1990
    DESIGNWHOLE LIMITED26 giu 199026 giu 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di TULLOCH LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mag 2025
    Scadenza dei prossimi bilanci il28 feb 2026
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2024

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per TULLOCH LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al23 mar 2026
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma06 apr 2026
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al23 mar 2025
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per TULLOCH LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mar 2025 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mag 2024

    19 pagineAA

    Cessazione della carica di Alexander James Grant come amministratore in data 31 mag 2024

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Kieran Graham come amministratore in data 01 mag 2024

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mar 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mag 2023

    21 pagineAA

    Nomina di Mr. Iain Alexander James Logan come amministratore in data 09 ago 2023

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michelle Hunter Motion come amministratore in data 10 mar 2023

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mar 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mag 2022

    16 pagineAA

    legacy

    110 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mar 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 30 giu 2021

    8 pagineAA

    legacy

    35 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Nomina di Andrew Todd come segretario in data 01 dic 2021

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di George Gabriel Fraser come amministratore in data 01 dic 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Michelle Hunter Motion come amministratore in data 01 dic 2021

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Innes Smith come amministratore in data 01 dic 2021

    2 pagineAP01

    Nomina di Alexander William Adam come amministratore in data 01 dic 2021

    2 pagineAP01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 giu 2022 al 31 mag 2022

    1 pagineAA01

    Indirizzo della sede legale modificato da Stoneyfield House Stoneyfield Business Park Inverness IV2 7PA a Alexander Fleming House 8 Southfield Drive Elgin Morayshire IV30 6GR in data 06 dic 2021

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di TULLOCH LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TODD, Andrew
    8 Southfield Drive
    IV30 6GR Elgin
    Alexander Fleming House
    Morayshire
    Scotland
    Segretario
    8 Southfield Drive
    IV30 6GR Elgin
    Alexander Fleming House
    Morayshire
    Scotland
    290283430001
    ADAM, Alexander William
    8 Southfield Drive
    IV30 6GR Elgin
    Alexander Fleming House
    Morayshire
    Scotland
    Amministratore
    8 Southfield Drive
    IV30 6GR Elgin
    Alexander Fleming House
    Morayshire
    Scotland
    United KingdomBritishFarmer246070480002
    GRAHAM, Kieran
    8 Southfield Drive
    IV30 6GR Elgin
    Alexander Fleming House
    Morayshire
    Scotland
    Amministratore
    8 Southfield Drive
    IV30 6GR Elgin
    Alexander Fleming House
    Morayshire
    Scotland
    ScotlandScottishCommercial Director322903410001
    LOGAN, Iain Alexander James, Mr.
    8 Southfield Drive
    IV30 6GR Elgin
    Alexander Fleming House
    Morayshire
    Scotland
    Amministratore
    8 Southfield Drive
    IV30 6GR Elgin
    Alexander Fleming House
    Morayshire
    Scotland
    ScotlandBritishChartered Accountant97626730002
    SMITH, Innes
    8 Southfield Drive
    IV30 6GR Elgin
    Alexander Fleming House
    Morayshire
    Scotland
    Amministratore
    8 Southfield Drive
    IV30 6GR Elgin
    Alexander Fleming House
    Morayshire
    Scotland
    ScotlandBritishChartered Accountant290185050001
    CAMERON, James
    Stoneyfield House
    Stoneyfield Business Park
    IV2 7PA Inverness
    Segretario
    Stoneyfield House
    Stoneyfield Business Park
    IV2 7PA Inverness
    British166635400001
    MCLUCAS, Donald Allan Mackintosh
    91 Old Edinburgh Road
    IV2 3HT Inverness
    Segretario
    91 Old Edinburgh Road
    IV2 3HT Inverness
    British30871850001
    STEWART, Katherine M
    22 Edgemoor Park
    Balloch
    IV1 2RB Inverness
    Inverness Shire
    Segretario
    22 Edgemoor Park
    Balloch
    IV1 2RB Inverness
    Inverness Shire
    BritishAccountant565690001
    SUTHERLAND, Caroline Anne
    Slackbuie Way
    Fairways
    IV2 6AT Inverness
    29
    United Kingdom
    Segretario
    Slackbuie Way
    Fairways
    IV2 6AT Inverness
    29
    United Kingdom
    BritishSolicitor87534020003
    SUTHERLAND, Caroline Anne
    Flat 3/2, 20 Oban Drive
    G20 6AF Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    Flat 3/2, 20 Oban Drive
    G20 6AF Glasgow
    Lanarkshire
    BritishTrainee Solicitor67855880001
    SUTHERLAND, David Fraser
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    Segretario
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    BritishChartered Accountant1321720003
    SUTHERLAND, David Fraser
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    Segretario
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    BritishChartered Accountant1321720003
    TRACE, Marjory Bremner
    1 Wellside Road
    Balloch
    IV2 7GS Inverness
    Segretario
    1 Wellside Road
    Balloch
    IV2 7GS Inverness
    BritishCompany Secretary43522850004
    TRACE, Marjory Bremner
    1 Wellside Road
    Balloch
    IV2 7GS Inverness
    Segretario
    1 Wellside Road
    Balloch
    IV2 7GS Inverness
    BritishAdministrator43522850004
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Segretario nominato
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    BANKIER, Ian Patrick
    2/2 168 Crow Road
    G11 7JS Glasgow
    Amministratore
    2/2 168 Crow Road
    G11 7JS Glasgow
    United KingdomBritishConsultant95000940001
    BARBOUR, Theresa
    16 Mcpherson Drive
    Bothwell
    G71 8QP Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    16 Mcpherson Drive
    Bothwell
    G71 8QP Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritishDirector127088430001
    BARKLEY, John
    10 Willow Tree Place
    The Beeches
    EH14 5AZ Balerno
    Edinburgh, Midlothian
    Amministratore
    10 Willow Tree Place
    The Beeches
    EH14 5AZ Balerno
    Edinburgh, Midlothian
    BritishBank Official18955940002
    BRAZIER, Stephen Harvey
    Russett House, 8 Main Drive
    SL9 7PS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Russett House, 8 Main Drive
    SL9 7PS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director100183520001
    CAMERON, David John
    Druminlochan
    Feshiebridge
    PH21 1NQ Kincraig
    Inverness-Shire
    Amministratore
    Druminlochan
    Feshiebridge
    PH21 1NQ Kincraig
    Inverness-Shire
    ScotlandBritishCompany Director125212090001
    CAMERON, Kenneth William
    121 Culduthel Road
    IV2 4EE Inverness
    Amministratore
    121 Culduthel Road
    IV2 4EE Inverness
    ScotlandBritishDirector41410280001
    CAMERON, Neil Stuart
    30 Overton Avenue
    IV3 6RR Inverness
    Amministratore
    30 Overton Avenue
    IV3 6RR Inverness
    ScotlandBritishChartered Surveyor34848670001
    CAMERON, Neil Stuart
    30 Overton Avenue
    IV3 6RR Inverness
    Amministratore
    30 Overton Avenue
    IV3 6RR Inverness
    ScotlandBritishChartered Surveyor34848670001
    DUNCAN, Andrew Raymond
    Fearann-Nan-Gras
    Kilmuir, North Kessock
    IV1 3ZG Inverness
    Inverness Shire
    Amministratore
    Fearann-Nan-Gras
    Kilmuir, North Kessock
    IV1 3ZG Inverness
    Inverness Shire
    ScotlandBritishFinance Director63676750001
    FRASER, Donald Cameron
    10 West Heather Road
    IV2 4WS Inverness
    Amministratore
    10 West Heather Road
    IV2 4WS Inverness
    UkBritishManaging Director154418170001
    FRASER, George Gabriel
    8 Southfield Drive
    IV30 6GR Elgin
    Alexander Fleming House
    Morayshire
    Scotland
    Amministratore
    8 Southfield Drive
    IV30 6GR Elgin
    Alexander Fleming House
    Morayshire
    Scotland
    ScotlandBritishNone50219540001
    FRASER, George Gabriel
    7 Fairways
    Altonburn Road
    IV12 5NB Nairn
    Highland
    Amministratore
    7 Fairways
    Altonburn Road
    IV12 5NB Nairn
    Highland
    ScotlandBritishDirector50219540001
    GRAHAM, Robert
    17 Woodrush Glade
    Adam Brae
    EH54 9JY Livingston
    West Lothian
    Amministratore
    17 Woodrush Glade
    Adam Brae
    EH54 9JY Livingston
    West Lothian
    United KingdomBritishDirector95455880001
    GRANT, Alexander James
    8 Southfield Drive
    IV30 6GR Elgin
    Alexander Fleming House
    Morayshire
    Scotland
    Amministratore
    8 Southfield Drive
    IV30 6GR Elgin
    Alexander Fleming House
    Morayshire
    Scotland
    United KingdomBritishDirector113195780003
    GRANT, Alexander James
    52 Wester Inshes Court
    IV2 5HS Inverness
    Inverness Shire
    Amministratore
    52 Wester Inshes Court
    IV2 5HS Inverness
    Inverness Shire
    BritishFinance Director107801990001
    MACDONALD, Ian
    Stoneyfield House
    Stoneyfield Business Park
    IV2 7PA Inverness
    Amministratore
    Stoneyfield House
    Stoneyfield Business Park
    IV2 7PA Inverness
    ScotlandBritishQuantity Surveyor81926330001
    MACDONALD, Ronald Sutherland
    135 Stewarton Drive
    G72 8DH Cambuslang
    Amministratore
    135 Stewarton Drive
    G72 8DH Cambuslang
    United KingdomBritishFinancial Director145418810001
    MACDOUGALL, Alasdair
    104 Culduthel Park
    IV2 4RZ Inverness
    Highland
    Amministratore
    104 Culduthel Park
    IV2 4RZ Inverness
    Highland
    ScotlandBritishFinance Director91007550001
    MACKENZIE, Donald Henry
    Taighe-Na-Coille Dalgrambich
    Croy
    IV2 5PR Inverness
    Inverness Shire
    Amministratore
    Taighe-Na-Coille Dalgrambich
    Croy
    IV2 5PR Inverness
    Inverness Shire
    ScotlandBritishDirector66483050001
    MARSHALL, Alyson
    8 Blackthorn Avenue
    G66 4BZ Kirkintilloch
    Lanarkshire
    Amministratore
    8 Blackthorn Avenue
    G66 4BZ Kirkintilloch
    Lanarkshire
    ScotlandBritishBoard Administrator116919700001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TULLOCH LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Stoneyfield Business Park
    IV2 7PA Inverness
    Stoneyfield House
    Scotland
    14 nov 2018
    Stoneyfield Business Park
    IV2 7PA Inverness
    Stoneyfield House
    Scotland
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazioneSc496362
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Stoneyfield Business Park
    IV2 7PA Inverness
    Stoneyfield House
    Scotland
    06 apr 2016
    Stoneyfield Business Park
    IV2 7PA Inverness
    Stoneyfield House
    Scotland
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazioneSc166347
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0