BUSINESS COMPUTER TECHNOLOGY LIMITED
Panoramica
Nome della società | BUSINESS COMPUTER TECHNOLOGY LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | SC125837 |
Giurisdizione | Scozia |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | No |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BUSINESS COMPUTER TECHNOLOGY LIMITED?
- Altre attività di pubblicazione di software (58290) / Informazione e comunicazione
Dove si trova BUSINESS COMPUTER TECHNOLOGY LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 20 Castle Terrace EH1 2EG Edinburgh |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BUSINESS COMPUTER TECHNOLOGY LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
CALEDONIAN VENTURES SIXTEEN LIMITED | 27 giu 1990 | 27 giu 1990 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BUSINESS COMPUTER TECHNOLOGY LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 apr 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per BUSINESS COMPUTER TECHNOLOGY LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Conto finale prima della dissoluzione in MVL (conto finale allegato) | 6 pagine | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da The Centrum Business Centre Suite No. 4a 38 Queen Street Glasgow G1 3DX Scotland a 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG in data 18 apr 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 nov 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2018 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 apr 2019 al 31 mar 2019 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ian Michael Noble come amministratore in data 06 ago 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen James Callaghan il 06 ago 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Northgate Mill Road Industrial Estate Linlithgow West Lothian EH49 7SF a The Centrum Business Centre Suite No. 4a 38 Queen Street Glasgow G1 3DX in data 29 gen 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2017 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 nov 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2016 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Ian Michael Noble come amministratore in data 06 dic 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Coll come amministratore in data 06 dic 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 nov 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Stephen James Callaghan come amministratore in data 10 ott 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David John Meaden come amministratore in data 10 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2015 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 nov 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2014 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di David John Meaden come amministratore in data 22 dic 2014 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Andrew Coll come amministratore in data 22 dic 2014 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Robert Stier come amministratore in data 22 dic 2014 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Daniel William Schenck come segretario in data 22 dic 2014 | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di BUSINESS COMPUTER TECHNOLOGY LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Segretario | Park Row LS1 5AB Leeds 1 United Kingdom |
| 76579530001 | ||||||||||
CALLAGHAN, Stephen James | Amministratore | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 201347710052 | ||||||||
COUTTS, Cheryl Jane | Segretario | 6 Esmond Road W4 1JQ Chiswick London | British | 12016130002 | ||||||||||
COX, Melanie Rachel | Segretario | 1 The Green Bisham SL7 1RY Marlow Buckinghamshire | British | 96139050001 | ||||||||||
GREIG, Alistair James | Segretario | 27 Campbell Drive Bearsden G61 4NF Glasgow Lanarkshire | British | 9496390001 | ||||||||||
HEMMING, Vivienne Ruth | Segretario | 25 Saint Johns Road OX10 9AW Wallingford Oxon | British | 41962390006 | ||||||||||
HUMPHREY, Christopher John | Segretario | Well House School Lane, Northend BA1 7EP Bath Somerset | British | 32877720003 | ||||||||||
LAUASANEY, Raha Hosseini | Segretario | 171 Great Junction Street EH6 5SQ Edinburgh Midlothian | British | 1098970001 | ||||||||||
RICHARDSON, John David | Segretario | Mill Road Industrial Estate EH49 7SF Linlithgow C/O Northgate West Lothian | British | 128558470001 | ||||||||||
SADLER, John Michael | Segretario | 14 Highlands Close SL9 0DR Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | 78431540001 | ||||||||||
SCHENCK, Daniel William | Segretario | Mill Road Industrial Estate EH49 7SF Linlithgow C/O Northgate West Lothian | 181281460001 | |||||||||||
TANNAHILL, Linda Jeanie Coulston | Segretario | 62 Hamilton Street ML8 4HA Carluke South Lanarkshire | British | 55455860001 | ||||||||||
AL-SALEH, Adel Bedry | Amministratore | Mill Road Industrial Estate EH49 7SF Linlithgow C/O Northgate West Lothian | United States | American | Director | 165900220001 | ||||||||
BASS, Neil Anthony | Amministratore | 31 Archery Fields RG29 1AE Odiham Hampshire | England | British | Director | 70199330002 | ||||||||
BEATON, Richard L'Estrange | Amministratore | Prestbury Hall The Village SK10 4BN Prestbury Cheshire | England | British | Director | 97291590001 | ||||||||
BODHA, James Sanjay | Amministratore | Rook How 22 Elm Tree Road WA13 0NB Lymm Cheshire | England | British | Director | 93657140001 | ||||||||
COLL, Andrew | Amministratore | Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British | Finance Director | 237260100001 | ||||||||
GIBSON, John Leonard | Amministratore | Ivydene Delly End OX29 9XD Hailey Oxfordshire | British | Director | 104554430001 | |||||||||
GREIG, Alistair James | Amministratore | 27 Campbell Drive Bearsden G61 4NF Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | Computer Consultant | 9496390001 | ||||||||
HAIR, Robert | Amministratore | 14a Station Road Bearsden G61 4AW Glasgow | British | Computer Consultant | 72125500001 | |||||||||
HUNT, Simon Anthony | Amministratore | Apt 31 21 Sheldon Square Paddington Central W2 6DS London | British | Director | 118771650001 | |||||||||
JENKINS, Roderick Noel | Amministratore | 50 Old Castle Road Cathcart G44 5TE Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | Computer Consultant | 9496370001 | ||||||||
MCCANN, James | Amministratore | 32 Carter Close SL4 3QX Windsor Berkshire | British | Chartered Management Accountan | 69923680001 | |||||||||
MEADEN, David John | Amministratore | Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Executive | 193740420001 | ||||||||
NOBLE, Ian Michael | Amministratore | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British | Director | 199843940001 | ||||||||
ROBERTSON, Stuart Alexander | Amministratore | 171 Great Junction Street EH6 5SQ Edinburgh Midlothian | British | 49148240003 | ||||||||||
SHANNON, Malcolm Donaldson | Amministratore | 25 Allan Glen Gardens Bishopbriggs G64 3BG Glasgow | Scotland | British | Director | 65676360002 | ||||||||
STIER, John Robert | Amministratore | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 78901530003 | ||||||||
STONE, Christopher Michael Renwick | Amministratore | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Hertfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 66955690003 | ||||||||
TAIT, Ian | Amministratore | Field House Evesham Road WR10 2QR Fladbury Worcestershire | United Kingdom | British | Director | 76976490001 | ||||||||
TYRRELL, Simon Robert Edgar | Amministratore | Larks 15 Burstead Close KT11 2NL Cobham Surrey | England | British | Company Director | 77284710002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BUSINESS COMPUTER TECHNOLOGY LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nps (Uk6) Limited | 06 apr 2016 | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
BUSINESS COMPUTER TECHNOLOGY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0