INVERESK PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàINVERESK PLC
    Stato della societàIn amministrazione controllata
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società SC126333
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di INVERESK PLC?

    • (2112) /

    Dove si trova INVERESK PLC?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Ernst & Young Llp Atria One
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di INVERESK PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DMWS 167 LIMITED17 lug 199017 lug 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di INVERESK PLC?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2008
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 lug 2009
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2007

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per INVERESK PLC?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al17 lug 2016
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma31 lug 2016
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per INVERESK PLC?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per INVERESK PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Cessazione della carica di David Jonathan Pett come segretario in data 23 feb 2022

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di James Alan Fairley Walker come amministratore in data 23 feb 2022

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Ten George Street Edinburgh EH2 2DZ a C/O Ernst & Young Llp Atria One 144 Morrison Street Edinburgh EH3 8EX in data 22 dic 2017

    2 pagineAD01

    Avviso del rapporto del ricevitore

    9 pagine3.5(Scot)

    Indirizzo della sede legale modificato da * Steuart Road Bridge of Allan Stirlingshire FK9 4JX* in data 20 ott 2010

    2 pagineAD01

    Avviso di nomina del ricevitore da parte di un detentore di carica flottante

    3 pagine1(Scot)

    Cessazione della carica di Kieron Green come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gordon Thomson come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Mason come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    7 pagine363a

    Dimissioni del revisore

    3 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Modifiche alla garanzia mobiliare 31

    8 pagine466(Scot)

    Modifiche alla garanzia mobiliare 23

    6 pagine466(Scot)

    legacy

    3 pagine410(Scot)

    legacy

    5 pagine410(Scot)

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2007

    63 pagineAA

    legacy

    3 pagine410(Scot)

    legacy

    9 pagine363s

    legacy

    1 pagine287

    Risoluzioni

    Resolutions
    pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    legacy

    9 pagine363s

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2006

    46 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di INVERESK PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BERNANDER, Jan Gunnar
    13 Nathan Road
    Regency Park 04-02
    248737 Singapore
    Singapore
    Amministratore
    13 Nathan Road
    Regency Park 04-02
    248737 Singapore
    Singapore
    Swedish85805850001
    LAWSON, George Jamieson
    1 Blackwood Green
    Pitreavie
    KY11 8QG Dunfermline
    Fife
    Scotland
    Segretario
    1 Blackwood Green
    Pitreavie
    KY11 8QG Dunfermline
    Fife
    Scotland
    British59153100003
    MACRAE, Alexander Morgan
    Beauly 4 Primrose Bank Road
    EH5 3JH Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    Beauly 4 Primrose Bank Road
    EH5 3JH Edinburgh
    Midlothian
    British66177230001
    MORRISON, Ian Millar
    27 Boreland Road
    KY11 1DA Inverkeithing
    Fife
    Segretario
    27 Boreland Road
    KY11 1DA Inverkeithing
    Fife
    British1220920001
    PETT, David Jonathan
    23 Mill Lane
    Linton
    CB1 6JY Cambridge
    Cambridgeshire
    Segretario
    23 Mill Lane
    Linton
    CB1 6JY Cambridge
    Cambridgeshire
    British12054930001
    SCULL, Andrew James
    10 Kenilworth Court, Kenilworth Road
    Bridge Of Allan
    FK9 4EJ Stirling
    Segretario
    10 Kenilworth Court, Kenilworth Road
    Bridge Of Allan
    FK9 4EJ Stirling
    British53961740004
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Segretario nominato
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    900000320001
    BOYD, Ian Mair
    34 Newark Drive
    Pollokshields
    G41 4PZ Glasgow
    Amministratore
    34 Newark Drive
    Pollokshields
    G41 4PZ Glasgow
    United KingdomBritish35578940002
    BRUCE, Roderick Lawrence
    Rosehill
    23 Inveresk Village
    Inveresk
    East Lothian
    Amministratore delegato nominato
    Rosehill
    23 Inveresk Village
    Inveresk
    East Lothian
    British900003110001
    CASSELS, Gerard William
    324 Leith Walk
    EH6 5BU Edinburgh
    Amministratore
    324 Leith Walk
    EH6 5BU Edinburgh
    ScotlandBritish58834580001
    COLE, Alan Jack
    57 Hugh Street
    SW1V 4HR London
    Amministratore
    57 Hugh Street
    SW1V 4HR London
    United KingdomBritish9811630006
    DEAN OF THORNTON LE FYLDE, Brenda, Rt. Hon Baroness Dean Of Tiior
    2 Malvern Terrace
    N1 1HR London
    Amministratore
    2 Malvern Terrace
    N1 1HR London
    United KingdomBritish65745160001
    DOLLMAN, Paul Bernard
    36 Garscube Terrace
    EH12 6BN Edinburgh
    Amministratore
    36 Garscube Terrace
    EH12 6BN Edinburgh
    ScotlandBritish1230000002
    DOORBAR, David Nigel
    Glendale
    Soke Road, Silchester
    RG7 2PA Reading
    Amministratore
    Glendale
    Soke Road, Silchester
    RG7 2PA Reading
    United KingdomBritish103065330001
    GOODALL, Ralph William
    The Old Vicarage
    Hoghton
    PR5 0SJ Preston
    Lancashire
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Hoghton
    PR5 0SJ Preston
    Lancashire
    British934630001
    GORE, William Hornby
    12 Ainslie Place
    EH3 6AS Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    12 Ainslie Place
    EH3 6AS Edinburgh
    Midlothian
    British94619220001
    GREEN, Kieron Philip
    The Barn Sand Road
    BS28 4BX Wedmore
    Somerset
    Amministratore
    The Barn Sand Road
    BS28 4BX Wedmore
    Somerset
    British57160880001
    HARRISON, David Alexander
    6 Princes Terrace
    G12 9JW Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    6 Princes Terrace
    G12 9JW Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish72350900001
    HENDERSON, James Bryden
    The Great House
    Edington
    Bridgwater
    Somerset
    Amministratore
    The Great House
    Edington
    Bridgwater
    Somerset
    British65563500001
    KAY, Stefan George
    7 Kings Cramond
    Barnton
    EH4 6RL Edinburgh
    Amministratore
    7 Kings Cramond
    Barnton
    EH4 6RL Edinburgh
    United KingdomBritish1220910001
    LENTON, Aylmer Ingram
    Robin Hill Hockett Lane
    Cookham Dean
    SL6 9UF Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Robin Hill Hockett Lane
    Cookham Dean
    SL6 9UF Maidenhead
    Berkshire
    British1321890001
    MACDONALD, Brian Duke
    Westbrae Cottage
    Gartmore
    FK8 3RJ Stirling
    Amministratore
    Westbrae Cottage
    Gartmore
    FK8 3RJ Stirling
    British45513310002
    MACFIE, Andrew James
    9 Corrennie Gardens
    EH10 6DG Edinburgh
    Amministratore
    9 Corrennie Gardens
    EH10 6DG Edinburgh
    ScotlandBritish33487610001
    MACLEOD, Roland William George
    7 Grinnan Road
    Braco
    FK15 9RF Dunblane
    Perthshire
    Amministratore
    7 Grinnan Road
    Braco
    FK15 9RF Dunblane
    Perthshire
    British81489850001
    MASON, John Stephen
    Acorn Cottage
    Preston Deanery
    NN7 2DU Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Acorn Cottage
    Preston Deanery
    NN7 2DU Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish6821560001
    MCGHEE, Thomas Allan
    1 Port Laing Wynd
    KY11 1EW North Queensferry
    Fife
    Amministratore
    1 Port Laing Wynd
    KY11 1EW North Queensferry
    Fife
    British81489550002
    MCLACHLAN, Peter Ronie
    14 Hardy Gardens
    EH48 1NH Bathgate
    West Lothian
    Scotland
    Amministratore
    14 Hardy Gardens
    EH48 1NH Bathgate
    West Lothian
    Scotland
    British45586070001
    MCLEAN, Duncan Lawrence
    The Hawthorns 12 Kenilworth Road
    Bridge Of Allan
    FK9 4DU Stirling
    Amministratore
    The Hawthorns 12 Kenilworth Road
    Bridge Of Allan
    FK9 4DU Stirling
    British1220890002
    MINTO, Bruce Watson
    1 Wester Coates Road
    EH12 5LU Edinburgh
    Amministratore delegato nominato
    1 Wester Coates Road
    EH12 5LU Edinburgh
    British900000330001
    MINTON, Kenneth Joseph
    7 Midway
    AL3 4BD St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    7 Midway
    AL3 4BD St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish513690001
    RALPH, Henry Thomas
    9 Rockville Grove
    EH49 6BZ Linlithgow
    West Lothian
    Amministratore
    9 Rockville Grove
    EH49 6BZ Linlithgow
    West Lothian
    British45101650001
    SCULL, Andrew James
    10 Kenilworth Court, Kenilworth Road
    Bridge Of Allan
    FK9 4EJ Stirling
    Amministratore
    10 Kenilworth Court, Kenilworth Road
    Bridge Of Allan
    FK9 4EJ Stirling
    British53961740004
    SNEDDON, Thomas
    North Deal 5 Eldindean Court
    KY12 9AN Dunfermline
    Fife
    Amministratore
    North Deal 5 Eldindean Court
    KY12 9AN Dunfermline
    Fife
    British25784730001
    THOMPSON, Martin
    Arnsbrae House Alloa Road
    Cambus
    FK10 2NT Alloa
    Clackmannanshire
    Amministratore
    Arnsbrae House Alloa Road
    Cambus
    FK10 2NT Alloa
    Clackmannanshire
    British57160940001
    THOMSON, Gordon Mackenzie
    Newhaven House
    4 Chestnut Court
    PH3 1RE Auchterarder
    Amministratore
    Newhaven House
    4 Chestnut Court
    PH3 1RE Auchterarder
    ScotlandBritish45976520003

    INVERESK PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security
    Creato il 19 dic 2008
    Consegnato il 23 dic 2008
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Caldwells mill, inverkeithing, lyne burn pumping station, inverkeithing & pumping station at burnside business court, inverkeithing.
    Persone aventi diritto
    • Cavedrive Limited
    Transazioni
    • 23 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (410)
    Legal charge
    Creato il 18 dic 2008
    Consegnato il 31 dic 2008
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Freehold properties known as st cuthberts paper mill, glencot lane, wells, somerset ST74426, st cuthberts paperworks, haybridge, wells ,somerset ST147066,. St cutherts, wookey hole, somerset ST74425 and spring of water lying to the west of glencot lane, wells, somerset ST74424.
    Persone aventi diritto
    • Cavedrive Limited
    Transazioni
    • 31 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (410)
    Floating charge
    Creato il 18 dic 2008
    Consegnato il 31 dic 2008
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Cavedrive Limited
    Transazioni
    • 31 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 08 gen 2009Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Standard security
    Creato il 07 mag 2003
    Consegnato il 21 mag 2003
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Area of ground extending to 63.4 square metres at burnside court, inverkeithing (title number FFE55225).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 05 mag 2003
    Consegnato il 21 mag 2003
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects at caldwell's keith mill, inverkeithing.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 05 mag 2003
    Consegnato il 21 mag 2003
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects at carrongrove paper mill, denny.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 05 mag 2003
    Consegnato il 21 mag 2003
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects at 17A preston crescent, inverkeithing.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 05 mag 2003
    Consegnato il 21 mag 2003
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Area of ground extending to 63.4 square metres at burnside business court, inverkeithing.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    First legal charge
    Creato il 16 apr 2003
    Consegnato il 02 mag 2003
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    St cuthberts paper mill, glencot lane; st cuthberts paperworks, haybridge wells; property at st cuthberts, wookey hole and spring of water, west of glencot lane, wells, all somerset.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    Floating charge
    Creato il 07 apr 2003
    Consegnato il 16 apr 2003
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 08 gen 2009Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 115 ott 2010Nomina di un amministratore o gestore (1 Scot)
    • Ha modifiche all'ordine:
      • Numero di pratica 1
    Floating charge
    Creato il 27 giu 2002
    Consegnato il 02 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 02 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 23 set 2002Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 28 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Standard security
    Creato il 16 ago 2001
    Consegnato il 24 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Kilbagie mill, alloa.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 24 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 07 ago 2001
    Consegnato il 15 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The subjects known and forming westfield paper mill, westfield, bathgate.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 07 ago 2001
    Consegnato il 15 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects known and forming caldwell's mill, inverkeithing.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 07 ago 2001
    Consegnato il 13 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Carongrove paper mill, denny.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 06 ago 2001
    Consegnato il 14 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    St cuthberts paper mill, glencot lane, wells, somerset.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 30 mag 2001
    Consegnato il 08 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over freehold & leasehold property. Fixed & floating charge over assets.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 23 set 2002Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 28 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Bond & floating charge
    Creato il 02 mar 2000
    Consegnato il 07 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 23 set 2002Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 28 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Standard security
    Creato il 17 gen 1992
    Consegnato il 23 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Westfield paper mill, westfield, bathgate.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Grenfell & Co Limited as Security Agent and Trustee for Itself and Others
    Transazioni
    • 23 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 giu 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 17 gen 1992
    Consegnato il 23 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Caldwell's keith mill, inverkeithing.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Grenfell & Co Limited as Security Agent and Trustee for Itself and Others
    Transazioni
    • 23 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 giu 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 17 gen 1992
    Consegnato il 23 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Carrongrove paper mill, denny.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Grenfell & Co Limited as Security Agent and Trustee for Itself and Others
    Transazioni
    • 23 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 giu 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Debenture
    Creato il 23 dic 1991
    Consegnato il 06 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    St cuthberts paper mill.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Grenfell & Co Limited as Security Agent and Trustee for Itself, the Arranger, the Facili
    Transazioni
    • 06 gen 1992Registrazione di un'ipoteca
    • 11 giu 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • 17 giu 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 23 dic 1991
    Consegnato il 06 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Morgan Grenfell & Co Limited as Security Agent and Trustee for Itself, the Arranger, the Facili
    Transazioni
    • 06 gen 1992Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Scottish assignation in security
    Creato il 23 dic 1991
    Consegnato il 06 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The whole right, title interest and benefit present and future.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Grenfell & Co Limited as Security Agent and Trustee for Itself, the Arranger, the Facili
    Transazioni
    • 06 gen 1992Registrazione di un'ipoteca
    • 11 giu 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Assignation
    Creato il 31 ott 1990
    Consegnato il 12 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Whole right title, invest and benefit relative to hive agreement.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Grenfell & Co as Agent and Trustee for Itself and Others
    Transazioni
    • 12 nov 1990Registrazione di un'ipoteca

    INVERESK PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1Ricevitore amministrativo nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    C P Dempster
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Ricevitore amministrativo
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Christopher Marsden
    Ernst & Young Llp
    1 Bridewell Street
    BS1 2AA Bristol
    Ricevitore amministrativo
    Ernst & Young Llp
    1 Bridewell Street
    BS1 2AA Bristol
    Notescottish-insolvency-info

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0