PINNACLE CELLULAR LIMITED
Panoramica
| Nome della società | PINNACLE CELLULAR LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC127133 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PINNACLE CELLULAR LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova PINNACLE CELLULAR LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di PINNACLE CELLULAR LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2023 |
Quali sono le ultime deposizioni per PINNACLE CELLULAR LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2023 | 5 pagine | AA | ||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||
Modifica dei dettagli di Pinnacle Cellular Group Limited come persona con controllo significativo il 03 lug 2023 | 2 pagine | PSC05 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Edinburgh House 4 North St. Andrew Street Edinburgh EH2 1HJ United Kingdom a 50 Lothian Road Festival Square Edinburgh EH3 9WJ in data 04 lug 2023 | 1 pagine | AD01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 feb 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Janine Butler come amministratore in data 23 nov 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2022 | 5 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 feb 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021 | 5 pagine | AA | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020 | 6 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di David Nigel Evans come amministratore in data 23 feb 2021 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mrs Janine Butler come amministratore in data 23 feb 2021 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 feb 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 feb 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019 | 4 pagine | AA | ||
legacy | 256 pagine | PARENT_ACC | ||
legacy | 2 pagine | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Leven House 10 Lochside Place Edinburgh Park Edinburgh Scotland EH12 9RG a Edinburgh House 4 North St. Andrew Street Edinburgh EH2 1HJ in data 14 mag 2019 | 1 pagine | AD01 | ||
Nomina di Mr Andrew Michael Yorston come amministratore in data 02 apr 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Michael Anthony Henry Olivier come amministratore in data 02 apr 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Diane Josephine Mcintyre come amministratore in data 16 mar 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Chi sono gli amministratori di PINNACLE CELLULAR LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Segretario | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom |
| 75473330004 | ||||||||||
| OLIVIER, Michael Anthony Henry | Amministratore | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 United Kingdom | United Kingdom | British | 257268230001 | |||||||||
| YORSTON, Andrew Michael | Amministratore | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 United Kingdom | United Kingdom | British | 257275320001 | |||||||||
| COULL, Gillian Margaret | Segretario | 62 Alloway Crescent FK4 1EZ Bonnybridge Stirlingshire | British | 30641050001 | ||||||||||
| COULL, Graham | Segretario | 3 Coney Park Kings Park FK7 9LU Stirling Stirlingshire | British | 76740000001 | ||||||||||
| DAWE-LANE, Patrick John Beachim | Segretario | Marsh Lane Rowde SN10 1RE Devizes Upper Foxhangers Farm Wiltshire England | Other | 130771170001 | ||||||||||
| EMETULU, Lola | Segretario | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 88619360002 | ||||||||||
| JEFFERSON, Karen | Segretario | 8 Bailey Close SN9 5HU Pewsey Wiltshire | British | 79393480001 | ||||||||||
| MACLEOD, David | Segretario | 12 Glebe Road Newton Mearns G77 6DU Glasgow | British | 32696310001 | ||||||||||
| REID, Brian | Segretario nominato | 5 Logie Mill Beaverbank Office Park EH7 4HH Edinburgh | British | 900007130001 | ||||||||||
| SCOTT, Stephen Roy | Segretario | Bracken House Bunces Shaw Farley Hill RG7 1UU Reading Berkshire | British | 25660590003 | ||||||||||
| WHEELER, David | Segretario | Carn Mairg Wallacestone Brae FK2 0DH Brightons Stirlingshire | British | 102737470001 | ||||||||||
| ALLAN, William | Amministratore | Shernfold Meadows Wadhurst Road TN3 9EH Frant East Sussex | Uk | British | 111131550001 | |||||||||
| ALLEN, Christian Philip Quentin | Amministratore | 7 Lochside Avenue Edinburgh Park EH12 9DJ Edinburgh Lochside House Scotland Scotland | British | 123612980001 | ||||||||||
| BARR, Duncan David Whyte | Amministratore | 95 Wheatlands Avenue FK4 1PJ Bonnybridge Stirlingshire | British | 37411850001 | ||||||||||
| BREWER, Stephen | Amministratore | Flat 10 Rushworth House Enborne Lodge Lane RG14 6RH Newbury Berkshire | British | 79186090002 | ||||||||||
| BROCKLEHURST, Nigel | Amministratore | 1 The Hollyhocks Reading Road, Harwell OX11 0LX Didcot Oxfordshire | British | 83126790001 | ||||||||||
| BUTLER, Janine | Amministratore | 4 North St. Andrew Street EH2 1HJ Edinburgh Edinburgh House United Kingdom | England | British | 277534960001 | |||||||||
| CHESWORTH, Paul | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 99525280001 | ||||||||||
| COULL, Graham | Amministratore | 3 Coney Park Kings Park FK7 9LU Stirling Stirlingshire | British | 76740000001 | ||||||||||
| EVANS, David Nigel | Amministratore | 4 North St. Andrew Street EH2 1HJ Edinburgh Edinburgh House United Kingdom | United Kingdom | British | 134975040001 | |||||||||
| EVANS, Mark | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 127017870001 | ||||||||||
| FINCH, Joanne Sarah | Amministratore | 10 Lochside Place Edinburgh Park EH12 9RG Edinburgh Leven House Scotland Scotland | United Kingdom | British | 158146620001 | |||||||||
| GOW, John Warrender | Amministratore | 32 Cammo Gardens Barnton EH4 8EQ Edinburgh | British | 55207220001 | ||||||||||
| GRAY, Ian | Amministratore | 61 Bathurst Mews W2 2SB London | United Kingdom | British | 50246030004 | |||||||||
| HALFORD, Andrew Nigel | Amministratore | The Oxdrove House Burghclere RG20 9HJ Newbury Berkshire | British | 33951180005 | ||||||||||
| HERROD, Harry Alan | Amministratore | Dakar, 40 Camelon Road FK1 5SH Falkirk | British | 93998280001 | ||||||||||
| HILLS, Kenneth Cumming | Amministratore | 49 Spottiswoode Street EH9 1DQ Edinburgh Midlothian | British | 65152940001 | ||||||||||
| KEY, Matthew David | Amministratore | Yardley School Lane Seer Green HP9 2QJ Beaconsfield Buckinghamshire | British | 62981720001 | ||||||||||
| LANGSTON, Edward | Amministratore | 23 Manilla Road Clifton BS8 4EB Bristol Avon | Uk | British | 24471140001 | |||||||||
| LEE, Simon Christopher | Amministratore | Moorlands Harrow Road West RH4 3BH Dorking Surrey | United Kingdom | British | 86697870001 | |||||||||
| LEE, Simon Christopher | Amministratore | Moorlands Harrow Road West RH4 3BH Dorking Surrey | United Kingdom | British | 86697870001 | |||||||||
| MATTHEWS, Roderick Alfred | Amministratore | Aros House Rhu G84 8NJ Helensburgh Dunbartonshire | British | 74872510003 | ||||||||||
| MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo | Amministratore | 10 Lochside Place Edinburgh Park EH12 9RG Edinburgh Leven House Scotland Scotland | United Kingdom | British | 173703620001 | |||||||||
| MCNEILL, Ronald | Amministratore | 4/6 New Bells Court Maritime Street EH6 6RY Edinburgh | British | 205550003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PINNACLE CELLULAR LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle Cellular Group Limited | 06 apr 2016 | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
PINNACLE CELLULAR LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Bond & floating charge | Creato il 27 feb 1996 Consegnato il 04 mar 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari The whole assets of the company. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 23 nov 1995 Consegnato il 29 nov 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Shop premises, 27 union street, dundee. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 23 nov 1995 Consegnato il 29 nov 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Shop premises, 35 and 37A high street, ayr. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 14 apr 1994 Consegnato il 26 apr 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Shop 12 leven street, edinburgh. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Bond & floating charge | Creato il 06 apr 1991 Consegnato il 19 apr 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0