PINNACLE CELLULAR LIMITED

PINNACLE CELLULAR LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPINNACLE CELLULAR LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC127133
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PINNACLE CELLULAR LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova PINNACLE CELLULAR LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di PINNACLE CELLULAR LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2023

    Quali sono le ultime deposizioni per PINNACLE CELLULAR LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2023

    5 pagineAA

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Modifica dei dettagli di Pinnacle Cellular Group Limited come persona con controllo significativo il 03 lug 2023

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da Edinburgh House 4 North St. Andrew Street Edinburgh EH2 1HJ United Kingdom a 50 Lothian Road Festival Square Edinburgh EH3 9WJ in data 04 lug 2023

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 feb 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Janine Butler come amministratore in data 23 nov 2022

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2022

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 feb 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021

    5 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di David Nigel Evans come amministratore in data 23 feb 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Janine Butler come amministratore in data 23 feb 2021

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 feb 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 feb 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019

    4 pagineAA

    legacy

    256 paginePARENT_ACC

    legacy

    2 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Indirizzo della sede legale modificato da Leven House 10 Lochside Place Edinburgh Park Edinburgh Scotland EH12 9RG a Edinburgh House 4 North St. Andrew Street Edinburgh EH2 1HJ in data 14 mag 2019

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Andrew Michael Yorston come amministratore in data 02 apr 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Michael Anthony Henry Olivier come amministratore in data 02 apr 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Diane Josephine Mcintyre come amministratore in data 16 mar 2019

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di PINNACLE CELLULAR LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione2357692
    75473330004
    OLIVIER, Michael Anthony Henry
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United Kingdom
    Amministratore
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United Kingdom
    United KingdomBritish257268230001
    YORSTON, Andrew Michael
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United Kingdom
    Amministratore
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United Kingdom
    United KingdomBritish257275320001
    COULL, Gillian Margaret
    62 Alloway Crescent
    FK4 1EZ Bonnybridge
    Stirlingshire
    Segretario
    62 Alloway Crescent
    FK4 1EZ Bonnybridge
    Stirlingshire
    British30641050001
    COULL, Graham
    3 Coney Park
    Kings Park
    FK7 9LU Stirling
    Stirlingshire
    Segretario
    3 Coney Park
    Kings Park
    FK7 9LU Stirling
    Stirlingshire
    British76740000001
    DAWE-LANE, Patrick John Beachim
    Marsh Lane
    Rowde
    SN10 1RE Devizes
    Upper Foxhangers Farm
    Wiltshire
    England
    Segretario
    Marsh Lane
    Rowde
    SN10 1RE Devizes
    Upper Foxhangers Farm
    Wiltshire
    England
    Other130771170001
    EMETULU, Lola
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Segretario
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British88619360002
    JEFFERSON, Karen
    8 Bailey Close
    SN9 5HU Pewsey
    Wiltshire
    Segretario
    8 Bailey Close
    SN9 5HU Pewsey
    Wiltshire
    British79393480001
    MACLEOD, David
    12 Glebe Road
    Newton Mearns
    G77 6DU Glasgow
    Segretario
    12 Glebe Road
    Newton Mearns
    G77 6DU Glasgow
    British32696310001
    REID, Brian
    5 Logie Mill
    Beaverbank Office Park
    EH7 4HH Edinburgh
    Segretario nominato
    5 Logie Mill
    Beaverbank Office Park
    EH7 4HH Edinburgh
    British900007130001
    SCOTT, Stephen Roy
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    Segretario
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    British25660590003
    WHEELER, David
    Carn Mairg
    Wallacestone Brae
    FK2 0DH Brightons
    Stirlingshire
    Segretario
    Carn Mairg
    Wallacestone Brae
    FK2 0DH Brightons
    Stirlingshire
    British102737470001
    ALLAN, William
    Shernfold Meadows
    Wadhurst Road
    TN3 9EH Frant
    East Sussex
    Amministratore
    Shernfold Meadows
    Wadhurst Road
    TN3 9EH Frant
    East Sussex
    UkBritish111131550001
    ALLEN, Christian Philip Quentin
    7 Lochside Avenue
    Edinburgh Park
    EH12 9DJ Edinburgh
    Lochside House
    Scotland
    Scotland
    Amministratore
    7 Lochside Avenue
    Edinburgh Park
    EH12 9DJ Edinburgh
    Lochside House
    Scotland
    Scotland
    British123612980001
    BARR, Duncan David Whyte
    95 Wheatlands Avenue
    FK4 1PJ Bonnybridge
    Stirlingshire
    Amministratore
    95 Wheatlands Avenue
    FK4 1PJ Bonnybridge
    Stirlingshire
    British37411850001
    BREWER, Stephen
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    British79186090002
    BROCKLEHURST, Nigel
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    Amministratore
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    British83126790001
    BUTLER, Janine
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    United Kingdom
    Amministratore
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    United Kingdom
    EnglandBritish277534960001
    CHESWORTH, Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British99525280001
    COULL, Graham
    3 Coney Park
    Kings Park
    FK7 9LU Stirling
    Stirlingshire
    Amministratore
    3 Coney Park
    Kings Park
    FK7 9LU Stirling
    Stirlingshire
    British76740000001
    EVANS, David Nigel
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    United Kingdom
    Amministratore
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    United Kingdom
    United KingdomBritish134975040001
    EVANS, Mark
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British127017870001
    FINCH, Joanne Sarah
    10 Lochside Place
    Edinburgh Park
    EH12 9RG Edinburgh
    Leven House
    Scotland
    Scotland
    Amministratore
    10 Lochside Place
    Edinburgh Park
    EH12 9RG Edinburgh
    Leven House
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish158146620001
    GOW, John Warrender
    32 Cammo Gardens
    Barnton
    EH4 8EQ Edinburgh
    Amministratore
    32 Cammo Gardens
    Barnton
    EH4 8EQ Edinburgh
    British55207220001
    GRAY, Ian
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    Amministratore
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    United KingdomBritish50246030004
    HALFORD, Andrew Nigel
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    British33951180005
    HERROD, Harry Alan
    Dakar, 40 Camelon Road
    FK1 5SH Falkirk
    Amministratore
    Dakar, 40 Camelon Road
    FK1 5SH Falkirk
    British93998280001
    HILLS, Kenneth Cumming
    49 Spottiswoode Street
    EH9 1DQ Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    49 Spottiswoode Street
    EH9 1DQ Edinburgh
    Midlothian
    British65152940001
    KEY, Matthew David
    Yardley School Lane
    Seer Green
    HP9 2QJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Yardley School Lane
    Seer Green
    HP9 2QJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British62981720001
    LANGSTON, Edward
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    Amministratore
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    UkBritish24471140001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish86697870001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish86697870001
    MATTHEWS, Roderick Alfred
    Aros House
    Rhu
    G84 8NJ Helensburgh
    Dunbartonshire
    Amministratore
    Aros House
    Rhu
    G84 8NJ Helensburgh
    Dunbartonshire
    British74872510003
    MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo
    10 Lochside Place
    Edinburgh Park
    EH12 9RG Edinburgh
    Leven House
    Scotland
    Scotland
    Amministratore
    10 Lochside Place
    Edinburgh Park
    EH12 9RG Edinburgh
    Leven House
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish173703620001
    MCNEILL, Ronald
    4/6 New Bells Court
    Maritime Street
    EH6 6RY Edinburgh
    Amministratore
    4/6 New Bells Court
    Maritime Street
    EH6 6RY Edinburgh
    British205550003

    Chi sono le persone con controllo significativo di PINNACLE CELLULAR LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleUnited Kingdom (Scotland)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazioneSc123629
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    PINNACLE CELLULAR LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Bond & floating charge
    Creato il 27 feb 1996
    Consegnato il 04 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The whole assets of the company.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 ott 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 23 nov 1995
    Consegnato il 29 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Shop premises, 27 union street, dundee.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 ott 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 23 nov 1995
    Consegnato il 29 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Shop premises, 35 and 37A high street, ayr.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 ott 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 14 apr 1994
    Consegnato il 26 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Shop 12 leven street, edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 26 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 03 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 06 apr 1991
    Consegnato il 19 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Tsb Bank Scotland PLC
    Transazioni
    • 19 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 11 apr 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0