STAGECOACH EXPRESS LIMITED

STAGECOACH EXPRESS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTAGECOACH EXPRESS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC127800
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STAGECOACH EXPRESS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova STAGECOACH EXPRESS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    10 Dunkeld Road
    Perth
    PH1 5TW
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STAGECOACH EXPRESS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WESTERN SCOTTISH HOLDINGS LIMITED24 ott 199124 ott 1991
    MM&S (2068) LIMITED08 ott 199008 ott 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di STAGECOACH EXPRESS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per STAGECOACH EXPRESS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per STAGECOACH EXPRESS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 20 apr 2015

    • Capitale: GBP 0.05
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    That the amount by which the capital of the company is so reduced be credited to the companys profit and loss account 17/04/2015
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 06 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 apr 2015

    Stato del capitale al 07 apr 2015

    • Capitale: GBP 500,000
    SH01

    Nomina di Mr Michael John Vaux come amministratore in data 06 mar 2015

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2014

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 apr 2014

    Stato del capitale al 08 apr 2014

    • Capitale: GBP 500,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2013

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Leslie Warneford come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 06 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2012

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2011

    4 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    7 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Bilancio annuale redatto al 06 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2010

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Michael John Vaux il 10 ott 2009

    1 pagineCH03

    Nomina di Colin Brown come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2009

    4 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di STAGECOACH EXPRESS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VAUX, Michael John
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Segretario
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    British137383880001
    BROWN, Colin
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish85970020003
    VAUX, Michael John
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish137383880003
    BRADLEY, Dorothy Anne
    191 Mearns Road
    Newton Mearns
    G77 5EP Glasgow
    Segretario
    191 Mearns Road
    Newton Mearns
    G77 5EP Glasgow
    British1169520002
    REAY, David
    49 The Grange
    Tanfield Lea
    DH9 9UT Stanley
    Durham
    Segretario
    49 The Grange
    Tanfield Lea
    DH9 9UT Stanley
    Durham
    British57307420001
    STRACHAN, Norman James
    7 Jenner Place
    DD9 6YL Brechin
    Angus
    Segretario
    7 Jenner Place
    DD9 6YL Brechin
    Angus
    British24916460002
    WHITNALL, Alan Leonard
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    Segretario
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    British54184420002
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Segretario nominato
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    ANDREW, Robert Gervase
    7 Roseberry Grove
    Dalgety Bay
    KY11 9YL Dunfermline
    Fife
    Amministratore
    7 Roseberry Grove
    Dalgety Bay
    KY11 9YL Dunfermline
    Fife
    British54172700002
    BRADLEY, Dorothy Anne
    191 Mearns Road
    Newton Mearns
    G77 5EP Glasgow
    Amministratore
    191 Mearns Road
    Newton Mearns
    G77 5EP Glasgow
    British1169520002
    HOWITT, Malcolm
    36 Castlereagh
    Wynyard Park
    TS22 5QF Billingham
    Amministratore
    36 Castlereagh
    Wynyard Park
    TS22 5QF Billingham
    British14928120002
    KINSKI, Michael John
    Cherry Tree House 268 Dunchurch Road
    CV22 6HX Rugby
    Warwickshire
    Amministratore
    Cherry Tree House 268 Dunchurch Road
    CV22 6HX Rugby
    Warwickshire
    United KingdomBritish58643710001
    LEE, James
    36 Viking Crescent
    Houston
    PA6 7LQ Johnstone
    Renfrewshire
    Amministratore
    36 Viking Crescent
    Houston
    PA6 7LQ Johnstone
    Renfrewshire
    British71190780001
    MONAGHAN, Kenneth
    125 Hayocks Road
    KA20 4DJ Stevenston
    Ayrshire
    Amministratore
    125 Hayocks Road
    KA20 4DJ Stevenston
    Ayrshire
    British6371740002
    NAIRN, John
    25 Castlemains Avenue
    New Cumnock
    KA18 4BQ Cumnock
    Ayrshire
    Amministratore
    25 Castlemains Avenue
    New Cumnock
    KA18 4BQ Cumnock
    Ayrshire
    British6371710001
    REAY, David
    49 The Grange
    Tanfield Lea
    DH9 9UT Stanley
    Durham
    Amministratore
    49 The Grange
    Tanfield Lea
    DH9 9UT Stanley
    Durham
    EnglandBritish57307420001
    RENILSON, Neil John
    Essendean Perth Road
    PH10 6EN Blairgowrie
    Perthshire
    Amministratore
    Essendean Perth Road
    PH10 6EN Blairgowrie
    Perthshire
    British42889750001
    SOUTER, Brian
    Murrayfield House
    St Magdalenes Road
    PH2 0BT Perth
    Perthshire
    Amministratore
    Murrayfield House
    St Magdalenes Road
    PH2 0BT Perth
    Perthshire
    British1436810001
    STRACHAN, Norman James
    7 Jenner Place
    DD9 6YL Brechin
    Angus
    Amministratore
    7 Jenner Place
    DD9 6YL Brechin
    Angus
    British24916460002
    TOY, David James
    29 South Gargieston Drive
    KA1 1TB Kilmarnock
    Ayrshire
    Amministratore
    29 South Gargieston Drive
    KA1 1TB Kilmarnock
    Ayrshire
    British58904690001
    WARNEFORD, Leslie Brian
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish49771140004
    WILSON, Alan Forbes
    17 Fowler Place
    Polmont
    FK2 0XQ Falkirk
    Stirlingshire
    Amministratore
    17 Fowler Place
    Polmont
    FK2 0XQ Falkirk
    Stirlingshire
    ScotlandScottish1169510001
    VINDEX LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Amministratore delegato nominato
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003390001
    VINDEX SERVICES LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Amministratore delegato nominato
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003380001

    STAGECOACH EXPRESS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Bond and floating charge
    Creato il 14 ott 1991
    Consegnato il 22 ott 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The wqhole assets of the company.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 09 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 14 ott 1991
    Consegnato il 16 ott 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Scottish Transport Group
    Transazioni
    • 16 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 11 ago 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0