ASHBOURNE GROUP UK LIMITED

ASHBOURNE GROUP UK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàASHBOURNE GROUP UK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC141431
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ASHBOURNE GROUP UK LIMITED?

    • Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova ASHBOURNE GROUP UK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o DLA PIPER SCOTLAND LLP
    249 West George Street
    G2 4RB Glasgow
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ASHBOURNE GROUP UK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ASHBOURNE LIMITED04 nov 199404 nov 1994
    DALGLEN (NO. 504) LIMITED27 gen 199327 gen 1993
    ASHBOURNE HOLDINGS LIMITED20 gen 199320 gen 1993
    DALGLEN (NO. 504) LIMITED25 nov 199225 nov 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di ASHBOURNE GROUP UK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per ASHBOURNE GROUP UK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario in data 09 ott 2012

    1 pagineTM02

    Avviso di completamento dell'accordo volontario

    6 pagine1.4(Scot)

    Cessazione della carica di Timothy James Bolot come amministratore in data 17 ago 2012

    1 pagineTM01

    Avviso di relazione della riunione che approva l'accordo volontario

    4 pagine1.1(Scot)

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Southern Cross Healthcare the Castle Business Park Lomond Court Ground Floor, Unit 2 Stirling FK9 4TU Scotland in data 20 gen 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 15 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 gen 2012

    Stato del capitale al 18 gen 2012

    • Capitale: GBP 5,364,860
    SH01

    Cessazione della carica di William James Buchan come amministratore in data 15 nov 2011

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Andrew Smith come amministratore in data 01 nov 2011

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen Jonathan Taylor come amministratore in data 26 ott 2011

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Timothy James Bolot come amministratore in data 26 ott 2011

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    30 pagineAA

    Cessazione della carica di William Mcleish come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario

    1 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 15 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Cessazione della carica di Richard Midmer come amministratore

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 193 Bath Street Glasgow G2 4HU in data 27 lug 2010

    1 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Enter into various agreements 14/05/2010
    RES13

    Bilancio redatto al 27 set 2009

    26 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Andrew Smith il 07 gen 2010

    2 pagineCH01

    Nomina di un amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Lynn Fearn come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di ASHBOURNE GROUP UK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector163496070001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Segretario
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    BritishFinance Director53915080001
    FORD, Colin Andrew
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    British70144650001
    HURRELL, Steven Alfred
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    Segretario
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    British82311390001
    KIME, Sean Thomas
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    Segretario
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    British89002440002
    MACFARLANE, Rona Jane
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    Segretario
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    BritishExecutive Consultant62509960001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    Segretario
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    158304650001
    MCLEISH, William David
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor, Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    Segretario
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor, Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    British168970640001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Segretario
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    BritishDirector103588940001
    SPEIRS, Lesley Sarah
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    BritishFinance Director69112020001
    BIGGART BAILLIE & GIFFORD WS
    11 Glenfinlas Street
    Edinburgh
    Lothian
    Segretario nominato
    11 Glenfinlas Street
    Edinburgh
    Lothian
    900005750001
    ABLETT, Julie
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    Amministratore
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    BritishCompany Director57906600001
    BARLOW, George Edward
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director66559170001
    BOLOT, Timothy James
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector107837080002
    BRADEEN, Chester Howard
    Pipers Cottage Grove Heath Road
    Ripley
    GU23 6EU Woking
    Surrey
    Amministratore
    Pipers Cottage Grove Heath Road
    Ripley
    GU23 6EU Woking
    Surrey
    AmericanAlternate Director To A Turner51593550001
    BROKE, Michael Haviland Adlington
    7 Westmead
    Roehampton
    SW15 5BH London
    Amministratore
    7 Westmead
    Roehampton
    SW15 5BH London
    BritishCompany Director2996750001
    BUCHAN, William James
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor, Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    Amministratore
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor, Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    EnglandBritishDirector79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Amministratore
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritishDirector51697890003
    DAVIS, Mary
    Oakdene
    200 Culduthel Road
    IV2 4BH Inverness
    Amministratore
    Oakdene
    200 Culduthel Road
    IV2 4BH Inverness
    BritishDirector76212360001
    DENNY, Nigel John
    Brook House The Manor
    Potton
    SG19 2RN Sandy
    Bedfordshire
    Amministratore
    Brook House The Manor
    Potton
    SG19 2RN Sandy
    Bedfordshire
    BritishOperations Director53339290001
    FARRALL, Elaine Ann
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director14241020001
    FEARN, Lynn
    Elmwood Drive
    DE55 7QJ Alfreton
    24
    Derbyshire
    Amministratore
    Elmwood Drive
    DE55 7QJ Alfreton
    24
    Derbyshire
    United KingdomBritishDirector130867640001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Amministratore
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    ScotlandBritishFinance Director53915080001
    FLAHERTY, James Paul
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    Amministratore
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    AmericanDirector100530310001
    FOULKES, Kamma
    193 Bath Street
    Glasgow
    G2 4HU
    Amministratore
    193 Bath Street
    Glasgow
    G2 4HU
    United KingdomBritishDirector111188390002
    FOULKES, Kamma
    17 Lower Castle Street
    NP7 5EE Abergavenny
    Monmouthshire
    Amministratore
    17 Lower Castle Street
    NP7 5EE Abergavenny
    Monmouthshire
    United KingdomBritishManaging Director111188390002
    GOSLING, Mark David
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    Amministratore
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    BritishDirector66801660002
    GUEST, Walter Henry
    Spindleberry Pine Avenue
    GU15 2LY Camberley
    Surrey
    Amministratore
    Spindleberry Pine Avenue
    GU15 2LY Camberley
    Surrey
    BritishInvestment Director4200040001
    HAMILTON, Thomas Banks
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    Amministratore
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    BritishChief Executive79846610001
    JAP, Chee Miau
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    Amministratore
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    United KingdomSingaporeanDirector101200680001
    LAWRENCE, Stephen John
    The Old Barn Littleton
    SO22 6QS Winchester
    Hants
    Amministratore
    The Old Barn Littleton
    SO22 6QS Winchester
    Hants
    EnglandBritishDirector5579020001
    LEVICK, Ann
    57a Highlands Heath
    SW15 3TX London
    Amministratore
    57a Highlands Heath
    SW15 3TX London
    BritishDirector37880870004
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Amministratore
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritishDirector144822040001
    MCINTEER, Warren Hill
    11 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    11 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritishCompany Director100131200001
    MIDMER, Richard Neil
    The Castle Business Park, Lomond Court
    Ground Floor, Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    C/O Southern Cross Healthcare
    Scotland
    Scotland
    Amministratore
    The Castle Business Park, Lomond Court
    Ground Floor, Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    C/O Southern Cross Healthcare
    Scotland
    Scotland
    EnglandBritishDirector110640170001

    ASHBOURNE GROUP UK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge of acquisition agreement
    Creato il 01 feb 1993
    Consegnato il 19 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    In the charge of acquisition agreement topco as beneficial owner charges by way of first fixed charge to the security agent as a continuing security fot the secured obligations the full benefit of the acquisition agreement and all thhe right title and interest whatsoever of topco therein (together the "charged property").
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 29 nov 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    ASHBOURNE GROUP UK LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 ago 2012Data di completamento o cessazione del CVA
    20 giu 2012Data della riunione per approvare il CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Praticante
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Notescottish-insolvency-info

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0