ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC141433 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | c/o DLA PIPER SCOTLAND LLP 249 West George Street G2 4RB Glasgow United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| DALGLEN (NO. 506) LIMITED | 25 nov 1992 | 25 nov 1992 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario in data 09 ott 2012 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy James Bolot come amministratore in data 31 ago 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Charles Lovett come amministratore in data 31 ago 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Avviso di completamento dell'accordo volontario | 6 pagine | 1.4(Scot) | ||||||||||
Avviso di relazione della riunione che approva l'accordo volontario | 4 pagine | 1.1(Scot) | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Southern Cross Healthcare the Castle Business Park Lomond Court Ground Floor, Unit 2 Stirling FK9 4TU Scotland in data 20 gen 2012 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 gen 2012 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di William James Buchan come amministratore in data 15 nov 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Andrew Smith come amministratore in data 01 nov 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Stephen Jonathan Taylor come amministratore in data 26 ott 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Timothy James Bolot come amministratore in data 26 ott 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2010 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di William Mcleish come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 gen 2011 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Midmer come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 193 Bath Street Glasgow G2 4HU in data 28 lug 2010 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 27 set 2009 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 gen 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr David Andrew Smith il 07 gen 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di un amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOVETT, David Charles | Amministratore | The Grange SW19 4PS London 17 England England | United Kingdom | British | 34419700002 | |||||
| TAYLOR, Stephen Jonathan | Amministratore | c/o Dla Piper Scotland Llp West George Street G2 4RB Glasgow 249 United Kingdom | United Kingdom | British | 163496070001 | |||||
| FEENEY, Martin | Segretario | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | British | 53915080001 | ||||||
| FORD, Colin Andrew | Segretario | 12 Willow Drive Milton Of Campsie G66 8DY Glasgow Lanarkshire | British | 70144650001 | ||||||
| HURRELL, Steven Alfred | Segretario | 8 Hamilton Crescent Bearsden G61 3JP Glasgow Strathclyde | British | 82311390001 | ||||||
| KIME, Sean Thomas | Segretario | Flat 1 3 Nevern Place SW5 9NR London | British | 89002440002 | ||||||
| MACFARLANE, Rona Jane | Segretario | 2/2 5 Doune Quadrant G20 6DL Glasgow | British | 62509960001 | ||||||
| MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Segretario | c/o Dla Piper Scotland Llp West George Street G2 4RB Glasgow 249 United Kingdom | 158304690001 | |||||||
| MCLEISH, William David | Segretario | c/o Southern Cross Healthcare Lomond Court Ground Floor, Unit 2 FK9 4TU Stirling The Castle Business Park Scotland | British | 168970640001 | ||||||
| RUTTER, Christopher | Segretario | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | 103588940001 | ||||||
| SPEIRS, Lesley Sarah | Segretario | 22 Douglas Park Crescent Bearsden G61 3DT Glasgow Lanarkshire | British | 69112020001 | ||||||
| SPEIRS, Lesley Sarah | Segretario | 22 Douglas Park Crescent Bearsden G61 3DT Glasgow Lanarkshire | British | 69112020001 | ||||||
| BIGGART BAILLIE & GIFFORD WS | Segretario nominato | 11 Glenfinlas Street Edinburgh Lothian | 900005750001 | |||||||
| ABLETT, Julie | Amministratore | 166 Rutland Road West Bridgford NG2 5DZ Nottingham | British | 57906600001 | ||||||
| BARLOW, George Edward | Amministratore | 41 Nidd Approach LS22 7UJ Wetherby West Yorkshire | England | British | 66559170001 | |||||
| BOLOT, Timothy James | Amministratore | c/o Dla Piper Scotland Llp West George Street G2 4RB Glasgow 249 United Kingdom | United Kingdom | British | 107837080002 | |||||
| BRADEEN, Chester Howard | Amministratore | Pipers Cottage Grove Heath Road Ripley GU23 6EU Woking Surrey | American | 51593550001 | ||||||
| BUCHAN, William James | Amministratore | c/o Southern Cross Healthcare Lomond Court Ground Floor, Unit 2 FK9 4TU Stirling The Castle Business Park Scotland | England | British | 79917240001 | |||||
| COLVIN, William | Amministratore | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890003 | |||||
| DAVIS, Mary | Amministratore | Oakdene 200 Culduthel Road IV2 4BH Inverness | British | 76212360001 | ||||||
| DENNY, Nigel John | Amministratore | Brook House The Manor Potton SG19 2RN Sandy Bedfordshire | British | 53339290001 | ||||||
| FARRALL, Elaine Ann | Amministratore | Manton Lodge Clumber Park S80 3AX Worksop Nottinghamshire | British | 14241020001 | ||||||
| FEENEY, Martin | Amministratore | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | Scotland | British | 53915080001 | |||||
| FLAHERTY, James Paul | Amministratore | Flat 18 Montagu Court 27-29 Montagu Square W1H 2LG London | American | 100530310001 | ||||||
| FOULKES, Kamma | Amministratore | 193 Bath Street Glasgow G2 4HU | United Kingdom | British | 111188390002 | |||||
| GOSLING, Mark David | Amministratore | Fosse Beck Bewerley HG3 5HX Harrogate | British | 66801660002 | ||||||
| GUEST, Walter Henry | Amministratore | Spindleberry Pine Avenue GU15 2LY Camberley Surrey | British | 4200040001 | ||||||
| HAMILTON, Thomas Banks | Amministratore | 29 Montrose Avenue G52 4LA Hillington Park Glasgow | British | 79846610001 | ||||||
| JAP, Chee Miau | Amministratore | 8 Thurloe Street SW7 2ST London | United Kingdom | Singaporean | 101200680001 | |||||
| LAWRENCE, Stephen John | Amministratore | The Old Barn Littleton SO22 6QS Winchester Hants | England | British | 5579020001 | |||||
| LOCK, Jason David | Amministratore | 32 Monkton Rise TS14 6BG Guisborough Chessington House | England | British | 144822040001 | |||||
| MCINTEER, Warren Hill | Amministratore | 11 Thorn Road Bearsden G61 4PP Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 100131200001 | |||||
| MIDMER, Richard Neil | Amministratore | The Castle Business Park, Lomond Court Ground Floor, Unit 2 FK9 4TU Stirling C/O Southern Cross Healthcare Scotland Scotland | England | British | 110640170001 | |||||
| MURPHY, John | Amministratore | 4 Lochend Road KA10 6JJ Troon | United Kingdom | British | 26177180004 | |||||
| PHIPPEN, Kent William | Amministratore | 12 Elm Tree Road St Johns Wood NW8 9JX London | United Kingdom | American | 84576560001 |
ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of accession and charge | Creato il 21 ago 2008 Consegnato il 03 set 2008 | In corso | Importo garantito All sums due or to become due all sums due or to become due | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 02 set 1996 Consegnato il 18 set 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Fixed and floating charges.collingwood grange,portsmouth road,camberley,surrey. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 02 feb 1995 Acquisito il 03 feb 1995 Consegnato il 12 apr 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due, or to become due | |
Brevi particolari Annfield house, stirling, registered under title number stg 9911. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 19 apr 1994 Consegnato il 22 apr 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Broomcroft, ecclesall road, south sheffield, south yorkshire.... See ch microfiche. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 09 giu 1993 Consegnato il 25 giu 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 174 norwich road, ipswich and 176-182 (even nos) norwich road, ipswich. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 01 feb 1993 Acquisito il 01 feb 1993 Consegnato il 11 mar 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Broomcroft eccleshall road south sheffield and 12 other properties see paper apart 2. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 01 feb 1993 Consegnato il 12 feb 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Area of ground at torr road, quarrier's village, bridge of weir registered title number ren 58217 together with the mines, minerals, metals and fossils within and under the said subjects but that only in so far as the company has right thereto, the whole buildings and other erections if any to be erected thereon, the heritable fittings and fixtures therein and thereon and the parts, pertinents and priveleges thereof. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed charge | Creato il 01 feb 1993 Consegnato il 04 feb 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari A. by way of legal mortgage the mortaged propery as listed in the paper apart, together with all fixed plant and machinery and fixtures thereto. B. by way of specific equitable charge all estates or interests in any freehold or leasehold property (except the mortgaged property and any such property as may be situated in scotland) now or at any time during the subsistence of the charge belonging to or charged to the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 01 feb 1993 Consegnato il 04 feb 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
ASHBOURNE HOMES (DEVELOPMENTS) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA) |
|
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0