CTP SILLECK SCOTLAND LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CTP SILLECK SCOTLAND LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC141586 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CTP SILLECK SCOTLAND LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova CTP SILLECK SCOTLAND LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | c/o C/O BRUNTONS AERO PRODUCTS LIMITED Units 1-3 Block 1 Inveresk Industrial Estate EH21 7PA Musselburgh Midlothian Scotland |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CTP SILLECK SCOTLAND LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SILLECK MOULDINGS (SCOTLAND) LIMITED | 18 gen 1993 | 18 gen 1993 |
| PAYNUMBER LIMITED | 07 dic 1992 | 07 dic 1992 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CTP SILLECK SCOTLAND LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 mar 2026 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 dic 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2025 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per CTP SILLECK SCOTLAND LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 13 giu 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 27 giu 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 13 giu 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per CTP SILLECK SCOTLAND LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2025 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 giu 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Ian Alan Tichias come amministratore in data 01 apr 2025 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Eric George Hutchinson come amministratore in data 31 mar 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2024 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 giu 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Modifica dei dettagli di Carclo Plc come persona con controllo significativo il 14 giu 2024 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di David Michael Bedford come amministratore in data 21 ago 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Eric George Hutchinson come amministratore in data 21 ago 2023 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Memorandum e Statuto | 37 pagine | MA | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione degli oggetti sociali | 2 pagine | CC04 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Angela Wakes come segretario in data 20 giu 2023 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 giu 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Lee George Westgarth come amministratore in data 12 mag 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2023 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Mr David Michael Bedford come amministratore in data 14 nov 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2022 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 giu 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Modifica dei dettagli di Carclo Plc come persona con controllo significativo il 16 nov 2021 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 giu 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Lee George Westgarth il 09 ott 2020 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di CTP SILLECK SCOTLAND LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TICHIAS, Ian Alan | Amministratore | c/o C/O Bruntons Aero Products Limited Inveresk Industrial Estate EH21 7PA Musselburgh Units 1-3 Block 1 Midlothian Scotland | England | British | 334271160001 | |||||
| COLE, Richard Andrew | Segretario | PO BOX 88 27 Dewsbury Road WF5 9WS Ossett Springstone House England | 262035740001 | |||||||
| COOK, Eric | Segretario | 15 Chevet Lane Sandal WF2 6HN Wakefield West Yorkshire | British | 34100510003 | ||||||
| DUNCAN, James Crabb | Segretario | 20 Hawthorn Avenue PA8 7BU Erskine Renfrewshire | British | 58711040001 | ||||||
| HOBBS, Jeffrey Jacques | Segretario | 1 Cedar Copse BR1 2NY Bromley Kent | British | 3252730001 | ||||||
| LIDDLE, Matthew | Segretario | 54 High Street MK45 5DY Flitton Bedfordshire | British | 35090550001 | ||||||
| LONGHORN, James Grahame | Segretario | Ingelthorpe Cresswell Road TS26 0EG Hartlepool Cleveland | British | 42995300001 | ||||||
| OTTAWAY, Richard | Segretario | c/o C/O Bruntons Aero Products Limited Inveresk Industrial Estate EH21 7PA Musselburgh Units 1-3 Block 1 Midlothian Scotland | 199253800001 | |||||||
| WAKES, Angela | Segretario | c/o C/O Bruntons Aero Products Limited Inveresk Industrial Estate EH21 7PA Musselburgh Units 1-3 Block 1 Midlothian Scotland | 263104830001 | |||||||
| OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | Segretario nominato | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 | |||||||
| ADAM, David William | Amministratore | 34 Gill Bank Road LS29 0AU Ilkley West Yorkshire | England | British | 106771550001 | |||||
| ADAMS, John Flannagan | Amministratore | 3 Strawberryfield Road Crosslee PA6 7LA Johnstone Renfrewshire | British | 35787770001 | ||||||
| BEDFORD, David Michael | Amministratore | c/o C/O Bruntons Aero Products Limited Inveresk Industrial Estate EH21 7PA Musselburgh Units 1-3 Block 1 Midlothian Scotland | England | British | 302295360001 | |||||
| CAMPBELL, Drew | Amministratore | 1 Stonefield Gardens PA2 7RH Paisley Renfrewshire | British | 69256200001 | ||||||
| COOK, Eric | Amministratore | 15 Chevet Lane Sandal WF2 6HN Wakefield West Yorkshire | United Kingdom | British | 34100510003 | |||||
| DUNCAN, James Crabb | Amministratore | 20 Hawthorn Avenue PA8 7BU Erskine Renfrewshire | British | 58711040001 | ||||||
| HASLEHURST, Peter Joseph Kinder | Amministratore | Old Crowholt Farm Cowbrook Lane Gawsworth SK11 0JH Macclesfield Cheshire | England | British | 39820040001 | |||||
| HOBBS, Jeffrey Jacques | Amministratore | 1 Cedar Copse BR1 2NY Bromley Kent | British | 3252730001 | ||||||
| HOBBS, Jeffrey Jacques | Amministratore | 1 Cedar Copse BR1 2NY Bromley Kent | British | 3252730001 | ||||||
| HUTCHINSON, Eric George | Amministratore | c/o C/O Bruntons Aero Products Limited Inveresk Industrial Estate EH21 7PA Musselburgh Units 1-3 Block 1 Midlothian Scotland | United Kingdom | British | 278361460001 | |||||
| KURWIE, Tiessir Shhab | Amministratore | 6 Kensington Road WF1 3JX Wakefield West Yorkshire | British | 63799580002 | ||||||
| LOGIE, Ian | Amministratore | 15 Fairways View Hardgate Glasgow | British | 35787830002 | ||||||
| MAWE, Christopher | Amministratore | 5 Back Lane Whixley YO26 8BG York North Yorkshire | British | 99084660001 | ||||||
| MAXTED, Tony | Amministratore | 25 Nursery Grove PA13 4HW Kilmacolm Renfrewshire | British | 69256170001 | ||||||
| MCDOUGAL, Ian Waddell | Amministratore | 10 Belford Grove Newton Mearns G77 5FB Glasgow Lanarkshire | British | 35787780002 | ||||||
| OTTAWAY, Richard John | Amministratore | c/o C/O Bruntons Aero Products Limited Inveresk Industrial Estate EH21 7PA Musselburgh Units 1-3 Block 1 Midlothian Scotland | England | British | 183149280001 | |||||
| REVILL, John Arthur | Amministratore | 43 Haworth Crescent Moorgate S60 3BW Rotherham South Yorkshire | British | 39565760003 | ||||||
| SALT, Roger | Amministratore | 55 Ashford Road Dronfield Woodhouse S18 8RT Dronfield Derbyshire | England | British | 172092330001 | |||||
| WALTON, Neil | Amministratore | Bankfoot Farm Ingleby Greenhow TS9 6LP Middlesbrough Cleveland | England | British | 33358380001 | |||||
| WARDROP, Robert | Amministratore | 49 St Annes Wynd PA8 7DT Erskine Renfrewshire | British | 58710990001 | ||||||
| WESTGARTH, Lee George | Amministratore | c/o C/O Bruntons Aero Products Limited Inveresk Industrial Estate EH21 7PA Musselburgh Units 1-3 Block 1 Midlothian Scotland | England | British | 262033110002 | |||||
| WILLIAMSON, Ian | Amministratore | Longmeadow 10 Edmunton Way LE15 6JE Oakham Rutland Leicester | England | British | 43077420001 | |||||
| WORMSLEY, Bertram Howard | Amministratore | 69 Hervey Road Blackheath SE3 8BX London | British | 3252750001 | ||||||
| YOUNG, Peter James | Amministratore | Mathon House Mathon WR13 5PW Malvern Worcestershire | British | 18300970002 | ||||||
| JORDANS (SCOTLAND) LIMITED | Amministratore delegato nominato | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000000001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CTP SILLECK SCOTLAND LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carclo Plc | 06 apr 2016 | Wates Way CR4 4HR Mitcham 47 Surrey United Kingdom | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
| |||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0