MACRAE FOODS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MACRAE FOODS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC141744 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MACRAE FOODS LIMITED?
- Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi (10200) / Industrie manifatturiere
Dove si trova MACRAE FOODS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 319 St. Vincent Street G2 5AS Glasgow |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MACRAE FOODS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| MOUNTWEST ONE LIMITED | 16 dic 1992 | 16 dic 1992 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MACRAE FOODS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per MACRAE FOODS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||||||
Conto finale prima della dissoluzione in MVL (conto finale allegato) | 7 pagine | LIQ13(Scot) | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Kpmg Llp Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG a 319 st. Vincent Street Glasgow G2 5AS in data 14 mag 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Watermill Road Fraserburgh Aberdeenshire AB43 9HA a C/O Kpmg Llp Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG in data 17 lug 2020 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Stato del capitale al 09 apr 2020
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 dic 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Jenny Nancy Loncaster come amministratore in data 25 set 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Timothy Mark Busby come amministratore in data 12 set 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2019 al 31 mar 2020 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Michael Kamiel Jan Alfons Kestemont come amministratore in data 04 lug 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Wilkin Chapman Company Secretarial Services Limited come segretario in data 04 lug 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 dic 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Wilkin Chapman Company Secretarial Service Ltd il 19 nov 2018 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Malcolm Herbert Lofts come amministratore in data 31 dic 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Timothy Mark Busby come amministratore in data 31 dic 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Malcolm Herbert Lofts come amministratore in data 31 dic 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 dic 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2016 | 6 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 dic 2016 con aggiornamenti | 7 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di MACRAE FOODS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESTEMONT, Michael Kamiel Jan Alfons | Amministratore | St. Vincent Street G2 5AS Glasgow 319 | United Kingdom | Belgian | 231792890001 | |||||||||
| GAULT, Sandra | Segretario | 25 Pitblae Gardens AB43 7BH Fraserburgh Aberdeenshire | British | 61174690002 | ||||||||||
| STRONACHS | Segretario nominato | 34 Albyn Place AB10 1FW Aberdeen Aberdeenshire | 900000500001 | |||||||||||
| WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario nominato | 26 Chantry Lane DN31 2LJ Grimsby Cartergate House England |
| 900013350001 | ||||||||||
| ALLAN, David Martin | Amministratore | Silverdale South Avenue Cults AB15 9LP Aberdeen Aberdeenshire | British | 41797230002 | ||||||||||
| ANDERSON, Stuart Anthony Kidston | Amministratore | Allee Du Cloitre 7 FOREIGN Brussels 1000 Belgium | British | 71513420001 | ||||||||||
| BRITTON, Christopher Paul | Amministratore | Park Grange Main Street LS22 4AP Sicklinghall West Yorkshire | United Kingdom | British | 127835580001 | |||||||||
| BROWN, Cameron Matthew | Amministratore | 26 St Clair Wynd Newburgh AB41 6DZ Ellon Aberdeenshire | British | 61176080001 | ||||||||||
| BUSBY, Timothy Mark | Amministratore | Watermill Road Fraserburgh AB43 9HA Aberdeenshire | England | English | 169852920001 | |||||||||
| DEN HOLLANDER, Leendert Pieter | Amministratore | Watermill Road Fraserburgh AB43 9HA Aberdeenshire | England | Dutch | 166335910001 | |||||||||
| HARKJAER, Per | Amministratore | Oakridge House 6 Montrose Gardens Oxshott KT22 0UU Leatherhead Surrey | England | Danish | 127032620001 | |||||||||
| HAZELDEAN, James William | Amministratore | 6a Balmoral Court Gleneagles Village PH3 1SH Auchterarder Perthshire | Scotland | British | 10359650007 | |||||||||
| KNUTTON, Roderick Leonard | Amministratore | Loanhead Of Pitinnan Daviot AB51 0JH Inverurie Aberdeenshire | British | 35167880001 | ||||||||||
| LEADBEATER, Stephen Paul | Amministratore | Allt Nam Breac Mill Lane, Legbourne LN11 8LT Louth Lincolnshire | England | British | 84487230001 | |||||||||
| LOFTS, Malcolm Herbert | Amministratore | Watermill Road Fraserburgh AB43 9HA Aberdeenshire | England | British | 177239110001 | |||||||||
| LONCASTER, Jenny Nancy | Amministratore | Watermill Road Fraserburgh AB43 9HA Aberdeenshire | England | British | 185293570001 | |||||||||
| PARKER, Michael | Amministratore | Humber Lodge Old Post Office Lane South Ferriby DN18 6HH Barton Upon Humber N E Lincolnshire | United Kingdom | British | 2785890001 | |||||||||
| PORTEOUS, Ronald | Amministratore | Coirseunan Lodge Whitecairns AB23 8UN Aberdeen | British | 42171410001 | ||||||||||
| WRIGHT, Robin James Morrison | Amministratore | 7 Buckland Gate Wexham SL3 6LS Slough Berkshire | United Kingdom | British | 71513490001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MACRAE FOODS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Young's Seafood Limited | 06 apr 2016 | Wickham Road DN31 3SW Grimsby Ross House North East Lincolnshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
MACRAE FOODS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Creato il 06 nov 2008 Consegnato il 19 nov 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Subjects lying on the north side of watermill road, fraserburgh, aberdeen ABN59533. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 23 ott 2008 Consegnato il 05 nov 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 23 set 2008 Consegnato il 03 ott 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 30 mar 2007 Consegnato il 04 apr 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Subjects lying on the north side of watermill road, fraserburgh ABN59533. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 21 mar 2007 Consegnato il 31 mar 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Fixed charges by way of legal mortgage all material premises, all the subsidary shares and investments and distribution rights, all other interests in any material premises, all plant machinery vehicles computers office and other equipment, all book debts - see form 410 appendix 2 for further details including floating charge over all assets. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 28 mar 2006 Consegnato il 31 mar 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due under the finance documents | |
Brevi particolari The subjects lying on the north side of watermill road, fraserburgh (title number abn 59533). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 16 mar 2006 Consegnato il 29 mar 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due under the finance documents | |
Brevi particolari First legal mortgage over all material premises; first fixed and floating charges over assets. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 12 dic 2005 Consegnato il 20 dic 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 07 dic 2005 Consegnato il 28 dic 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Subjects on north side of watermill road, fraserburgh ABN59533. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 14 lug 2004 Consegnato il 22 lug 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Subjectas lying on the northside of watermill road, fraserburgh--title number ABN59533. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 30 giu 2004 Consegnato il 10 lug 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari First legal mortgage over all material premises; first fixed and floating charges over assets. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 04 ago 2000 Consegnato il 15 ago 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 04 ago 2000 Consegnato il 15 ago 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 22 feb 1993 Consegnato il 03 mar 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari The whole assets of the company. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
MACRAE FOODS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0