BELGRAVE RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED

BELGRAVE RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBELGRAVE RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC142783
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BELGRAVE RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari
    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova BELGRAVE RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4th Floor 115 George Street
    EH2 4JN Edinburgh
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di BELGRAVE RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per BELGRAVE RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per BELGRAVE RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dettagli del segretario cambiati per Terrace Hill (Secretaries) Limited il 28 ott 2015

    1 pagineCH04

    Stato del capitale al 17 set 2015

    • Capitale: GBP 1.00
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    legacy

    1 pagineSH20

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2014

    8 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Philip Alexander Jeremy Leech il 08 giu 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jonathan Martin Austen il 08 giu 2015

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 22 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 feb 2015

    Stato del capitale al 23 feb 2015

    • Capitale: GBP 40,400
    SH01

    Bilancio redatto al 30 set 2013

    13 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * 24 Great King Street Edinburgh EH3 6QN* in data 23 apr 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 22 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 feb 2014

    Stato del capitale al 28 feb 2014

    • Capitale: GBP 40,400
    SH01

    Nomina di Mr Jonathan Martin Austen come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Thomas Walsh come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Philip Alexander Jeremy Leech come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Miranda Kelly come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 set 2012

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    Chi sono gli amministratori di BELGRAVE RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    URBAN&CIVIC (SECRETARIES) LIMITED
    115 George Street
    EH2 4JN Edinburgh
    4th Floor
    United Kingdom
    Segretario
    115 George Street
    EH2 4JN Edinburgh
    4th Floor
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSC154216
    41006000014
    AUSTEN, Jonathan Martin
    W1S 1BJ London
    50 New Bond Street
    United Kingdom
    Amministratore
    W1S 1BJ London
    50 New Bond Street
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director51921200001
    LEECH, Philip Alexander Jeremy
    W1S 1BJ London
    50 New Bond Street
    United Kingdom
    Amministratore
    W1S 1BJ London
    50 New Bond Street
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector77080490002
    FOX, Jacqueline Elizabeth
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    Segretario
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    British35460890004
    GILLEN, Seamus Joseph
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    Segretario
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary66174560001
    MORRISON, John
    Willis Mar
    13 Glen Brae
    FK1 5LT Falkirk
    Central
    Scotland
    Segretario
    Willis Mar
    13 Glen Brae
    FK1 5LT Falkirk
    Central
    Scotland
    British1500260013
    TURNER, David Charles
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Segretario
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Other84007940001
    QUILL SERVE LIMITED
    30 Queensferry Road
    EH4 2HG Edinburgh
    Segretario nominato
    30 Queensferry Road
    EH4 2HG Edinburgh
    900003050001
    CUFLEY, Sean Dominic Hardy
    Bank Cottage Haywards Heath Road
    Balcombe
    RH17 6NF Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    Bank Cottage Haywards Heath Road
    Balcombe
    RH17 6NF Haywards Heath
    West Sussex
    United KingdomBritishChartered Accountant9150920001
    DONNELLY, Anthony
    1 Old Kirk Road
    Corstorphine
    EH12 6JY Edinburgh
    Amministratore
    1 Old Kirk Road
    Corstorphine
    EH12 6JY Edinburgh
    United KingdomBritishDevelopment Director109258700001
    HOWELL, Keith Martin
    Woodbine Cottage Main Street
    EH46 7EA West Linton
    Borders
    Scotland
    Amministratore
    Woodbine Cottage Main Street
    EH46 7EA West Linton
    Borders
    Scotland
    BritishFinance Director1499960004
    HUTCHISON, Graeme
    11 West Savile Gardens
    EH9 3AB Edinburgh
    Amministratore
    11 West Savile Gardens
    EH9 3AB Edinburgh
    BritishBanker38185540002
    IRONSIDE, Ronald Alexander Hamilton
    24 Pentland Avenue
    EH13 0HZ Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    24 Pentland Avenue
    EH13 0HZ Edinburgh
    Midlothian
    BritishChartered Accountant296250001
    KELLY, Miranda Anne
    21 Rozelle Avenue
    Waterside, Newton Mearns
    G77 6YS Glasgow
    Amministratore
    21 Rozelle Avenue
    Waterside, Newton Mearns
    G77 6YS Glasgow
    ScotlandBritishSolicitor62817160003
    LAW, William Blyth
    Loanstone Crossing
    Loanstone
    EH26 8PH Penicuik
    Midlothian
    Amministratore
    Loanstone Crossing
    Loanstone
    EH26 8PH Penicuik
    Midlothian
    BritishHousing Manager33622620002
    LEITH, Brian James
    10 Douglas Avenue
    Lenzie
    G66 4NW Glasgow
    Amministratore
    10 Douglas Avenue
    Lenzie
    G66 4NW Glasgow
    BritishCompany Director61660001
    LEITH, Brian James
    10 Douglas Avenue
    Lenzie
    G66 4NW Glasgow
    Amministratore
    10 Douglas Avenue
    Lenzie
    G66 4NW Glasgow
    BritishCompany Director61660001
    MACDONALD, Donald Ross
    Flat 2r, 37 Bellshaugh Gardens
    Kelvinside
    G12 0SA Glasgow
    Amministratore
    Flat 2r, 37 Bellshaugh Gardens
    Kelvinside
    G12 0SA Glasgow
    United KingdomBritishSolicitor76786510001
    MCDONALD, Derek
    8 Glen Sannox Grove
    Craigmarloch
    G68 0GH Cumbernauld
    Amministratore
    8 Glen Sannox Grove
    Craigmarloch
    G68 0GH Cumbernauld
    ScotlandBritishBank Official190466700001
    MCDOUGALL, Alastair Douglas
    Mayfield House
    Frankscroft
    EH45 9DX Peebles
    Peebleshire
    Amministratore
    Mayfield House
    Frankscroft
    EH45 9DX Peebles
    Peebleshire
    ScotlandBritishCompany Director33622580001
    MCDOWALL, June Patricia
    139 Hamilton Road
    Rutherglen
    G73 3BE Glasgow
    Amministratore
    139 Hamilton Road
    Rutherglen
    G73 3BE Glasgow
    United KingdomBritishCompany Registrar50316470001
    MIDDLETON, Douglas Alister
    16 Wesley Crescent
    Bonnyrigg
    EH19 3RT Edinburgh
    Amministratore
    16 Wesley Crescent
    Bonnyrigg
    EH19 3RT Edinburgh
    BritishChartered Accountant73738070001
    MORRISON, John
    Willis Mar
    13 Glen Brae
    FK1 5LT Falkirk
    Central
    Scotland
    Amministratore
    Willis Mar
    13 Glen Brae
    FK1 5LT Falkirk
    Central
    Scotland
    BritishCompany Secretary1500260013
    PRICHARD, Kim Alan
    24 Pentland Gardens
    EH10 6NW Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    24 Pentland Gardens
    EH10 6NW Edinburgh
    Midlothian
    BritishProperty Developer72744060002
    ROBB, Gordon William
    7 High Buckstone
    Fairmilehead
    EH10 6XS Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    7 High Buckstone
    Fairmilehead
    EH10 6XS Edinburgh
    Midlothian
    BritishChartered Accountant11456230001
    WALSH, Thomas Gerard
    26 Flanders Road
    Chiswick
    W4 1NG London
    Amministratore
    26 Flanders Road
    Chiswick
    W4 1NG London
    EnglandIrishAccountant48520230001
    WILSON, Alistair Barclay
    19 Cauldstream Place
    Milngavie
    G62 7NL Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    19 Cauldstream Place
    Milngavie
    G62 7NL Glasgow
    Lanarkshire
    BritishAccountant426640001
    QUILL FORM LIMITED
    30 Queensferry Road
    EH4 2HG Edinburgh
    Amministratore delegato nominato
    30 Queensferry Road
    EH4 2HG Edinburgh
    900003040001

    BELGRAVE RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security
    Creato il 03 dic 2001
    Consegnato il 19 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Area of ground lying in the parish of belhelvie and county of aberdeen extending to 1 acre 685 decimla or one thousandth parts of an acre.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 19 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 mar 2003Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (419b)
    • 22 giu 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04s)
    • 03 ago 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 03 dic 2001
    Consegnato il 11 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    34,36,40,42,44,46,48 & 49 high mill, high mill court, dundee; 25C, 25A,23B, 21A,21B,11A,15A,15B,17A,17B,19A,19B & 43C taylors lane, dundee.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 11 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 03 dic 2001
    Consegnato il 10 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Flatted dwellinghouses known as 256, 258, 259, 264 and 265 (also known as 2, 6, 8, 18 and 20) castle heather drive, inverness and those plots or areas of ground extending in total to 1071.20 square metres or thereby with the semi-detached dwellinghouse erected thereonknown as plots 268, 269, 272, 273, 415 and 417 (also known as 26, 28, 34, 36, 94 and 98) castle heather drive, inverness.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 10 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 22 giu 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04s)
    • 03 ago 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 03 dic 2001
    Consegnato il 10 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Area of ground lying to the east of castle heather drive, inverness together with whole buildings and other erections thereon being plots 232-255 castle heather drive, inverness.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 10 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 mar 2003Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (419b)
    • 22 giu 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04s)
    • 03 ago 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 03 dic 2001
    Consegnato il 10 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    0.59 hectares of ground at orchard avenue and mossgiel road, ayr.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 10 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 03 dic 2001
    Consegnato il 06 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    25-31 high street, penicuik.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 06 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 12 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 03 dic 2001
    Consegnato il 06 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    6,7 & 8 grandfield, craighall road, newhaven.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 06 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 mar 2003Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (419b)
    • 22 giu 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04s)
    • 03 ago 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Bond & floating charge
    Creato il 26 nov 2001
    Consegnato il 29 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 29 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 dic 2001Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 11 dic 2001Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 11 dic 2001Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 10 apr 2003Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (419b)
    • 05 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Standard security
    Creato il 11 ott 1995
    Consegnato il 18 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects at 25-31 high street, penicuik in the county of midlothian.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 11 ott 1995
    Consegnato il 18 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects extending to fifty nine decimals or one hundreth parts of an hectare or thereby at orchard avenue and mossgiel road ayr.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 11 ott 1995
    Consegnato il 18 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects extending to one acre and six hundred and eighty five decimal or one thousandth parts of an acre or therebyat eigie crescent, balmedie in the parish of belhelvie and county of aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 06 ott 1995
    Consegnato il 06 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    0.59 gectares at orchard avenue and mossgiel road, ayr.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 06 ott 1995
    Consegnato il 06 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    1.685 acres at eigie crescent, balmedie, belhevie, aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 06 ott 1995
    Consegnato il 06 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects at 25-31 high street, penicuik.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 25 set 1995
    Consegnato il 05 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Piece of ground lying in the parish of belhevie, aberdeen, extending to 1.685 acres under exception....... See ch microfiche for full details.
    Persone aventi diritto
    • Scottish Homes
    Transazioni
    • 05 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Minute of agreement
    Creato il 04 apr 1995
    Consegnato il 25 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The rights under a management agreement dated 31/3/95 between the company and adam housing society limited.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Minute of agreement
    Creato il 04 apr 1995
    Consegnato il 25 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The rights under a management contract dated 31/3/95 between the company and adam housing society limited.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Minute of agreement
    Creato il 04 apr 1995
    Consegnato il 07 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The company's rights under a minute of agreement dated 31/3/95
    Brevi particolari
    The management contract.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 22 giu 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04s)
    • 03 ago 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Minute of agreement
    Creato il 04 apr 1995
    Consegnato il 07 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The company's rights under a minute of agreement dated 31/3/95
    Brevi particolari
    The management contract.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 22 giu 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04s)
    • 03 ago 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 03 apr 1995
    Consegnato il 07 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Plots 256,258,259,264,264,268,269,272,273,415,417 and 420 castleheather, inverness.
    Persone aventi diritto
    • Morrison Homes Limited
    Transazioni
    • 07 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 03 apr 1995
    Consegnato il 07 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Plots 9,33,35 and 36 balfour's green, carronshore.
    Persone aventi diritto
    • Morrison Homes Limited
    Transazioni
    • 07 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 03 apr 1995
    Consegnato il 04 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Castle heather development balloan road, inverness.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 03 apr 1995
    Consegnato il 04 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    15 duncan avenue and 1, 3 & 4 rae court, carronvale.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 03 feb 1995
    Consegnato il 23 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    0.59 ha orchard avenue, ayr.
    Persone aventi diritto
    • Scottish Homes
    Transazioni
    • 23 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 22 giu 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04s)
    • 03 ago 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 24 gen 1995
    Consegnato il 25 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due and to become due in terms of a personal bond dated 17/8/93
    Brevi particolari
    Area of ground lying generally to the east and south of castle heather drive, inverness.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0