THE MALMAISON HOTEL (GLASGOW) LIMITED

THE MALMAISON HOTEL (GLASGOW) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE MALMAISON HOTEL (GLASGOW) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC143071
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THE MALMAISON HOTEL (GLASGOW) LIMITED?

    • Alberghi e simili strutture ricettive (55100) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova THE MALMAISON HOTEL (GLASGOW) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o HBJ GATELEY
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THE MALMAISON HOTEL (GLASGOW) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE MALMAISON HOTEL LIMITED17 giu 199317 giu 1993
    COMLAW NO. 319 LIMITED05 mar 199305 mar 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE MALMAISON HOTEL (GLASGOW) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per THE MALMAISON HOTEL (GLASGOW) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere SC1430710035 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC1430710036 in pieno

    4 pagineMR04

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 giu 2016 al 30 set 2016

    1 pagineAA01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Roberts il 11 mag 2016

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 30 giu 2015

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 mar 2016

    Stato del capitale al 17 mar 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Cessazione della carica di Gary Reginald Davis come amministratore in data 17 giu 2015

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere SC1430710038 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC1430710037 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio redatto al 30 giu 2014

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 mar 2015

    Stato del capitale al 26 mar 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere SC1430710035

    5 pagineMR05

    **Parte della proprietà o attività è stata liberata dall'onere ** SC1430710037

    5 pagineMR05

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere SC1430710036

    5 pagineMR05

    Cessazione della carica di as Company Services Limited come segretario in data 31 ago 2014

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Rutland Court Edinburgh EH3 8EY a C/O Hbj Gateley Exchange Tower 19 Canning Street Edinburgh EH3 8EH in data 12 set 2014

    1 pagineAD01

    Stato del capitale al 29 mag 2014

    • Capitale: GBP 1.00
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    legacy

    1 pagineSH20

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Chi sono gli amministratori di THE MALMAISON HOTEL (GLASGOW) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ROBERTS, Paul
    Fleet Place
    EC4M 7WS London
    1
    England
    Amministratore
    Fleet Place
    EC4M 7WS London
    1
    England
    United KingdomBritish168184220001
    BONELLA, Richard John Murray
    Rose House
    Portsmouth Road Ripley
    GU23 6ER Woking
    Surrey
    Segretario
    Rose House
    Portsmouth Road Ripley
    GU23 6ER Woking
    Surrey
    British33446940002
    BRUCE, Graeme Murray
    Madeleine Smith House
    6/7 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    Segretario nominato
    Madeleine Smith House
    6/7 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    British900002440001
    ROBSON, Gail
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    Segretario
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    British100895090001
    TUTTY, Roy James
    The Granary
    Highway Drayton Parslow
    MK17 0JW Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Segretario
    The Granary
    Highway Drayton Parslow
    MK17 0JW Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British61146650001
    AS COMPANY SERVICES LIMITED
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    Segretario
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSC316974
    119906300001
    FILEX SERVICES LIMITED
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    Segretario
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione02566556
    3620420001
    SF SECRETARIES LIMITED
    George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    80
    Segretario
    George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    80
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSC128549
    152751750001
    BALFOUR-LYNN, Richard Gary
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    Amministratore
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    United KingdomBritish34251500001
    BATE, Simon Donald
    27 Southdowns Road
    WA14 3NP Bowden
    Altrincham
    Amministratore
    27 Southdowns Road
    WA14 3NP Bowden
    Altrincham
    British75874130002
    BIBRING, Michael Albert
    Hive Road
    WD2 1JG Bushey Heath
    Conifers
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Hive Road
    WD2 1JG Bushey Heath
    Conifers
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish9320160002
    BIBRING, Michael Albert
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    Amministratore
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    EnglandBritish9320160002
    BLACK, Robin Kennedy
    Nevergood Farmhouse
    Brick Kiln Lane
    TN12 8ES Horsmonden
    Kent
    Amministratore
    Nevergood Farmhouse
    Brick Kiln Lane
    TN12 8ES Horsmonden
    Kent
    United KingdomBritish37965380001
    BLUM, Edward Jesse
    63 Denton Road
    TW1 2TN Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    63 Denton Road
    TW1 2TN Twickenham
    Middlesex
    American65674420001
    BLURTON, Andrew Francis
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    EnglandBritish53724380001
    BLURTON, Andrew Francis
    Old Cedar House
    Guildford Road
    GU6 8LT Cranleigh
    Surrey
    Amministratore
    Old Cedar House
    Guildford Road
    GU6 8LT Cranleigh
    Surrey
    EnglandBritish53724380001
    BOHLMANN, John
    4015 Kirkmeadow Lane
    75287 Dallas
    Texas
    Usa
    Amministratore
    4015 Kirkmeadow Lane
    75287 Dallas
    Texas
    Usa
    American65674380001
    BREARE, Robert Roddick Ackrill
    42 Magdalen Road
    SW18 3NP London
    Amministratore
    42 Magdalen Road
    SW18 3NP London
    British38255700004
    BRUCE, Graeme Murray
    Madeleine Smith House
    6/7 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    Amministratore delegato nominato
    Madeleine Smith House
    6/7 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    British900002440001
    CARREKER, James Don
    6801 Baltimore
    Dallas 75205
    FOREIGN Texas
    Usa
    Amministratore
    6801 Baltimore
    Dallas 75205
    FOREIGN Texas
    Usa
    American66262660001
    CAVE, Ian Bruce
    392 Woodstock Road
    OX2 8AF Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    392 Woodstock Road
    OX2 8AF Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish102741680001
    COOK, Robert Barclay
    Longhoughton Road
    Lesbury
    NE66 3AT Alnwick
    Dukes Ryde
    Northumberland
    Amministratore
    Longhoughton Road
    Lesbury
    NE66 3AT Alnwick
    Dukes Ryde
    Northumberland
    United KingdomBritish136758210001
    DAVIS, Gary Reginald
    Curtiss House
    27 Heritage Avenue
    NW9 5WT London
    Flat 66
    England
    Amministratore
    Curtiss House
    27 Heritage Avenue
    NW9 5WT London
    Flat 66
    England
    EnglandBritish167510270002
    DODD, Andrew Gerard
    96 Park Road
    WA15 9LF Hale
    Cheshire
    Amministratore
    96 Park Road
    WA15 9LF Hale
    Cheshire
    EnglandBritish74768570001
    ELLIOT, Colin David
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    EnglandBritish154267590001
    GALBRAITH, Eric Roger
    Madeleine Smith House
    6/7 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    Amministratore delegato nominato
    Madeleine Smith House
    6/7 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    British900002450001
    HAINING, Andrew
    21 Stratford Grove
    SW15 1NU London
    Amministratore
    21 Stratford Grove
    SW15 1NU London
    British42196640008
    HARRISON, John William
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    Amministratore
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    United KingdomBritish69263980002
    MCCULLOCH, Kenneth Wilfred
    69 Kelvin Court
    G12 0AG Glasgow
    Amministratore
    69 Kelvin Court
    G12 0AG Glasgow
    ScotlandBritish37947170001
    NISBETT, Paul Sandle
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    EnglandBritish132613500001
    PRIESTLEY, Jeremy Robert
    8 Macaulay Road
    Clapham
    SW4 0QX London
    Amministratore
    8 Macaulay Road
    Clapham
    SW4 0QX London
    EnglandBritish766060001
    RAYMOND, Anne
    9324 Waternew
    Dallas 75218
    FOREIGN Texas
    Usa
    Amministratore
    9324 Waternew
    Dallas 75218
    FOREIGN Texas
    Usa
    American66261390001
    SHASHOU, Joseph Saleem
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    Amministratore
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    United KingdomBrazilian51723030002
    SINGH, Jagtar
    West Garden Place
    Kendal Street
    W2 2AQ London
    1
    England
    Amministratore
    West Garden Place
    Kendal Street
    W2 2AQ London
    1
    England
    United KingdomBritish121710890001
    TUTTY, Roy James
    The Granary
    Highway Drayton Parslow
    MK17 0JW Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Granary
    Highway Drayton Parslow
    MK17 0JW Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British61146650001

    THE MALMAISON HOTEL (GLASGOW) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 10 apr 2014
    Consegnato il 17 apr 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    278 west george street glasgow GLA104489 and 160 pitt street glasgow GLA104488.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 17 apr 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 28 nov 2014Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 30 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 10 apr 2014
    Consegnato il 17 apr 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    278 west george street glasgow and 160 pitt street glasgow GLA193266 & GLA193265.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 17 apr 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 28 nov 2014Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 30 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 01 apr 2014
    Consegnato il 15 apr 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 apr 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 22 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 01 apr 2014
    Consegnato il 11 apr 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All intellectual property, all estates or interest in any freehold or leasehold property, all of the chargors rights and interests in any lease document.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 apr 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 28 nov 2014Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 22 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Bond & floating charge
    Creato il 15 apr 2008
    Consegnato il 22 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 12 apr 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 28 giu 2006
    Consegnato il 17 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The companys interest in a lease of the land and buildings erected thereon known as malmaison glasgow, 160 pitt street and 278 west george street, glasgow GLA104488 GLA104489.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 09 giu 2003
    Consegnato il 23 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    160 pitt street & 278 west george street, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • Gmac Commercial Mortgage Bank Europe PLC
    Transazioni
    • 23 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 20 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 03 giu 2003
    Consegnato il 20 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Gmac Commercial Mortgage Bank Europe PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 20 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 23 mag 2003
    Consegnato il 10 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Gmac Commercial Mortgage Bank Europe PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 10 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Assignation of standard security
    Creato il 08 lug 2002
    Consegnato il 17 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under or pursuant to the financing documents
    Brevi particolari
    160 pitt street and 278 west george street, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 08 lug 2002
    Consegnato il 17 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due in terms of a personal bond dated 26 june 2002
    Brevi particolari
    160 pitt street and 278 west george street, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 26 giu 2002
    Consegnato il 08 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 21 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    Charge over construction documentation
    Creato il 02 giu 2002
    Consegnato il 22 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed charge over the company's right, title and interest in the construction documentation.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 28 mar 2001
    Consegnato il 03 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The obligations as contained in the agreement
    Brevi particolari
    160 pitt street and 278 west george street, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • Hotel Invest UK a/S
    Transazioni
    • 03 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 03 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 10 nov 2000
    Consegnato il 21 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    160 pitt street, glasgow and 278 west george street, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale as Security Trustee
    Transazioni
    • 21 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 03 nov 2000
    Consegnato il 23 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Hotel Invest UK a/S
    Transazioni
    • 23 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 03 nov 2000
    Consegnato il 23 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Hotel Invest UK a/S
    Transazioni
    • 23 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 03 nov 2000
    Consegnato il 21 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over property; fixed charge over assets; floating charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale as Trustee
    Transazioni
    • 21 nov 2000Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 21 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 nov 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Bond & floating charge
    Creato il 03 nov 2000
    Consegnato il 21 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale as Trustee
    Transazioni
    • 21 nov 2000Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 21 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 nov 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Standard security
    Creato il 10 apr 1997
    Consegnato il 17 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    278 west george street,glasgow.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Company as Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transazioni
    • 17 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 10 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 10 apr 1997
    Consegnato il 17 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    160 pitt street,glasgow.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Company as Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transazioni
    • 17 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 10 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 02 apr 1997
    Consegnato il 14 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Company as Agent and Trustee for Itself and the Secured Parties
    Transazioni
    • 14 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 02 apr 1997
    Consegnato il 10 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Company as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 10 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 24 apr 1997Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 16 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Standard security
    Creato il 13 mar 1997
    Consegnato il 27 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    160 pitt street,glasgow.
    Persone aventi diritto
    • Arcadian International PLC
    Transazioni
    • 27 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 24 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 13 mar 1997
    Consegnato il 27 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    278 west george street,glasgow.
    Persone aventi diritto
    • Arcadian International PLC
    Transazioni
    • 27 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 24 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0