FRASERS (BROWN STREET) LIMITED

FRASERS (BROWN STREET) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFRASERS (BROWN STREET) LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC143073
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di FRASERS (BROWN STREET) LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
    • Costruzione di edifici commerciali (41201) / Costruzioni
    • Altre attività di costruzione specializzate n.c.a. (43999) / Costruzioni

    Dove si trova FRASERS (BROWN STREET) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    101 Rose Street South Lane
    EH2 3JG Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FRASERS (BROWN STREET) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FAIRBRIAR ASCOT LTD.18 giu 200118 giu 2001
    ILFORD DEVELOPMENTS LIMITED16 set 199316 set 1993
    COMLAW NO. 321 LIMITED05 mar 199305 mar 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di FRASERS (BROWN STREET) LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 set 2025
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 giu 2026
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2024

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per FRASERS (BROWN STREET) LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al15 mag 2026
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma29 mag 2026
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al15 mag 2025
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per FRASERS (BROWN STREET) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Cessazione della carica di Martin James Ratchford come amministratore in data 23 lug 2025

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Ilaria Jane Del Beato come amministratore in data 23 lug 2025

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Jonathan Henry Cheshire Walsh come amministratore in data 23 lug 2025

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Hetal Dinesh Trivedi come amministratore in data 23 lug 2025

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 mag 2025 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 30 set 2024

    12 pagineAA

    legacy

    42 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 mag 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2023

    17 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 mag 2023 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2022

    17 pagineAA

    Bilancio redatto al 30 set 2021

    17 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 mag 2022 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2020

    15 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 mag 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2019

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 mag 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 50 Lothian Road Festival Square Edinburgh EH3 9WJ a 101 Rose Street South Lane Edinburgh Midlothian EH2 3JG in data 17 feb 2020

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Seng Khoon Ng come segretario in data 12 dic 2019

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Seng Khoon Ng come amministratore in data 12 dic 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Seng Khoon Ng come amministratore in data 15 feb 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Martin James Ratchford come amministratore in data 15 feb 2019

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di FRASERS (BROWN STREET) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TRIVEDI, Hetal Dinesh
    Rose Street South Lane
    EH2 3JG Edinburgh
    101
    Midlothian
    Scotland
    Amministratore
    Rose Street South Lane
    EH2 3JG Edinburgh
    101
    Midlothian
    Scotland
    EnglandBritish276156100001
    WALSH, Jonathan Henry Cheshire
    Rose Street South Lane
    EH2 3JG Edinburgh
    101
    Midlothian
    Scotland
    Amministratore
    Rose Street South Lane
    EH2 3JG Edinburgh
    101
    Midlothian
    Scotland
    EnglandBritish132049610002
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    Segretario
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    British812680001
    BRUCE, Graeme Murray
    Madeleine Smith House
    6/7 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    Segretario nominato
    Madeleine Smith House
    6/7 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    British900002440001
    NG, Seng Khoon
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Segretario
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    British90211410001
    RITCHIE, Graham
    60 North Castle Street
    EH2 3LU Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    60 North Castle Street
    EH2 3LU Edinburgh
    Midlothian
    British31167840002
    WRIGHT, Gordon Nicholson
    8 Mossway
    HP9 1TG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Segretario
    8 Mossway
    HP9 1TG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British38011750001
    WRIGHT, Gordon Nicholson
    Thorney Lane
    SL0 9HQ Iver
    Bucks
    Segretario
    Thorney Lane
    SL0 9HQ Iver
    Bucks
    British38011750003
    VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Melville Street
    EH3 7NS Edinburgh
    4a
    Scotland
    Segretario
    Melville Street
    EH3 7NS Edinburgh
    4a
    Scotland
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSC219311
    133355520001
    VALSEC COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Segretario
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione7307485
    154161270001
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    Amministratore
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    UkBritish812680001
    BROWN, Nicholas John
    5 Wendron Close
    Goldsworth Park
    GU21 3PB Woking
    Surrey
    Amministratore
    5 Wendron Close
    Goldsworth Park
    GU21 3PB Woking
    Surrey
    EnglandBritish86030700001
    BRUCE, Graeme Murray
    Madeleine Smith House
    6/7 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    Amministratore delegato nominato
    Madeleine Smith House
    6/7 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    British900002440001
    CHIA, Khong Shoong
    Alexandra Road
    119958 21-00 Alexandra Point
    438
    Singapore
    Amministratore
    Alexandra Road
    119958 21-00 Alexandra Point
    438
    Singapore
    SingaporeSingaporean141112510002
    CONNOR, John Thomas
    7 West Hill Avenue
    KT19 8LE Epsom
    Surrey
    Amministratore
    7 West Hill Avenue
    KT19 8LE Epsom
    Surrey
    British25104060001
    DEL BEATO, Ilaria Jane
    Rose Street South Lane
    EH2 3JG Edinburgh
    101
    Midlothian
    Scotland
    Amministratore
    Rose Street South Lane
    EH2 3JG Edinburgh
    101
    Midlothian
    Scotland
    United KingdomBritish93124450002
    GALBRAITH, Eric Roger
    Madeleine Smith House
    6/7 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    Amministratore delegato nominato
    Madeleine Smith House
    6/7 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    British900002450001
    HANKINSON, Derek William
    Foxlea Manor
    Dorneywood Road
    SL1 8PS Burnham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Foxlea Manor
    Dorneywood Road
    SL1 8PS Burnham
    Buckinghamshire
    British822380001
    LEAR, Simon John Patrick
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Amministratore
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United KingdomBritish138750860001
    LEAR, Simon John Patrick
    2 Orchard Road
    TW1 1LY St Margarets
    Middlesex
    Amministratore
    2 Orchard Road
    TW1 1LY St Margarets
    Middlesex
    United KingdomBritish107485520001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    NG, Seng Khoon
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Amministratore
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    EnglandBritish90211410001
    QUEK, Stanley Swee Han, Dr
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    Amministratore
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    SingaporeSingaporean123800250001
    RATCHFORD, Martin James
    Rose Street South Lane
    EH2 3JG Edinburgh
    101
    Midlothian
    Scotland
    Amministratore
    Rose Street South Lane
    EH2 3JG Edinburgh
    101
    Midlothian
    Scotland
    EnglandBritish255563630001
    READMAN, John Charles Jeffrey
    Mill Of Argatty
    FK16 6DN Doune
    Perthshire
    Amministratore
    Mill Of Argatty
    FK16 6DN Doune
    Perthshire
    British34647400002
    RITCHIE, Graham
    60 North Castle Street
    EH2 3LU Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    60 North Castle Street
    EH2 3LU Edinburgh
    Midlothian
    British31167840002
    RUDDOCKS, Melvyn Andrew
    31 Churchill Drive
    G11 7LN Glasgow
    Amministratore
    31 Churchill Drive
    G11 7LN Glasgow
    British38012010001
    THOMAS, Alastair
    Old Orchard Cottage
    Church Lane
    OX5 2UA Charlton On Otmoor
    Oxfordshire
    Amministratore
    Old Orchard Cottage
    Church Lane
    OX5 2UA Charlton On Otmoor
    Oxfordshire
    EnglandBritish155371690001
    VAN REYK, Philip
    Cherry Tree House
    Chequers Lane
    RG27 0NT Eversley
    Hampshire
    Amministratore
    Cherry Tree House
    Chequers Lane
    RG27 0NT Eversley
    Hampshire
    EnglandBritish76943220003
    WALKER, Bruce Layland
    59 Chiswick Staithe
    Hartington Road
    W4 3TP London
    Amministratore
    59 Chiswick Staithe
    Hartington Road
    W4 3TP London
    United KingdomBritish82714410001
    WOOD-PENN, Richard Cecil
    3 Glebe Road
    Cogenhoe
    NN7 1NR Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    3 Glebe Road
    Cogenhoe
    NN7 1NR Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish99981260001
    WOODEN, Russell Charles
    The Old Stable House
    Finches Lane
    RH16 2PG Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    The Old Stable House
    Finches Lane
    RH16 2PG Haywards Heath
    West Sussex
    EnglandBritish35410970003
    WRIGHT, Gordon Nicholson
    Thorney Lane
    SL0 9HQ Iver
    Bucks
    Amministratore
    Thorney Lane
    SL0 9HQ Iver
    Bucks
    British38011750003

    Chi sono le persone con controllo significativo di FRASERS (BROWN STREET) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Frasers Property (Uk) Limited
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    England
    06 apr 2016
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House, England And Wales
    Numero di registrazione05402640
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0