TIGER (NOMINEES) LIMITED
Panoramica
Nome della società | TIGER (NOMINEES) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | SC143948 |
Giurisdizione | Scozia |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TIGER (NOMINEES) LIMITED?
- Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari
Dove si trova TIGER (NOMINEES) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Collins House Rutland Square EH1 2AA Edinburgh |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TIGER (NOMINEES) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
CHANCERYGATE (AA) PROPERTIES LIMITED | 07 ago 2002 | 07 ago 2002 |
CHANCERYGATE SUON PROPERTIES LIMITED | 11 lug 2002 | 11 lug 2002 |
CARISBROOKE SUON PROPERTIES LIMITED | 14 ott 1998 | 14 ott 1998 |
WEST REGISTER (P.I.3) LIMITED | 12 mag 1993 | 12 mag 1993 |
ROBOSCOT (8) LIMITED | 20 apr 1993 | 20 apr 1993 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TIGER (NOMINEES) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per TIGER (NOMINEES) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2019 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 apr 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2018 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 apr 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2017 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 apr 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2016 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2015 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Michael Joseph O'flynn come amministratore in data 28 ott 2015 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di John Oliver Nesbitt come amministratore in data 28 ott 2015 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon David Austin Davies come amministratore in data 28 ott 2015 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di James Robert Lock come amministratore in data 28 ott 2015 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Gordon Robert Mckie come amministratore in data 28 ott 2015 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 apr 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr. Simon David Austin Davies come amministratore in data 25 apr 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Joseph O'flynn come amministratore in data 25 apr 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Oliver Nesbitt come amministratore in data 25 apr 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Kelleher come amministratore in data 25 apr 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr. Gordon Robert Mckie come amministratore in data 25 apr 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr. James Robert Lock come amministratore in data 25 apr 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Thomas Anthony Barry come segretario in data 01 mar 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di TIGER (NOMINEES) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESBITT, John Oliver | Amministratore | Rutland Square EH1 2AA Edinburgh Collins House Scotland | United Kingdom | British | None | 203614990001 | ||||
O'FLYNN, Michael Joseph | Amministratore | Rutland Square EH1 2AA Edinburgh Collins House | Ireland | Irish | None | 203653720001 | ||||
BARRY, Thomas Anthony | Segretario | Gurraun North IRISH Donoughmore County Cork Ireland | Irish | Accountant | 116825710001 | |||||
MACGILLIVRAY, Shirley Margaret | Segretario | 52 Erskine Road EH52 6XL Broxburn West Lothian | British | 40027890001 | ||||||
MAHENDRA, Myron Murugendra | Segretario | 9 Wellesley Road Chiswick W4 4BS London | British | 62660140005 | ||||||
MILLS, Alan Ewing | Segretario | Sheriffs Park EH49 7SR Linlithgow 87 West Lothian | British | 1268780001 | ||||||
O'NEILL, Brian | Segretario | 7 Woodbrook Rochestown Road IRISH Cork Ireland | Irish | 87734240001 | ||||||
PHOENIX, Christopher John | Segretario | Mount Pleasant Farm Station Road Sturton Le Steeple DN22 9HS Retford Nottinghamshire | British | Accountant | 16220320001 | |||||
BARRY, Thomas Anthony | Amministratore | Gurraun North IRISH Donoughmore County Cork Ireland | Ireland | Irish | Accountant | 116825710001 | ||||
BEATTIE, Robert Henry | Amministratore | 10 Swanston Green EH10 7EW Edinburgh Midlothian | Scotland | British | Bank Official | 27224590001 | ||||
BEATTIE, Robert Henry | Amministratore | 10 Swanston Green EH10 7EW Edinburgh Midlothian | Scotland | British | Bank Official | 27224590001 | ||||
BHATIA, Kamal | Amministratore | 5 Highfields Grove Fitzroy Park N6 6HN London | England | Indian | Property Consultant | 82610530001 | ||||
CARTLEDGE, David Edmund | Amministratore | Raines Lodge Greenway CM13 2NR Brentwood Essex | British | Bank Official | 38897330001 | |||||
DAVIES, Simon David Austin | Amministratore | Berkeley Square W1J 5AL London 40 England | United Kingdom | British | Managing Director | 197508390001 | ||||
FOSTER, Kennedy Campbell | Amministratore | 4 Deacons Court EH49 6BT Linlithgow West Lothian | British | Company Secretary | 70070530001 | |||||
JOHNSON, Andrew William | Amministratore | Fulford Farm Culworth OX17 2HL Banbury Oxfordshire | England | British | Director | 68089410003 | ||||
KELLEHER, Michael | Amministratore | Clifford Street W1S 2FT London 9 England | Ireland | Irish | Director | 99150420001 | ||||
LEE, Peter John Gorringe | Amministratore | South Park Farm Lower South Park RH9 8LF South Godstone Surrey | United Kingdom | British | Solicitor | 83600080001 | ||||
LEWIS, Simon Nicholas Hewitt | Amministratore | Bickley Court 36 Chiselhurst Road BR1 2NW Bickley Kent | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 60744980001 | ||||
LOCK, James Robert | Amministratore | Berkeley Square W1J 5AL London 40 England | United Kingdom | British | Managing Director | 195412690001 | ||||
MCKEAN, Alan Wallace | Amministratore | 141 Colinton Road EH14 1BG Edinburgh | British | Bank Official | 1019950002 | |||||
MCKIE, Gordon Robert | Amministratore | Berkeley Square W1J 5AL London 40 England | England | British | Managing Director | 155757550001 | ||||
MELHUISH, Richard Marcus | Amministratore | The Roundel Buncton Lane, Bolney RH17 5RE Haywards Heath West Sussex | British | Chartered Surveyor | 83530000001 | |||||
NESBITT, John Oliver | Amministratore | Stoke Court Greete SY8 3BX Ludlow Shropshire | England | British | Director | 99542990002 | ||||
O NEIL, Brian | Amministratore | 7 Woodbrook IRISH Rochester Town Cork Ireland | Irish | Company Director | 116920110001 | |||||
O'FLYNN, Michael Joseph | Amministratore | Clifford Street W15 2FT London 9 England | United Kingdom | Irish | Director | 19022840006 | ||||
PHOENIX, Christopher John | Amministratore | Mount Pleasant Farm Station Road Sturton Le Steeple DN22 9HS Retford Nottinghamshire | England | British | Accountant | 16220320001 | ||||
SACH, Derek Stephen | Amministratore | Warren Lodge 32 Leigh Hill Road KT11 2HZ Cobham Surrey | British | Banker | 646390001 | |||||
SHEAVILLS, Ernest Michael | Amministratore | Coombe House, 8 Westgarth Avenue Colinton EH13 0BD Edinburgh | British | Bank Official | 34817880001 | |||||
SPEIRS, Robert | Amministratore | 17 Kings Crescent G84 7RB Helensburgh Dunbartonshire | British | Group Finance Director | 2592770003 | |||||
TOUGH, Eric George William | Amministratore | 4 Doune Terrace EH3 6DY Edinburgh | British | Solicitor | 54132470001 | |||||
WHITEHEAD, Grahame Taylor | Amministratore | Southlea 20 Cammo Crescent EH4 8DZ Edinburgh | British | Bank Official | 1363570003 | |||||
WILLIAMS, John | Amministratore | 13 Doran Drive RH1 6AX Redhill Surrey | British | Chartered Surveyor | 36333640001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di TIGER (NOMINEES) LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiger No2 General Partner Limited | 20 apr 2017 | 126-130 Regent Street W1B 5SE London Carrington House England | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
|
TIGER (NOMINEES) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Floating charge | Creato il 03 ago 2004 Consegnato il 10 ago 2004 | In corso | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Legal mortgage over property at 59-61 high road, wood green, london--title number EGL219750 (see mortgage document for full listing of properties); fixed cahrges over assets; floating charge over same. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 22 lug 2004 Consegnato il 30 lug 2004 | In corso | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 52-58 high street, 5-13 cross wynd and 25-33 queen anne street, dunfermline--title number FFE10416. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignation of rents | Creato il 09 lug 2004 Consegnato il 30 lug 2004 | In corso | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 52-58 high street, 5-13 cross wynd and 25-33 queen anne street, dunfermline. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 15 lug 2002 Consegnato il 24 lug 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due under or in connection with the loan agreement dated 28 june 2002 | |
Brevi particolari Ground floor shop premises known as 39 and 41 king street, kilmarnock. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 15 lug 2002 Consegnato il 24 lug 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due under or in connection with the loan agreement dated 28 june 2002 | |
Brevi particolari The subjects 3 and 5 high street, paisley. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 15 lug 2002 Consegnato il 24 lug 2002 | In corso | Importo garantito All sums due under or in connection with the loan agreement dated 28 june 2002 | |
Brevi particolari Subjects forming 52-58 high street, 5/13 cross wynd & 25/33 queen anne street, dunfermline. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 15 lug 2002 Consegnato il 24 lug 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due under or in connection with the loan agreement dated 28 june 2002 | |
Brevi particolari Subjects forming 43 king street & 14 sandbed street, kilmarnock. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Floating charge | Creato il 03 lug 2002 Consegnato il 17 lug 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Legal mortgage over the property and assets...see ch microfiche for full details. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 20 ott 1998 Consegnato il 22 ott 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 43 king street & 14 sandbed street,kilmarnock. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 20 ott 1998 Consegnato il 22 ott 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 52/58 high street,dunfermline. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 20 ott 1998 Consegnato il 22 ott 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 39/41 king street,kilmarnock. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 20 ott 1998 Consegnato il 22 ott 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 3 & 5 high street,paisley. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignation of rents | Creato il 15 ott 1998 Consegnato il 22 ott 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 43 king street & 14 sandbed street,kilmarnock. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignation of rents | Creato il 15 ott 1998 Consegnato il 22 ott 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 39/41 king street,kilmarnock. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignation of rents | Creato il 15 ott 1998 Consegnato il 22 ott 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 3 & 5 high street,paisley. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignation of rents | Creato il 15 ott 1998 Consegnato il 22 ott 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 52/58 high street,dunfermline. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Floating charge | Creato il 13 ott 1998 Consegnato il 03 nov 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Bond & floating charge | Creato il 13 ott 1998 Consegnato il 03 nov 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0