TIGER (NOMINEES) LIMITED

TIGER (NOMINEES) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTIGER (NOMINEES) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC143948
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TIGER (NOMINEES) LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova TIGER (NOMINEES) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Collins House
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TIGER (NOMINEES) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CHANCERYGATE (AA) PROPERTIES LIMITED07 ago 200207 ago 2002
    CHANCERYGATE SUON PROPERTIES LIMITED11 lug 200211 lug 2002
    CARISBROOKE SUON PROPERTIES LIMITED14 ott 199814 ott 1998
    WEST REGISTER (P.I.3) LIMITED12 mag 199312 mag 1993
    ROBOSCOT (8) LIMITED20 apr 199320 apr 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di TIGER (NOMINEES) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per TIGER (NOMINEES) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2019

    17 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 apr 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2018

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 apr 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2017

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 apr 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2016

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 mag 2016

    Stato del capitale al 02 mag 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    14 pagineAA

    Nomina di Michael Joseph O'flynn come amministratore in data 28 ott 2015

    3 pagineAP01

    Nomina di John Oliver Nesbitt come amministratore in data 28 ott 2015

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Simon David Austin Davies come amministratore in data 28 ott 2015

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di James Robert Lock come amministratore in data 28 ott 2015

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gordon Robert Mckie come amministratore in data 28 ott 2015

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 20 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 giu 2015

    Stato del capitale al 11 giu 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Nomina di Mr. Simon David Austin Davies come amministratore in data 25 apr 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michael Joseph O'flynn come amministratore in data 25 apr 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Oliver Nesbitt come amministratore in data 25 apr 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael Kelleher come amministratore in data 25 apr 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr. Gordon Robert Mckie come amministratore in data 25 apr 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr. James Robert Lock come amministratore in data 25 apr 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Thomas Anthony Barry come segretario in data 01 mar 2015

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di TIGER (NOMINEES) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NESBITT, John Oliver
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Collins House
    Scotland
    Amministratore
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Collins House
    Scotland
    United KingdomBritishNone203614990001
    O'FLYNN, Michael Joseph
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Collins House
    Amministratore
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Collins House
    IrelandIrishNone203653720001
    BARRY, Thomas Anthony
    Gurraun North
    IRISH Donoughmore
    County Cork
    Ireland
    Segretario
    Gurraun North
    IRISH Donoughmore
    County Cork
    Ireland
    IrishAccountant116825710001
    MACGILLIVRAY, Shirley Margaret
    52 Erskine Road
    EH52 6XL Broxburn
    West Lothian
    Segretario
    52 Erskine Road
    EH52 6XL Broxburn
    West Lothian
    British40027890001
    MAHENDRA, Myron Murugendra
    9 Wellesley Road
    Chiswick
    W4 4BS London
    Segretario
    9 Wellesley Road
    Chiswick
    W4 4BS London
    British62660140005
    MILLS, Alan Ewing
    Sheriffs Park
    EH49 7SR Linlithgow
    87
    West Lothian
    Segretario
    Sheriffs Park
    EH49 7SR Linlithgow
    87
    West Lothian
    British1268780001
    O'NEILL, Brian
    7 Woodbrook
    Rochestown Road
    IRISH Cork
    Ireland
    Segretario
    7 Woodbrook
    Rochestown Road
    IRISH Cork
    Ireland
    Irish87734240001
    PHOENIX, Christopher John
    Mount Pleasant Farm Station Road
    Sturton Le Steeple
    DN22 9HS Retford
    Nottinghamshire
    Segretario
    Mount Pleasant Farm Station Road
    Sturton Le Steeple
    DN22 9HS Retford
    Nottinghamshire
    BritishAccountant16220320001
    BARRY, Thomas Anthony
    Gurraun North
    IRISH Donoughmore
    County Cork
    Ireland
    Amministratore
    Gurraun North
    IRISH Donoughmore
    County Cork
    Ireland
    IrelandIrishAccountant116825710001
    BEATTIE, Robert Henry
    10 Swanston Green
    EH10 7EW Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    10 Swanston Green
    EH10 7EW Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishBank Official27224590001
    BEATTIE, Robert Henry
    10 Swanston Green
    EH10 7EW Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    10 Swanston Green
    EH10 7EW Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishBank Official27224590001
    BHATIA, Kamal
    5 Highfields Grove
    Fitzroy Park
    N6 6HN London
    Amministratore
    5 Highfields Grove
    Fitzroy Park
    N6 6HN London
    EnglandIndianProperty Consultant82610530001
    CARTLEDGE, David Edmund
    Raines Lodge
    Greenway
    CM13 2NR Brentwood
    Essex
    Amministratore
    Raines Lodge
    Greenway
    CM13 2NR Brentwood
    Essex
    BritishBank Official38897330001
    DAVIES, Simon David Austin
    Berkeley Square
    W1J 5AL London
    40
    England
    Amministratore
    Berkeley Square
    W1J 5AL London
    40
    England
    United KingdomBritishManaging Director197508390001
    FOSTER, Kennedy Campbell
    4 Deacons Court
    EH49 6BT Linlithgow
    West Lothian
    Amministratore
    4 Deacons Court
    EH49 6BT Linlithgow
    West Lothian
    BritishCompany Secretary70070530001
    JOHNSON, Andrew William
    Fulford Farm
    Culworth
    OX17 2HL Banbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    Fulford Farm
    Culworth
    OX17 2HL Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector68089410003
    KELLEHER, Michael
    Clifford Street
    W1S 2FT London
    9
    England
    Amministratore
    Clifford Street
    W1S 2FT London
    9
    England
    IrelandIrishDirector99150420001
    LEE, Peter John Gorringe
    South Park Farm
    Lower South Park
    RH9 8LF South Godstone
    Surrey
    Amministratore
    South Park Farm
    Lower South Park
    RH9 8LF South Godstone
    Surrey
    United KingdomBritishSolicitor83600080001
    LEWIS, Simon Nicholas Hewitt
    Bickley Court
    36 Chiselhurst Road
    BR1 2NW Bickley
    Kent
    Amministratore
    Bickley Court
    36 Chiselhurst Road
    BR1 2NW Bickley
    Kent
    United KingdomBritishChartered Surveyor60744980001
    LOCK, James Robert
    Berkeley Square
    W1J 5AL London
    40
    England
    Amministratore
    Berkeley Square
    W1J 5AL London
    40
    England
    United KingdomBritishManaging Director195412690001
    MCKEAN, Alan Wallace
    141 Colinton Road
    EH14 1BG Edinburgh
    Amministratore
    141 Colinton Road
    EH14 1BG Edinburgh
    BritishBank Official1019950002
    MCKIE, Gordon Robert
    Berkeley Square
    W1J 5AL London
    40
    England
    Amministratore
    Berkeley Square
    W1J 5AL London
    40
    England
    EnglandBritishManaging Director155757550001
    MELHUISH, Richard Marcus
    The Roundel
    Buncton Lane, Bolney
    RH17 5RE Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    The Roundel
    Buncton Lane, Bolney
    RH17 5RE Haywards Heath
    West Sussex
    BritishChartered Surveyor83530000001
    NESBITT, John Oliver
    Stoke Court
    Greete
    SY8 3BX Ludlow
    Shropshire
    Amministratore
    Stoke Court
    Greete
    SY8 3BX Ludlow
    Shropshire
    EnglandBritishDirector99542990002
    O NEIL, Brian
    7 Woodbrook
    IRISH Rochester Town
    Cork
    Ireland
    Amministratore
    7 Woodbrook
    IRISH Rochester Town
    Cork
    Ireland
    IrishCompany Director116920110001
    O'FLYNN, Michael Joseph
    Clifford Street
    W15 2FT London
    9
    England
    Amministratore
    Clifford Street
    W15 2FT London
    9
    England
    United KingdomIrishDirector19022840006
    PHOENIX, Christopher John
    Mount Pleasant Farm Station Road
    Sturton Le Steeple
    DN22 9HS Retford
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Mount Pleasant Farm Station Road
    Sturton Le Steeple
    DN22 9HS Retford
    Nottinghamshire
    EnglandBritishAccountant16220320001
    SACH, Derek Stephen
    Warren Lodge
    32 Leigh Hill Road
    KT11 2HZ Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Warren Lodge
    32 Leigh Hill Road
    KT11 2HZ Cobham
    Surrey
    BritishBanker646390001
    SHEAVILLS, Ernest Michael
    Coombe House, 8 Westgarth Avenue
    Colinton
    EH13 0BD Edinburgh
    Amministratore
    Coombe House, 8 Westgarth Avenue
    Colinton
    EH13 0BD Edinburgh
    BritishBank Official34817880001
    SPEIRS, Robert
    17 Kings Crescent
    G84 7RB Helensburgh
    Dunbartonshire
    Amministratore
    17 Kings Crescent
    G84 7RB Helensburgh
    Dunbartonshire
    BritishGroup Finance Director2592770003
    TOUGH, Eric George William
    4 Doune Terrace
    EH3 6DY Edinburgh
    Amministratore
    4 Doune Terrace
    EH3 6DY Edinburgh
    BritishSolicitor54132470001
    WHITEHEAD, Grahame Taylor
    Southlea 20 Cammo Crescent
    EH4 8DZ Edinburgh
    Amministratore
    Southlea 20 Cammo Crescent
    EH4 8DZ Edinburgh
    BritishBank Official1363570003
    WILLIAMS, John
    13 Doran Drive
    RH1 6AX Redhill
    Surrey
    Amministratore
    13 Doran Drive
    RH1 6AX Redhill
    Surrey
    BritishChartered Surveyor36333640001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TIGER (NOMINEES) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Tiger No2 General Partner Limited
    126-130 Regent Street
    W1B 5SE London
    Carrington House
    England
    20 apr 2017
    126-130 Regent Street
    W1B 5SE London
    Carrington House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Autorità legaleEnglish
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    TIGER (NOMINEES) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Floating charge
    Creato il 03 ago 2004
    Consegnato il 10 ago 2004
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over property at 59-61 high road, wood green, london--title number EGL219750 (see mortgage document for full listing of properties); fixed cahrges over assets; floating charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 10 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 22 lug 2004
    Consegnato il 30 lug 2004
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    52-58 high street, 5-13 cross wynd and 25-33 queen anne street, dunfermline--title number FFE10416.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 30 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    Assignation of rents
    Creato il 09 lug 2004
    Consegnato il 30 lug 2004
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    52-58 high street, 5-13 cross wynd and 25-33 queen anne street, dunfermline.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 30 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 15 lug 2002
    Consegnato il 24 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under or in connection with the loan agreement dated 28 june 2002
    Brevi particolari
    Ground floor shop premises known as 39 and 41 king street, kilmarnock.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 24 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 08 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 15 lug 2002
    Consegnato il 24 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under or in connection with the loan agreement dated 28 june 2002
    Brevi particolari
    The subjects 3 and 5 high street, paisley.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 24 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 15 lug 2002
    Consegnato il 24 lug 2002
    In corso
    Importo garantito
    All sums due under or in connection with the loan agreement dated 28 june 2002
    Brevi particolari
    Subjects forming 52-58 high street, 5/13 cross wynd & 25/33 queen anne street, dunfermline.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 24 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 15 lug 2002
    Consegnato il 24 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under or in connection with the loan agreement dated 28 june 2002
    Brevi particolari
    Subjects forming 43 king street & 14 sandbed street, kilmarnock.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 24 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 08 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 03 lug 2002
    Consegnato il 17 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over the property and assets...see ch microfiche for full details.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Crp General Partner Limited
    Transazioni
    • 17 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 20 ott 1998
    Consegnato il 22 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    43 king street & 14 sandbed street,kilmarnock.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag as Agent and Trustee for Itself and Others
    Transazioni
    • 22 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 20 ott 1998
    Consegnato il 22 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    52/58 high street,dunfermline.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag as Agent and Trustee for Itself and Others
    Transazioni
    • 22 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 08 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 20 ott 1998
    Consegnato il 22 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    39/41 king street,kilmarnock.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag as Agent and Trustee for Itself and Others
    Transazioni
    • 22 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 20 ott 1998
    Consegnato il 22 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    3 & 5 high street,paisley.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag as Agent and Trustee for Itself and Others
    Transazioni
    • 22 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 08 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Assignation of rents
    Creato il 15 ott 1998
    Consegnato il 22 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    43 king street & 14 sandbed street,kilmarnock.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag as Agent and Trustee for Itself and Others
    Transazioni
    • 22 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 08 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Assignation of rents
    Creato il 15 ott 1998
    Consegnato il 22 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    39/41 king street,kilmarnock.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag as Agent and Trustee for Itself and Others
    Transazioni
    • 22 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 08 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Assignation of rents
    Creato il 15 ott 1998
    Consegnato il 22 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    3 & 5 high street,paisley.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag as Agent and Trustee for Itself and Others
    Transazioni
    • 22 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 08 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Assignation of rents
    Creato il 15 ott 1998
    Consegnato il 22 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    52/58 high street,dunfermline.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag as Agent and Trustee for Itself and Others
    Transazioni
    • 22 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 08 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 13 ott 1998
    Consegnato il 03 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 03 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 13 ott 1998
    Consegnato il 03 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Veriensbank Aktiengesellschaft as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 03 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0