BREEDON NORTHERN LIMITED
Panoramica
Nome della società | BREEDON NORTHERN LIMITED |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | SC144788 |
Giurisdizione | Scozia |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BREEDON NORTHERN LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova BREEDON NORTHERN LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Ethiebeaton Quarry Kingennie DD5 3RB Monifieth Angus |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BREEDON NORTHERN LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
BREEDON AGGREGATES SCOTLAND LIMITED | 06 set 2010 | 06 set 2010 |
ENNSTONE THISTLE LIMITED | 01 ott 1999 | 01 ott 1999 |
THISTLE AGGREGATES LIMITED | 29 giu 1993 | 29 giu 1993 |
TRAVELACTUAL LIMITED | 04 giu 1993 | 04 giu 1993 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BREEDON NORTHERN LIMITED?
Scaduto | No |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2024 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2025 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2023 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per BREEDON NORTHERN LIMITED?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 04 giu 2025 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 18 giu 2025 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 04 giu 2024 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per BREEDON NORTHERN LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notifica di Breedon Midco Limited come persona con controllo significativo il 29 lug 2024 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione di Breedon Group Plc come persona con controllo significativo il 29 lug 2024 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2023 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2024 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2022 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Notifica di Breedon Group Plc come persona con controllo significativo il 09 giu 2023 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione di Breedon Group Plc come persona con controllo significativo il 09 giu 2023 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2023 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr James Edward Brotherton il 03 mag 2023 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2021 | 29 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr James West Atherton-Ham il 30 ago 2022 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2022 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Susan Bolton come segretario in data 01 mar 2022 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Mr James West Atherton-Ham come amministratore in data 01 mar 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alan Craig Morrison come amministratore in data 01 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alan Kenneth Mackenzie come amministratore in data 01 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ross Edward Mcdonald come segretario in data 01 mar 2022 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ross Edward Mcdonald come amministratore in data 01 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Stato del capitale al 13 dic 2021
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2020 | 30 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere SC1447880041 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2021 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di BREEDON NORTHERN LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLTON, Susan | Segretario | Quarry Kingennie DD5 3RB Monifieth Ethiebeaton Angus | 293067200001 | |||||||
ATHERTON-HAM, James West | Amministratore | Quarry Kingennie DD5 3RB Monifieth Ethiebeaton Angus | England | British | General Counsel | 293064500002 | ||||
BROTHERTON, James Edward | Amministratore | Quarry Kingennie DD5 3RB Monifieth Ethiebeaton Angus | England | British | Director | 119871180002 | ||||
WOOD, Robert | Amministratore | Quarry Kingennie DD5 3RB Monifieth Ethiebeaton Angus Scotland | England | British | Chartered Accountant | 131517770001 | ||||
BARLOW, John | Segretario | 43 Durleston Park Drive KT23 4AJ Great Bookham Surrey | British | Accountant | 55010900001 | |||||
GIBBINS, Malcolm | Segretario | 6 Merion Grove DE23 4YR Derby Derbyshire | British | 106989750001 | ||||||
KENNEDY, Ciaran Anthony | Segretario | Robertson Road KY15 5YR Cupar 29 Fife | Northern Irish | Director | 43853920001 | |||||
MCDONALD, Ross Edward | Segretario | Quarry Kingennie DD5 3RB Monifieth Ethiebeaton Angus Scotland | British | Company Secretary | 44092870005 | |||||
MORETON, Nigel Keef | Segretario | Sunnybank 44 Lincoln Croft WS14 0ND Shenstone Staffordshire | British | Chartered Accountant | 57063050001 | |||||
MORRISON, Alan Craig | Segretario | 73 Elie Avenue Broughty Ferry DD5 3SJ Dundee Angus | British | Accountant | 100616240001 | |||||
SMITH, Ian Patrick | Segretario | Coats Drive Luncarty PH1 3FD Perth 26 Perthshire | British | Accountant | 81307600003 | |||||
ANDERSON, Charles John Scott | Amministratore | 2 Chestnut Road IV15 9UQ Dingwall Ross Shire | Scotland | British | Contractor | 104265750001 | ||||
BARLOW, John | Amministratore | 43 Durleston Park Drive KT23 4AJ Great Bookham Surrey | United Kingdom | British | Accountant | 55010900001 | ||||
BAXTER, John | Amministratore | Kelliback House Brathinch DD9 7QZ Brechin Angus | British | Company Director | 81733050001 | |||||
BOWDEN, Philip | Amministratore | 3 Tealby Close Gilmorton LE17 5PT Lutterworth Leicestershire | British | Company Director | 28032710001 | |||||
BRUCE, Graham Forbes | Amministratore | 5 Airyhall View Newburgh AB41 0AW Ellon Aberdeenshire | British | Sales Director | 37764350001 | |||||
CARMICHAEL, Kevin George | Amministratore | 20 James Miller Road KY11 2HQ Dunfermline Fife | Scotland | British | Contractor | 293044570001 | ||||
ENSTON, William Norman | Amministratore | 34 Angusfield Avenue AB2 6AQ Aberdeen | British | Company Director | 45974990001 | |||||
FOLDES, John Henry Roger | Amministratore | Quarry Kingennie DD5 3RB Monifieth Ethiebeaton Angus Scotland | England | British | Chartered Accountant | 146584640002 | ||||
GORDON, Robert | Amministratore | 14 Seafield Drive East AB15 7UX Aberdeen Grampian | Scotland | British | Engineer | 56764180001 | ||||
GORDON, Robert | Amministratore | 14 Seafield Drive East AB15 7UX Aberdeen Grampian | Scotland | British | Quarry Engineer | 56764180001 | ||||
HALDANE, Iain James Macdonald | Amministratore | Manortoun Manor EH45 9JN Peebles Borders | United Kingdom | British | Director | 74495330001 | ||||
KENNEDY, Ciaran Anthony | Amministratore | Robertson Road KY15 5YR Cupar 29 Fife | Scotland | Northern Irish | Accountant | 43853920001 | ||||
MACAULAY, Michael Thomas | Amministratore | Kinellar AB21 0TT Aberdeen Clinterty Grange United Kingdom | Scotland | British | Contractor | 39842880002 | ||||
MACKENZIE, Alan Kenneth | Amministratore | Quarry Kingennie DD5 3RB Monifieth Ethiebeaton Angus Scotland | Scotland | British | Director | 126588100004 | ||||
MACKENZIE, Alan Kenneth | Amministratore | 7 Green Glen S40 3SH Chesterfield Derbyshire | British | Contractor | 76838270002 | |||||
MACKENZIE, John David | Amministratore | 9 Craigmarloch Avenue G64 4AY Torrance East Dunbartonshire | United Kingdom | British | Contractor | 105389440001 | ||||
MCDONALD, Ross Edward | Amministratore | Quarry Kingennie DD5 3RB Monifieth Ethiebeaton Angus | England | British | Company Secretary | 44092870005 | ||||
MCLEOD, Colin Vaughan | Amministratore | The Homestead Ratcliffe Road LE7 4UF Thrussington Leicester | England | British | Company Director | 32924830001 | ||||
MORETON, Nigel Keef | Amministratore | Sunnybank 44 Lincoln Croft WS14 0ND Shenstone Staffordshire | British | Chartered Accountant | 57063050001 | |||||
MORRISON, Alan Craig | Amministratore | Quarry Kingennie DD5 3RB Monifieth Ethiebeaton Angus Scotland | Scotland | British | Accountant | 100616240002 | ||||
OSWALD, William Albert | Amministratore | 26 Coats Drive Luncarty PH1 3FD Perth | Scottish | Contractor | 43831470002 | |||||
PETERS, Ian Alan Duncan | Amministratore | Quarry Kingennie DD5 3RB Monifieth Ethiebeaton Angus Scotland | England | British | Chartered Accountant | 154498310001 | ||||
SMITH, Ian Patrick | Amministratore | Coats Drive Luncarty PH1 3FD Perth 26 Perthshire | United Kingdom | British | Accountant | 81307600003 | ||||
WALLIS, Michael | Amministratore | Brockington Grange HR7 4TF Bredenbury Herefordshire | England | British | Company Director | 34696800004 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BREEDON NORTHERN LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breedon Midco Limited | 29 lug 2024 | Breedon Quarry Breedon On The Hill DE73 8AP Derby Pinnacle House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Breedon Group Plc | 09 giu 2023 | Breedon Quarry Breedon On The Hill DE73 8AP Derby Pinnacle House England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Breedon Group Plc | 06 apr 2016 | Esplanade St. Helier JE2 3QA Jersey 28 Jersey | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
BREEDON NORTHERN LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 17 apr 2018 Consegnato il 26 apr 2018 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 06 lug 2016 Consegnato il 19 lug 2016 | In corso | ||
Breve descrizione 1. the quarries situated at furnace in the parish of inveraray and county of argyll.. 2. the area of seabed lying ex adverso furnace, loch fyne.. 3. the minerals in and under the lands of south craleckan situated at furnace in the parish of inveraray and county of argyll. 4. furnace quarry, kenmore estate, furnace, inveraray. ARG5359. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 17 nov 2015 Consegnato il 19 nov 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 11 mar 2015 Consegnato il 21 mar 2015 | In corso | ||
Breve descrizione Area of ground extending to 8.7 hectares at clovenstone, kintore, aberdeenshire. Title number abn 121318. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 11 lug 2014 Consegnato il 21 lug 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 25 mar 2014 Consegnato il 29 mar 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Subjects known as powmyre quarry glamis (office premises known as blindwells cottage roundyhill glamis angus ANG46598. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 25 mar 2014 Consegnato il 29 mar 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione All and whole the tenants interest in the lease between the perth and kinross council and donald macculloch limited registered in the land registry PTH20923. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 25 mar 2014 Consegnato il 29 mar 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Mill of dyce aberdeen abn 114565. notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 25 mar 2014 Consegnato il 29 mar 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Marybank quarry stornoway ROS15022. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 25 mar 2014 Consegnato il 29 mar 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Area of ground on the west side of longtown street milton of craigie dundee ANG61515. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 25 mar 2014 Consegnato il 29 mar 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Loch airigh na lice isle of lewis ROS15037. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 25 mar 2014 Consegnato il 29 mar 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Subjects lying on the northwest side of greenbank crescent east tullos aberdeen KNC9377. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 25 mar 2014 Consegnato il 29 mar 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Fledmyre quarry forfar ANG61527. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 25 mar 2014 Consegnato il 29 mar 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Faichfield quarry longside peterhead abn 99903. notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 25 mar 2014 Consegnato il 29 mar 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Ceann an ora quarry ardhasaig isle of harris INV11249. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 25 mar 2014 Consegnato il 29 mar 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Carrs corner industrial estate fort william INV31217. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 25 mar 2014 Consegnato il 29 mar 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione All stone ironstone shale and all metals minerals substances and things in or under the land at borrowstone quarry thrumster wick CTH5318. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 25 mar 2014 Consegnato il 29 mar 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Balblair quarry beauly 8HV31197. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 25 feb 2014 Consegnato il 08 mar 2014 | In corso | ||
Breve descrizione Balblair quarry beauly. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 10 set 2012 Consegnato il 14 set 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Area of ground extending to 6.07 hectares or thereby in the parish and earldom of rothes and county of moray, title number MOR12110. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental security deed | Creato il 09 mar 2009 Consegnato il 17 mar 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari All the property undertaking and assets of the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 09 mar 2009 Consegnato il 16 mar 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due all sums due or to become due | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 10 dic 2008 Consegnato il 13 dic 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Tenants interest in a lease of the whinstone at ethiebeaton, monifieth, angus. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 06 giu 2008 Consegnato il 11 giu 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Subjects at cupar, fife FFE28957. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 17 mag 2007 Consegnato il 04 giu 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Debenture including legal mortgage and fixed charge over all land, the securities, intellectual property - see form 410 schedule for more details, including floating charge over all assets. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0