NEWSQUEST MAGAZINES LIMITED

NEWSQUEST MAGAZINES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNEWSQUEST MAGAZINES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC146648
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NEWSQUEST MAGAZINES LIMITED?

    • Edizione di riviste per il grande pubblico e per le imprese (58142) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova NEWSQUEST MAGAZINES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    200 Renfield Street
    Glasgow
    G2 3QB
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NEWSQUEST MAGAZINES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SMG MAGAZINES LIMITED26 giu 200026 giu 2000
    CALEDONIAN MAGAZINES LIMITED28 set 199328 set 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di NEWSQUEST MAGAZINES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per NEWSQUEST MAGAZINES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 gen 2016

    Stato del capitale al 04 gen 2016

    • Capitale: GBP 100,000
    SH01

    Stato del capitale al 23 dic 2015

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Anthony Hunter il 26 nov 2015

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 dic 2014

    6 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Anthony Hunter il 13 gen 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Neil Edward Carpenter il 13 gen 2015

    1 pagineCH03

    Dettagli del segretario cambiati per Simon Alton Westrop il 13 gen 2015

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Henry Kennedy Faure Walker il 13 gen 2015

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 gen 2015

    Stato del capitale al 12 gen 2015

    • Capitale: GBP 100,000
    SH01

    Cessazione della carica di Paul Davidson come amministratore in data 11 nov 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Henry Kennedy Faure Walker come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 dic 2013

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 gen 2014

    Stato del capitale al 07 gen 2014

    • Capitale: GBP 100,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 dic 2012

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 25 dic 2011

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 26 dic 2010

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Neil Edward Carpenter il 23 mar 2010

    1 pagineCH03

    Chi sono gli amministratori di NEWSQUEST MAGAZINES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CARPENTER, Neil Edward
    Quadrant House
    The Quadrant
    SM2 5AS Sutton
    9th And 10th Floors
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Quadrant House
    The Quadrant
    SM2 5AS Sutton
    9th And 10th Floors
    Surrey
    United Kingdom
    British90209080001
    WESTROP, Simon Alton
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British109662340001
    FAURE WALKER, Henry Kennedy
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish187012370001
    HUNTER, Paul Anthony
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandEnglish69320190004
    CLARKE, Sara
    17 Queens Drive
    Westerwood
    G68 0HW Glasgow
    Segretario
    17 Queens Drive
    Westerwood
    G68 0HW Glasgow
    British77963580001
    DAVIDSON, Dawn
    Langhaugh
    Carmichael
    ML12 6PQ Biggar
    Lanarkshire
    Segretario
    Langhaugh
    Carmichael
    ML12 6PQ Biggar
    Lanarkshire
    British51065860001
    HUGHES, Gary William
    64 Crown Road North
    Dowanhill
    G12 9HW Glasgow
    Segretario
    64 Crown Road North
    Dowanhill
    G12 9HW Glasgow
    British72256160002
    HUNTER, Paul Anthony
    15 Downs Way
    KT18 5LU Epsom
    Surrey
    Segretario
    15 Downs Way
    KT18 5LU Epsom
    Surrey
    British69320190002
    SUMMERS, Gavin Brown
    642 Clarkston Road
    G44 3YS Glasgow
    Segretario
    642 Clarkston Road
    G44 3YS Glasgow
    British37360660002
    MD SECRETARIES LIMITED
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Segretario nominato
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    900005110001
    BROWN, James Thomson
    Eyhurst Hall 8 Manor House
    Eyhurst Park Outwood Lane
    KT20 6JP Kingswood
    Surrey
    Amministratore
    Eyhurst Hall 8 Manor House
    Eyhurst Park Outwood Lane
    KT20 6JP Kingswood
    Surrey
    British4154210013
    DAVIDSON, Paul
    Church Street
    KT13 8DP Weybridge
    58
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Church Street
    KT13 8DP Weybridge
    58
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish46356560004
    FLANAGAN, Andrew Henry
    7 Collylinn Road
    Bearsden
    G61 4PN Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    7 Collylinn Road
    Bearsden
    G61 4PN Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish42787120004
    HUDSON, Desmond Gerard
    113 Chancery Lane
    WC2A 1PL London
    The Law Societys Hall
    Amministratore
    113 Chancery Lane
    WC2A 1PL London
    The Law Societys Hall
    United KingdomBritish32094360003
    HUGHES, Gary William
    64 Crown Road North
    Dowanhill
    G12 9HW Glasgow
    Amministratore
    64 Crown Road North
    Dowanhill
    G12 9HW Glasgow
    UkBritish72256160002
    JOHNSTONE, Joseph Blair
    6 Margarets Place
    ML9 2HQ Larkhall
    Lanarkshire
    Amministratore
    6 Margarets Place
    ML9 2HQ Larkhall
    Lanarkshire
    British37530220003
    JONES, Simon Hyde
    Evenlode Cottage Foxcote House
    High Street
    GL56 0AD Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    Amministratore
    Evenlode Cottage Foxcote House
    High Street
    GL56 0AD Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    British37530190003
    KANE, William James
    11 St Peters Street
    Islington
    N1 8JD London
    Amministratore
    11 St Peters Street
    Islington
    N1 8JD London
    British73972820001
    LEITCH, Graham
    11 Priors Grange
    Torphichen
    EH48 4QN Bathgate
    West Lothian
    Amministratore
    11 Priors Grange
    Torphichen
    EH48 4QN Bathgate
    West Lothian
    British37530260003
    MACDONALD, Angus John
    11 Great Western Terrace
    G12 0UP Glasgow
    Amministratore
    11 Great Western Terrace
    G12 0UP Glasgow
    British4120001
    MACDONALD, Ronald Sutherland
    135 Stewarton Drive
    G72 8DH Cambuslang
    Amministratore
    135 Stewarton Drive
    G72 8DH Cambuslang
    United KingdomBritish145418810001
    MCKELVIE, Fiona
    Whiteoaks, 11 Lochbroom Drive
    Newton Mearns
    G77 5PF Glasgow
    Amministratore
    Whiteoaks, 11 Lochbroom Drive
    Newton Mearns
    G77 5PF Glasgow
    British78491980001
    PARK, James Clement
    Balmaha
    Loch Lomond
    G63 0JQ Glasgow
    The Moorings
    United Kingdom
    Amministratore
    Balmaha
    Loch Lomond
    G63 0JQ Glasgow
    The Moorings
    United Kingdom
    United KingdomBritish135739890001
    PERMAN, Raymond John
    14 East Claremont Street
    EH7 4JP Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    14 East Claremont Street
    EH7 4JP Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish380430001
    URE, Michael Glen Mcgregor
    14 Birchgrove
    Houston
    PA6 7DF Johnstone
    Renfrewshire
    Amministratore
    14 Birchgrove
    Houston
    PA6 7DF Johnstone
    Renfrewshire
    British37530150001
    WATT, William George
    34 Wilton Street
    North Kelvinside
    G20 6LE Glasgow
    Amministratore
    34 Wilton Street
    North Kelvinside
    G20 6LE Glasgow
    British72664400001
    MD DIRECTORS LIMITED
    70 Wellington Street
    G2 6SB Glasgow
    Pacific House
    Amministratore delegato nominato
    70 Wellington Street
    G2 6SB Glasgow
    Pacific House
    900005100001
    MD SECRETARIES LIMITED
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Amministratore delegato nominato
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    900005110001

    NEWSQUEST MAGAZINES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Floating charge
    Creato il 18 lug 2002
    Consegnato il 31 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over property defined in the schedule; various fixed charges as defined in the schedule attached to the mortgage document; floating charge over all assets.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 10 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 03 ott 1994
    Consegnato il 21 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due by the company and others
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee
    Transazioni
    • 21 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 21 ott 1994Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 04 dic 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Supplemental debenture
    Creato il 03 ott 1994
    Consegnato il 21 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due by the company and others
    Brevi particolari
    See ch microfiche.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee
    Transazioni
    • 21 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 dic 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 31 dic 1993
    Consegnato il 11 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due by the company and others
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transazioni
    • 11 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 21 ott 1994Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 21 ott 1994Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 04 dic 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Debenture
    Creato il 31 dic 1993
    Consegnato il 11 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due by the company and others
    Brevi particolari
    See companies house microfiche.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transazioni
    • 11 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 dic 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0