CYMRU COUNTRY FEEDS LIMITED

CYMRU COUNTRY FEEDS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCYMRU COUNTRY FEEDS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC146668
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CYMRU COUNTRY FEEDS LIMITED?

    • Produzione di mangimi preparati per animali da allevamento (10910) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova CYMRU COUNTRY FEEDS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o BDO LLP
    4 Atlantic Quay
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CYMRU COUNTRY FEEDS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ISANDCO TWO HUNDRED AND FIFTY THREE LIMITED29 set 199329 set 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di CYMRU COUNTRY FEEDS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CYMRU COUNTRY FEEDS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per CYMRU COUNTRY FEEDS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Verbale della riunione finale di liquidazione volontaria

    3 pagine4.26(Scot)

    Varie

    Section 519
    1 pagineMISC

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 1.18 Alba Innovation Centre Alba Campus Livingston Scotland EH54 7GA a C/O Bdo Llp 4 Atlantic Quay 70 York Street Glasgow G2 8JX in data 23 apr 2015

    2 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 10 apr 2015

    LRESSP

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 nov 2014

    Stato del capitale al 04 nov 2014

    • Capitale: GBP 100,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    11 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    6 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    6 pagineMR04

    Indirizzo della sede legale modificato da * 7 Bain Square Kirkton Campus Livingston EH54 7DQ* in data 12 dic 2013

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 31 ago 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 set 2013

    Stato del capitale al 09 set 2013

    • Capitale: GBP 100,000
    SH01

    Cessazione della carica di Peter Miller come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Leon Barry Abbitt come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mark Steven come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Louis Vernaus come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Maarten Kusters come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    12 pagineMG01s

    legacy

    9 pagineMG01s

    Bilancio annuale redatto al 31 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di Stephen Francis come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Maarten Kusters come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Anthony Christiaanse come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    16 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di CYMRU COUNTRY FEEDS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    Segretario
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione06902863
    140723560001
    ABBITT, Leon Barry
    Stadium Way
    Eurolink Business Park
    ME10 3SP Sittingbourne
    Syndale Court
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Stadium Way
    Eurolink Business Park
    ME10 3SP Sittingbourne
    Syndale Court
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishManaging Director153119640001
    IAIN SMITH & COMPANY
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    Segretario nominato
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    900000570001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    Segretario
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    119967690001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    Segretario
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    39182980003
    CHRISTIAANSE, Anthony Martin
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    Amministratore
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    DutchDirector129239540002
    CREE, Andrew James
    36 Mayflower Drive
    Marford
    LL12 8LD Wrexham
    Clwyd
    Amministratore
    36 Mayflower Drive
    Marford
    LL12 8LD Wrexham
    Clwyd
    BritishPoultry Feed Manager43501370001
    DENTON, Alban Bede
    Park House
    Westfield Road
    KY15 5DR Cupar
    Fife
    Amministratore
    Park House
    Westfield Road
    KY15 5DR Cupar
    Fife
    BritishManaging Director67184980004
    DUNCAN, Alfred John
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    United KingdomBritishDirector402690001
    FRANCIS, Stephen Ronald William
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Amministratore
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director105961550001
    HALL, Michael James
    12 Cherry Orchard
    Holt
    LL13 9AH Wrexham
    Amministratore
    12 Cherry Orchard
    Holt
    LL13 9AH Wrexham
    BritishDirector89996450001
    HOPLEY, Philip Thomas
    Greenmoss Farmhouse
    Castle Fraser
    AB51 7LB Aberdeenshire
    Amministratore
    Greenmoss Farmhouse
    Castle Fraser
    AB51 7LB Aberdeenshire
    BritishDirector957150007
    IMRAY, Iain Murray
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomBritishAccountant63444910001
    KUSTERS, Maarten
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    BelgiumDutchCeo167543410001
    LAMMERS, Antonius Matheus Maria
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt 7005-7023
    The Netherlands
    Amministratore
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt 7005-7023
    The Netherlands
    DutchChief Financial Officer126350570004
    MILLER, Peter John
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Amministratore
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector55542610002
    MURPHY, Andrew Blyth
    Pitlessie House
    Cupar Road, Pitlessie
    KY15 7SU Fife
    Amministratore
    Pitlessie House
    Cupar Road, Pitlessie
    KY15 7SU Fife
    ScotlandBritishDirector89996470002
    PARIS, Walter Walker
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    Amministratore
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    BritishChartered Accountant338220001
    ROXBURGH, Roy
    515 North Deeside Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    Amministratore delegato nominato
    515 North Deeside Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    British900000560001
    SALKELD, David John
    The Old Hall Back Lane
    Bramham
    LS23 6QR Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Old Hall Back Lane
    Bramham
    LS23 6QR Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director111995510001
    SIMS, David John
    Beech House Main Street
    Scarrington
    NG13 9BQ Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Beech House Main Street
    Scarrington
    NG13 9BQ Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishManaging Director52926050001
    STEPHEN, Andrew Michael Duthie
    Speymuir 3 Victoria Street
    AB53 4RE Turriff
    Aberdeenshire
    Scotland
    Amministratore
    Speymuir 3 Victoria Street
    AB53 4RE Turriff
    Aberdeenshire
    Scotland
    ScotlandBritishSalesman/Company Director338210001
    STEVEN, Mark Alexander
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Amministratore
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    ScotlandBritishFinance Director159788300001
    VERNAUS, Louis Antoine Maria
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Amministratore
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    NetherlandsDutchCompany Director146206430001
    WRIGHT, Heather May
    17 Galachlaw Shot
    EH10 7JF Edinburgh
    Amministratore
    17 Galachlaw Shot
    EH10 7JF Edinburgh
    ScotlandBritishChartered Accountant72112170001

    CYMRU COUNTRY FEEDS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Second ranking security agreement
    Creato il 02 ott 2012
    Consegnato il 12 ott 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All rights in respect of assigned receivables. See form for further details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 15 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    First ranking security agreement
    Creato il 02 ott 2012
    Consegnato il 12 ott 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All rights in respect of assigned receivables. See form for further details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 15 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge
    Creato il 29 mag 2007
    Consegnato il 13 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 giu 2007Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 13 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 15 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Floating charge
    Creato il 29 mag 2007
    Consegnato il 13 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 13 giu 2007Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 15 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Bond & floating charge
    Creato il 07 dic 1998
    Consegnato il 24 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 07 dic 1998
    Consegnato il 24 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 28 lug 1998
    Consegnato il 17 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transazioni
    • 17 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 17 ago 1998Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 13 giu 2007Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 15 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Bond & floating charge
    Creato il 28 lug 1998
    Consegnato il 14 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transazioni
    • 14 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 17 ago 1998Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 13 giu 2007Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 15 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Debenture
    Creato il 22 apr 1997
    Consegnato il 08 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums of money or liabilities due or to become due
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage - all the property with all buildings and fixtures thereon,..................fixed and floating charges included..................see ch microfiche for more details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and Others
    Transazioni
    • 08 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 22 ago 1996
    Consegnato il 06 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent and Trustee for Others
    Transazioni
    • 06 set 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Debenture
    Creato il 27 mag 1994
    Consegnato il 14 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage:- all the property with all buildings and fixtures thereon. See companies house microfiche for more information.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and Others
    Transazioni
    • 14 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    CYMRU COUNTRY FEEDS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    10 apr 2015Inizio della liquidazione
    02 set 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Notescottish-insolvency-info

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0