CYMRU COUNTRY FEEDS LIMITED
Panoramica
Nome della società | CYMRU COUNTRY FEEDS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | SC146668 |
Giurisdizione | Scozia |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CYMRU COUNTRY FEEDS LIMITED?
- Produzione di mangimi preparati per animali da allevamento (10910) / Industrie manifatturiere
Dove si trova CYMRU COUNTRY FEEDS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | c/o BDO LLP 4 Atlantic Quay 70 York Street G2 8JX Glasgow |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CYMRU COUNTRY FEEDS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
ISANDCO TWO HUNDRED AND FIFTY THREE LIMITED | 29 set 1993 | 29 set 1993 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CYMRU COUNTRY FEEDS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CYMRU COUNTRY FEEDS LIMITED?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per CYMRU COUNTRY FEEDS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Verbale della riunione finale di liquidazione volontaria | 3 pagine | 4.26(Scot) | ||||||||||
Varie Section 519 | 1 pagine | MISC | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Unit 1.18 Alba Innovation Centre Alba Campus Livingston Scotland EH54 7GA a C/O Bdo Llp 4 Atlantic Quay 70 York Street Glasgow G2 8JX in data 23 apr 2015 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 ago 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 11 in pieno | 6 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 12 in pieno | 6 pagine | MR04 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * 7 Bain Square Kirkton Campus Livingston EH54 7DQ* in data 12 dic 2013 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 ago 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Peter Miller come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Leon Barry Abbitt come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Steven come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Louis Vernaus come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Maarten Kusters come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
legacy | 12 pagine | MG01s | ||||||||||
legacy | 9 pagine | MG01s | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 ago 2012 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Francis come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Maarten Kusters come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Anthony Christiaanse come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CYMRU COUNTRY FEEDS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED | Segretario | Floor 6 St. Andrew Street EC4A 3AE London 5th United Kingdom |
| 140723560001 | ||||||||||
ABBITT, Leon Barry | Amministratore | Stadium Way Eurolink Business Park ME10 3SP Sittingbourne Syndale Court Kent United Kingdom | England | British | Managing Director | 153119640001 | ||||||||
IAIN SMITH & COMPANY | Segretario nominato | 18-20 Queen's Road AB15 4ZT Aberdeen Grampian | 900000570001 | |||||||||||
MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Segretario | 66 Queen's Road AB15 4YE Aberdeen | 119967690001 | |||||||||||
MAWLAW SECRETARIES LIMITED | Segretario | Bishopsgate EC2M 3AF London 201 | 39182980003 | |||||||||||
CHRISTIAANSE, Anthony Martin | Amministratore | 3065 Sc Rotterdam 's-Gravenweg 551 The Netherlands | Dutch | Director | 129239540002 | |||||||||
CREE, Andrew James | Amministratore | 36 Mayflower Drive Marford LL12 8LD Wrexham Clwyd | British | Poultry Feed Manager | 43501370001 | |||||||||
DENTON, Alban Bede | Amministratore | Park House Westfield Road KY15 5DR Cupar Fife | British | Managing Director | 67184980004 | |||||||||
DUNCAN, Alfred John | Amministratore | Saetra House Inchmarlo Road AB31 3RR Banchory Aberdeenshire | United Kingdom | British | Director | 402690001 | ||||||||
FRANCIS, Stephen Ronald William | Amministratore | Bain Square Kirkton Campus EH54 7DQ Livingston 7 United Kingdom | England | British | Finance Director | 105961550001 | ||||||||
HALL, Michael James | Amministratore | 12 Cherry Orchard Holt LL13 9AH Wrexham | British | Director | 89996450001 | |||||||||
HOPLEY, Philip Thomas | Amministratore | Greenmoss Farmhouse Castle Fraser AB51 7LB Aberdeenshire | British | Director | 957150007 | |||||||||
IMRAY, Iain Murray | Amministratore | 41 Hammersmith Road AB10 6NA Aberdeen Aberdeenshire | United Kingdom | British | Accountant | 63444910001 | ||||||||
KUSTERS, Maarten | Amministratore | Floor 6 St. Andrew Street EC4A 3AE London 5th United Kingdom | Belgium | Dutch | Ceo | 167543410001 | ||||||||
LAMMERS, Antonius Matheus Maria | Amministratore | 5692 Hb Son En Breugel Ekkersrijt 7005-7023 The Netherlands | Dutch | Chief Financial Officer | 126350570004 | |||||||||
MILLER, Peter John | Amministratore | Bain Square Kirkton Campus EH54 7DQ Livingston 7 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 55542610002 | ||||||||
MURPHY, Andrew Blyth | Amministratore | Pitlessie House Cupar Road, Pitlessie KY15 7SU Fife | Scotland | British | Director | 89996470002 | ||||||||
PARIS, Walter Walker | Amministratore | 21 Hillview Road AB31 4EG Banchory Kincardineshire Scotland | British | Chartered Accountant | 338220001 | |||||||||
ROXBURGH, Roy | Amministratore delegato nominato | 515 North Deeside Road AB15 4ZT Aberdeen Grampian | British | 900000560001 | ||||||||||
SALKELD, David John | Amministratore | The Old Hall Back Lane Bramham LS23 6QR Wetherby West Yorkshire | England | British | Company Director | 111995510001 | ||||||||
SIMS, David John | Amministratore | Beech House Main Street Scarrington NG13 9BQ Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | Managing Director | 52926050001 | ||||||||
STEPHEN, Andrew Michael Duthie | Amministratore | Speymuir 3 Victoria Street AB53 4RE Turriff Aberdeenshire Scotland | Scotland | British | Salesman/Company Director | 338210001 | ||||||||
STEVEN, Mark Alexander | Amministratore | Bain Square Kirkton Campus EH54 7DQ Livingston 7 United Kingdom | Scotland | British | Finance Director | 159788300001 | ||||||||
VERNAUS, Louis Antoine Maria | Amministratore | Bain Square Kirkton Campus EH54 7DQ Livingston 7 United Kingdom | Netherlands | Dutch | Company Director | 146206430001 | ||||||||
WRIGHT, Heather May | Amministratore | 17 Galachlaw Shot EH10 7JF Edinburgh | Scotland | British | Chartered Accountant | 72112170001 |
CYMRU COUNTRY FEEDS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Second ranking security agreement | Creato il 02 ott 2012 Consegnato il 12 ott 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari All rights in respect of assigned receivables. See form for further details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
First ranking security agreement | Creato il 02 ott 2012 Consegnato il 12 ott 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari All rights in respect of assigned receivables. See form for further details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Floating charge | Creato il 29 mag 2007 Consegnato il 13 giu 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
Floating charge | Creato il 29 mag 2007 Consegnato il 13 giu 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
Bond & floating charge | Creato il 07 dic 1998 Consegnato il 24 dic 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Floating charge | Creato il 07 dic 1998 Consegnato il 24 dic 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Floating charge | Creato il 28 lug 1998 Consegnato il 17 ago 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
Bond & floating charge | Creato il 28 lug 1998 Consegnato il 14 ago 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
Debenture | Creato il 22 apr 1997 Consegnato il 08 mag 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums of money or liabilities due or to become due | |
Brevi particolari By way of first legal mortgage - all the property with all buildings and fixtures thereon,..................fixed and floating charges included..................see ch microfiche for more details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Bond & floating charge | Creato il 22 ago 1996 Consegnato il 06 set 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 27 mag 1994 Consegnato il 14 giu 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari By way of first legal mortgage:- all the property with all buildings and fixtures thereon. See companies house microfiche for more information. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
CYMRU COUNTRY FEEDS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0