DOUGLAS SHELF SIX LIMITED
Panoramica
| Nome della società | DOUGLAS SHELF SIX LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC146941 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di DOUGLAS SHELF SIX LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova DOUGLAS SHELF SIX LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Venlaw 349 Bath Street G2 4AA Glasgow Scotland |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di DOUGLAS SHELF SIX LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| JOLLYBASE ASSOCIATES LIMITED | 13 ott 1993 | 13 ott 1993 |
Quali sono gli ultimi bilanci di DOUGLAS SHELF SIX LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per DOUGLAS SHELF SIX LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 ott 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2017 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 ott 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 ott 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 8 Elmbank Gardens Glasgow G2 4NQ a Venlaw 349 Bath Street Glasgow G2 4AA in data 17 ott 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 ott 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 ott 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 ott 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 ott 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Venlaw Building 349 Bath Street Glasgow G2 4AA* in data 08 mag 2012 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2011 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 ott 2011 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2010 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 ott 2010 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2009 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 ott 2009 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Derek Porter il 05 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di DOUGLAS SHELF SIX LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMINE, Douglas Alexander | Segretario | 349 Bath Street G2 4AA Glasgow Venlaw Scotland | British | 85590510001 | ||||||
| CLAPHAM, Ronald Barrie | Amministratore | 349 Bath Street G2 4AA Glasgow Venlaw Scotland | England | British | 101562830005 | |||||
| PORTER, Derek | Amministratore | 349 Bath Street G2 4AA Glasgow Venlaw Scotland | United Kingdom | British | 47585310001 | |||||
| TOWERS, Thomas Peacock | Segretario | 9 Rannoch Avenue Newton Mearns G77 6LN Glasgow Lanarkshire | British | 3947680001 | ||||||
| MACROBERTS | Segretario | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | 32443220001 | |||||||
| OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | Segretario nominato | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 | |||||||
| SECRETAR SECURITIES LIMITED | Segretario | 249 West George Street G2 4RB Glasgow | 77605900001 | |||||||
| CLAPHAM, Mari Alexander | Amministratore | 6 Kirklee Terrace G12 0TQ Glasgow | United Kingdom | British | 118413430001 | |||||
| JORDANS (SCOTLAND) LIMITED | Amministratore delegato nominato | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000000001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di DOUGLAS SHELF SIX LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
|---|---|---|---|
| Mr Ronald Barrie Clapham | 06 apr 2016 | 349 Bath Street G2 4AA Glasgow Venlaw Scotland | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: Gibraltar | |||
Natura del controllo
| |||
DOUGLAS SHELF SIX LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Creato il 31 gen 1994 Consegnato il 14 feb 1994 | In corso | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari All and whole the tenant's interest in and to the lease among the corporation of the city of dundee and hesketh estates limited and another dated eighteenth an twenty first may and recorded in the division of the general register of sasines F0R the county of angus for publication and registered in the books of council and session for preservation and execution on second august, both months of nineteen hundred and seventy three under exception of (a) those thirty two dwellinghouse describedin the partial renuncaition dated first december nineteen hundred and eighty two and seventeenth january 1983 and recorded in the said division of the general register of sasineson 03/03/1983 granted by hesketh estates limited with consent of hallmark securities limited in favour of the city of dundee district council and (b)the highgate shopping centre, lochee,dundee and recorded in the said division of the generaregiser of sasines 18/10/1988 (one)the minute of agreement dated 21/12/1982 and-17/01/1983(two) deed of declaration and conditions in respect of the weaver village, high street, lochee,dundee dated 28/06/88 and 11/07/1988. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Bond & floating charge | Creato il 28 gen 1994 Consegnato il 31 gen 1994 | In corso | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0