SULZER (ABERDEEN) LIMITED

SULZER (ABERDEEN) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSULZER (ABERDEEN) LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC147952
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di SULZER (ABERDEEN) LIMITED?

    • fabbricazione di altre macchine per scopi speciali n.c.a. (28990) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova SULZER (ABERDEEN) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Formartine House Castle Street
    Castlepark Industrial Estate
    AB41 9RF Ellon
    Scotland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SULZER (ABERDEEN) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SULZER WOOD LIMITED10 gen 199410 gen 1994
    ALLCAST LIMITED09 dic 199309 dic 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di SULZER (ABERDEEN) LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2025
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2026
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2024

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per SULZER (ABERDEEN) LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al25 mar 2026
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma08 apr 2026
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al25 mar 2025
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per SULZER (ABERDEEN) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Cessazione della carica di John Rowland Davenport come amministratore in data 10 dic 2025

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Jonathon Ellis come amministratore in data 10 dic 2025

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2024

    35 pagineAA

    Nomina di Ms Helen Hanlon come amministratore in data 21 mag 2025

    2 pagineAP01

    Nomina di Ms Vanessa Jackson come amministratore in data 21 mag 2025

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ravin Pillay Ramsamy come amministratore in data 21 mag 2025

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 mar 2025 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2023

    34 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 mar 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Holger Hans-Jochen Ruckstuhl come amministratore in data 20 mar 2024

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2022

    35 pagineAA

    Cessazione della carica di Philippe Andreas Dewitz come amministratore in data 23 mag 2023

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 mar 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2021

    41 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 mar 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Christian Powles come amministratore in data 17 gen 2022

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr John Rowland Davenport come amministratore in data 17 gen 2022

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    36 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christian Powles il 02 giu 2021

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da . Castle Road Industrial Estate Ellon Aberdeenshire AB41 9RF Scotland a Formartine House Castle Street Castlepark Industrial Estate Ellon AB41 9RF in data 19 apr 2021

    1 pagineAD01

    Cessazione di Wood Group Engineering & Operations Support Limited come persona con controllo significativo il 22 mar 2021

    1 paginePSC07

    Cessazione della carica di Iain Angus Jones come segretario in data 22 mar 2021

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Ravin Pillay Ramsamy come amministratore in data 22 mar 2021

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Holger Hans-Jochen Ruckstuhl come amministratore in data 22 mar 2021

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 mar 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di SULZER (ABERDEEN) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ELLIS, David Jonathon
    Castle Street
    Castlepark Industrial Estate
    AB41 9RF Ellon
    Formartine House
    Scotland
    Amministratore
    Castle Street
    Castlepark Industrial Estate
    AB41 9RF Ellon
    Formartine House
    Scotland
    ScotlandBritish285759210001
    HANLON, Helen
    6502 Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7WL Birmingham
    6502
    England
    Amministratore
    6502 Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7WL Birmingham
    6502
    England
    EnglandBritish336149170001
    JACKSON, Vanessa
    Manor Mill Lane
    LS11 8BR Leeds
    Sulzer (Uk) Holdings
    United Kingdom
    Amministratore
    Manor Mill Lane
    LS11 8BR Leeds
    Sulzer (Uk) Holdings
    United Kingdom
    United KingdomBritish327078770001
    BROWN, Charles Nicholas
    Stoneyards Farm
    Menie By Balmedie
    AB41 0YJ Aberdeen
    Grampian
    Segretario
    Stoneyards Farm
    Menie By Balmedie
    AB41 0YJ Aberdeen
    Grampian
    British36752260001
    BROWN, Robert Muirhead Birnie
    c/o Wood Group
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    Segretario
    c/o Wood Group
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    153996880001
    GOOD, Graham
    22 Gladstone Place
    AB10 6XA Aberdeen
    Segretario
    22 Gladstone Place
    AB10 6XA Aberdeen
    British57781370001
    JOHNSON, Ian
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos
    AB12 3AX Aberdeen
    Segretario
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos
    AB12 3AX Aberdeen
    British102664100004
    JONES, Iain Angus
    Castle Road Industrial Estate
    AB41 9RF Ellon
    .
    Aberdeenshire
    Scotland
    Segretario
    Castle Road Industrial Estate
    AB41 9RF Ellon
    .
    Aberdeenshire
    Scotland
    204011970001
    MIDDLETON, Sandra Elizabeth
    Investment House 6 Union Row
    AB9 8DQ Aberdeen
    Segretario nominato
    Investment House 6 Union Row
    AB9 8DQ Aberdeen
    British900000270001
    WATSON, Christopher Edward Milne
    77 Fountainhall Road
    AB15 4EA Aberdeen
    Segretario
    77 Fountainhall Road
    AB15 4EA Aberdeen
    British60315030001
    ANGUS, Grant Rae
    c/o Wood Group
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    Amministratore
    c/o Wood Group
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    ScotlandBritish197743170001
    BAILLIE, David Charles
    Birchbank
    AB51 5JU Burnhervie
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Birchbank
    AB51 5JU Burnhervie
    Aberdeenshire
    Great BritainBritish89636000001
    BRADWELL, Garth Jeffrey
    5 Nightingale Croft
    Thorpe Hesley
    S61 2UB Rotherham
    South Yorkshire
    Amministratore
    5 Nightingale Croft
    Thorpe Hesley
    S61 2UB Rotherham
    South Yorkshire
    British66587570001
    BROADLEY, Stuart Richard
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos
    AB12 3AX Aberdeen
    Amministratore
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos
    AB12 3AX Aberdeen
    ScotlandBritish96818620001
    CARR, William Hadden
    Collieston Hall
    AB41 8RS Collieston
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Collieston Hall
    AB41 8RS Collieston
    Aberdeenshire
    British100270001
    CRAWFORD, James Duncan
    c/o Wood Group
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    Amministratore
    c/o Wood Group
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    ScotlandBritish169953750001
    DAVENPORT, John Rowland
    Castle Street
    Castlepark Industrial Estate
    AB41 9RF Ellon
    Formartine House
    Scotland
    Amministratore
    Castle Street
    Castlepark Industrial Estate
    AB41 9RF Ellon
    Formartine House
    Scotland
    EnglandBritish291715640001
    DEWITZ, Philippe Andreas
    Castle Street
    Castlepark Industrial Estate
    AB41 9RF Ellon
    Formartine House
    Scotland
    Amministratore
    Castle Street
    Castlepark Industrial Estate
    AB41 9RF Ellon
    Formartine House
    Scotland
    SwitzerlandSwiss217097980001
    DICKIE, Graham
    12 Northburn Avenue
    AB15 6AH Aberdeen
    Amministratore
    12 Northburn Avenue
    AB15 6AH Aberdeen
    British121618900001
    DOWLE, Keith
    10 Smithies Lane
    S75 1BH Barnsley
    South Yorkshire
    Amministratore
    10 Smithies Lane
    S75 1BH Barnsley
    South Yorkshire
    United KingdomBritish65271810001
    DRON, Alexander
    Villafield
    Elrick
    AB32 6TJ Westhill
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Villafield
    Elrick
    AB32 6TJ Westhill
    Aberdeenshire
    British63998700002
    EDGAR, William
    3 Cairnie View
    Westhill
    AB32 6NB Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    3 Cairnie View
    Westhill
    AB32 6NB Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish109447840001
    GILCHRIST, Thomas Armstrong
    c/o Wood Group
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Amministratore
    c/o Wood Group
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    ScotlandBritish240837940001
    HALL, Stuart
    Newlyn Huntly Road
    AB34 5HE Aboyne
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Newlyn Huntly Road
    AB34 5HE Aboyne
    Aberdeenshire
    British37727490001
    HODGSON, Andrew
    The Poplars
    Church Lane Averham
    NG23 5RB Newark
    Nottinghamshire
    Amministratore
    The Poplars
    Church Lane Averham
    NG23 5RB Newark
    Nottinghamshire
    British109391270001
    JESSIMAN, Scott
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos
    AB12 3AX Aberdeen
    Amministratore
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos
    AB12 3AX Aberdeen
    ScotlandBritish181632620001
    JOHNSTONE, Alan James
    c/o Wood Group
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Amministratore
    c/o Wood Group
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    ScotlandBritish108475490001
    JONES, Wayne
    4 Highbury Road
    Heaton Chapel
    SK4 5AZ Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    4 Highbury Road
    Heaton Chapel
    SK4 5AZ Stockport
    Cheshire
    British98176940001
    JUKES, Robert Arthur
    46 Springwater Avenue
    Holcombe Brook
    BL0 9TX Bury
    Lancashire
    Amministratore
    46 Springwater Avenue
    Holcombe Brook
    BL0 9TX Bury
    Lancashire
    British41727360001
    LANGLANDS, Allister Gordon
    Craigentoul
    16 Hillhead Road, Bieldside
    AB15 9EJ Aberdeen
    Amministratore
    Craigentoul
    16 Hillhead Road, Bieldside
    AB15 9EJ Aberdeen
    ScotlandBritish34145910003
    LITTLE, John
    6 Riverside Park
    Port Elphinstone
    AB51 3SB Inverurie
    Aberdeenshire
    Amministratore
    6 Riverside Park
    Port Elphinstone
    AB51 3SB Inverurie
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish106011130001
    MCNIVEN, Alan Ross
    Investment House 6 Union Row
    AB9 8DQ Aberdeen
    Amministratore delegato nominato
    Investment House 6 Union Row
    AB9 8DQ Aberdeen
    British900000280001
    MURRAY, Iain
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos
    AB12 3AX Aberdeen
    Amministratore
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos
    AB12 3AX Aberdeen
    UsaBritish155887240001
    NADKARNI, Subodh Satchitanand
    Castle Street
    Castlepark Industrial Estate
    AB41 9RF Ellon
    Sulzer Wood Limited
    Aberdeenshire
    Scotland
    Amministratore
    Castle Street
    Castlepark Industrial Estate
    AB41 9RF Ellon
    Sulzer Wood Limited
    Aberdeenshire
    Scotland
    NetherlandsIndian183995950001
    NICOL, Stephen James
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos
    AB12 3AX Aberdeen
    Amministratore
    John Wood House, Greenwell Road
    East Tullos
    AB12 3AX Aberdeen
    ScotlandBritish162632260012

    Chi sono le persone con controllo significativo di SULZER (ABERDEEN) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Wood Group Engineering & Operations Support Limited
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    06 apr 2016
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleScotland
    Luogo di registrazioneRegistrar Of Companies (Scotland)
    Numero di registrazioneSc159149
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    Sulzer (Uk) Holdings Limited
    Manor Mill Lane
    LS11 8BR Leeds
    Manor Mill Lane
    West Yorkshire
    England
    06 apr 2016
    Manor Mill Lane
    LS11 8BR Leeds
    Manor Mill Lane
    West Yorkshire
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEngland
    Luogo di registrazioneRegistrar Of Companies (England)
    Numero di registrazione03347095
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% ma non più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 50% ma non più del 75% dei diritti di voto nella società.

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0